WHITWORTHS GROUP LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | WHITWORTHS GROUP LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04131087 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von WHITWORTHS GROUP LIMITED?
- Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln a.n.g. (10890) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich WHITWORTHS GROUP LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O Fti Consulting Llp 200 Aldersgate Street EC1A 4HD London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von WHITWORTHS GROUP LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| SECKLOE 58 LIMITED | 27. Dez. 2000 | 27. Dez. 2000 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WHITWORTHS GROUP LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 02. Mai 2015 |
Welche sind die letzten Einreichungen für WHITWORTHS GROUP LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 17 Seiten | LIQ14 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stuart Jonathan Lowe als Geschäftsführer am 23. Apr. 2018 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Orchard House, Irthlingborough Wellingborough Northamptonshire NN9 5DB zum C/O Fti Consulting Llp 200 Aldersgate Street London EC1A 4HD am 08. Aug. 2017 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Vermögensübersicht | 10 Seiten | LIQ02 | ||||||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Apr. 2016 bis 31. Okt. 2016 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 27. Dez. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Stuart Jonathan Lowe als Direktor am 18. Jan. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Peter Dylan Unsworth als Geschäftsführer am 26. Jan. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Peter Andrew Utting als Geschäftsführer am 11. Nov. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mark Fairweather als Direktor am 23. Dez. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 02. Mai 2015 | 15 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 27. Dez. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 03. Mai 2014 | 13 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 27. Dez. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Peter Andrew Utting am 16. Aug. 2013 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Colin Stephens als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 27. Dez. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 27. Apr. 2013 | 14 Seiten | AA | ||||||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom C/O Emw Seebeck House 1 Seebeck Place, Knowlhill Milton Keynes Buckinghamshire MK5 8FR United Kingdom geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||||||
Ernennung von Peter Dylan Unsworth als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Eintragung der Belastung 041310870006 | 35 Seiten | MR01 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 37 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von WHITWORTHS GROUP LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JARMAN, Daniel | Sekretär | Wellingborough Road NN9 5DB Irthlingborough Orchard House Nothamptonshire United Kingdom | 165072640001 | |||||||
| FAIRWEATHER, Mark Robert | Geschäftsführer | 200 Aldersgate Street EC1A 4HD London C/O Fti Consulting Llp | England | British | 208083400001 | |||||
| CHAMBERS, Christopher James | Sekretär | Irthlingborough NN9 5DB Wellingborough Orchard House Northamptonshire United Kingdom | 147427370001 | |||||||
| OAKLEY, Christopher Richard | Sekretär | 26 Long Park Chesham Bois HP6 5LA Amersham Buckinghamshire | British | 124625030001 | ||||||
| PARTRIDGE, Charles Edward | Sekretär | 24 Ashpole Spinney NN4 9QB Northampton | British | 77450510002 | ||||||
| ASHCROFT CAMERON SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 4 Rivers House Fentiman Walk SG14 1DB Hertford Hertfordshire | 900004530001 | |||||||
| EMW SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Seckloe House 101 North 13th Street MK9 3NX Central Milton Keynes Buckinghamshire | 93910510001 | |||||||
| ANDREW, Vincent Leo | Geschäftsführer | Copperfields 1 Hamlet Green, Dallington NN5 7AR Northampton | United Kingdom | British | 116947660003 | |||||
| BARBOUR SMITH, James Kenneth Alexander | Geschäftsführer | The Square House Latchmoor Grove SL9 8LN Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 80175630001 | ||||||
| CARTER, Michael William | Geschäftsführer | Vine Cottage Pinfold Lane RG8 8SH Ashampstead Berkshire | British | 114525240001 | ||||||
| CASLIN, James | Geschäftsführer | 43 Rolleston Drive CH45 6XE Wallasey Merseyside | British | 116947340001 | ||||||
| CHAMBERS, Christopher James | Geschäftsführer | Irthlingborough NN9 5DB Wellingborough Orchard House Northamptonshire United Kingdom | United Kingdom | British | 147427330001 | |||||
| INCHLEY, Simon Nicholas | Geschäftsführer | The Farmhouse, Top Yard Farm Burnmill Road, Great Bowden LE16 7JB Market Harborough Leicestershire | England | British | 64345880002 | |||||
| LOWE, Stuart Jonathan | Geschäftsführer | 200 Aldersgate Street EC1A 4HD London C/O Fti Consulting Llp | United Kingdom | British | 30980880002 | |||||
| NAYLOR, Peter David | Geschäftsführer | 31 Barlows Road Harborne B15 2PN Birmingham | British | 73589160004 | ||||||
| OAKLEY, Christopher Richard | Geschäftsführer | 26 Long Park Chesham Bois HP6 5LA Amersham Buckinghamshire | England | British | 124625030001 | |||||
| PARTRIDGE, Charles Edward | Geschäftsführer | 24 Ashpole Spinney NN4 9QB Northampton | United Kingdom | British | 77450510002 | |||||
| PRATT, David Andrew | Geschäftsführer | The Former Vicarage 41 Main Street CB5 9AB Stow Cum Quy Cambridgeshire | British | 61204820002 | ||||||
| ROME, Martin Leslie | Geschäftsführer | 3 Lowswood Close HA6 2XE Northwood Middlesex | England | British | 56407850003 | |||||
| SHEARS, Tim | Geschäftsführer | The Dog House 12 Dawson Court, Station Road LE15 6SD Oakham Rutland | British | 116796720002 | ||||||
| SMITH, David Jervis | Geschäftsführer | 22 Audley Close LE16 8ER Market Harborough Leicestershire | United Kingdom | British | 116796520002 | |||||
| STEPHENS, Colin Alan | Geschäftsführer | Orchard Road SL4 2RZ Old Windsor 12c Berkshire England | United Kingdom | British | 129694970001 | |||||
| UNSWORTH, Peter Dylan | Geschäftsführer | Irthlingborough NN9 5DB Wellingborough Orchard House Northamptonshire United Kingdom | England | British | 32904400004 | |||||
| UTTING, Peter Andrew | Geschäftsführer | Orchard House, Irthlingborough Wellingborough NN9 5DB Northamptonshire | United Kingdom | British | 129694830001 | |||||
| VICARY, Gary Kevin | Geschäftsführer | Desborough Manorial Road Parkgate CH64 6QN Neston Wirral | British | 18943850005 | ||||||
| WOODHEAD, Ian | Geschäftsführer | Manor House Church Lane, Brigsley DN37 0RH Grimsby South Humberside | England | British | 73390240001 | |||||
| ASHCROFT CAMERON NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 4 Rivers House Fentiman Walk SG14 1DB Hertford Hertfordshire | 900004520001 | |||||||
| EMW DIRECTORS LIMITED | Geschäftsführer | Seckloe House 101 North 13th Street MK9 3NX Central Milton Keynes Buckinghamshire | 97336730001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei WHITWORTHS GROUP LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seckloe 260 Limited | 06. Apr. 2016 | Irthlingborough NN9 5DB Wellingborough Orchard House Northamptonshire England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat WHITWORTHS GROUP LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 10. Sept. 2013 Geliefert am 24. Sept. 2013 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Trade marks tm number UK00002383797 jurisdiction UK, tm number 164539 jurisdiction turkey see image for full details. Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An omnibus letter of set-off | Erstellt am 01. Nov. 2007 Geliefert am 02. Nov. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of accession to a debenture dated 26 january 2007 and | Erstellt am 26. Jan. 2007 Geliefert am 02. Feb. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each chargor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of accession | Erstellt am 30. Okt. 2006 Geliefert am 15. Nov. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage of life and total and permanent disability policies | Erstellt am 10. Apr. 2001 Geliefert am 18. Apr. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The life and total permanent disability policies in respect of gary vicary and david pratt. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 10. Apr. 2001 Geliefert am 18. Apr. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat WHITWORTHS GROUP LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0