RMAC 2001-NS1 PLC
Überblick
Unternehmensname | RMAC 2001-NS1 PLC |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Aktiengesellschaft |
Unternehmensnummer | 04133589 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von RMAC 2001-NS1 PLC?
- Finanzintermediation sonst. n.n.a. (64999) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Wo befindet sich RMAC 2001-NS1 PLC?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 5 Arlington Square Downshire Way RG12 1WA Bracknell Berkshire United Kingdom |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von RMAC 2001-NS1 PLC?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für RMAC 2001-NS1 PLC?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 29. Dez. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Heol Ygamlas Parc Nantgarw Treforest Cardiff South Glamorgan CF15 7QU am 01. Juni 2011 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 29. Dez. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift verlegt | 1 Seiten | AD04 | ||||||||||
Ernennung von Sfm Corporate Services Limited als Sekretär | 2 Seiten | AP04 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Phillip Simpson als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 5 Arlington Square Downshire Way Bracknell Berkshire RG12 1WA am 20. Aug. 2010 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 29. Dez. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Sfm Directors Limited am 25. Jan. 2010 | 2 Seiten | CH02 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Sfm Directors (No.2) Limited am 25. Jan. 2010 | 2 Seiten | CH02 | ||||||||||
Ernennung von Vinoy Nursiah als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jefrey Lundgren als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von RMAC 2001-NS1 PLC?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM CORPORATE SERVICES LIMITED | Sekretär | Great St. Helen's EC3A 6AP London 35 United Kingdom |
| 70578490002 | ||||||||||
NURSIAH, Vinoy Rajanah | Geschäftsführer | Arlington Square Downshire Way RG12 1WA Bracknell 5 Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director Of Client Accounting & Finance | 165402030001 | ||||||||
SFM DIRECTORS (NO.2) LIMITED | Geschäftsführer | Great St Helen's EC3A 6AP London 35 |
| 71663610002 | ||||||||||
SFM DIRECTORS LIMITED | Geschäftsführer | Great St Helen's EC3A 6AP London 35 |
| 69353890002 | ||||||||||
EDMONDS, Karen Britt | Sekretär | Badgers Barn Farthings Paddock BA7 7QA Alford Somerset | British | 42484650004 | ||||||||||
HAMZEHPOUR, Tammy | Sekretär | 7816 Bush Lake Drive Bloomington Minnesota Mn 55438 Usa | American | Joint Secretary | 64501790002 | |||||||||
SIMPSON, Phillip Bertram | Sekretär | 16 Gatscombe Crescent Hanover Park SL5 7HA Ascot | British | Solicitor | 54705580002 | |||||||||
ACHESON, William Brian | Geschäftsführer | Eastern Gate Brants Bridge RG12 9BZ Bracknell Berkshire | American | Director | 100315920003 | |||||||||
BRADLEY, Colin Walter | Geschäftsführer | Williamsgate The Street RG27 0PJ Eversley Hampshire | British | Finance Director | 70001440003 | |||||||||
DUGGLEBY, Colin | Geschäftsführer | Red Cottages Pilcot Hill RG27 8SZ Dogmersfield Hampshire | British | Director | 69027230001 | |||||||||
HIGGINS, Christopher James | Geschäftsführer | 24 Ennismore Avenue GU1 1SR Guildford Surrey | British | Finance Director | 115417740001 | |||||||||
LUNDGREN, Jefrey Andrew | Geschäftsführer | Arlington Square Downshire Way RG12 1WA Bracknell 5 Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 130391340002 | ||||||||
NORDEEN, Christopher Jon | Geschäftsführer | The Turnberry 8 Sheridan Grange Broomhall Lane SL5 0BX Sunningdale Berkshire | Usa | Director | 61535870001 |
Hat RMAC 2001-NS1 PLC Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Deed of amendment | Erstellt am 30. Sept. 2005 Geliefert am 17. Okt. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the issuer to the trustee and/or any receiver and to ambac and to each of the other secured creditors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first fixed security with full title guarantee all right title interest and benefit in the english mortgage loans and the english mortgages in the mortgage pool and the title deeds and documents relating to the property in england and wales. All right tiel and interest in the scottish trust property, the northern irish mortgage loans, the charged obligation documents, floating chargeall undertaking property and assets present and future,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Assignation in security (incorporating intimation thereof) by the company in favour of the trustee (the "charge") | Erstellt am 01. Mai 2001 Geliefert am 18. Mai 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies and liabilities whatsoever which from time to time become due owing or payable by the company (I) to the order of the trustee and/ or any receiver under the deed of charge the trust deed or the conditions at the times and in the manner provided therein (ii) under or in respect of the notes (iii) to ambac under the premium letter or the insurance and indemnity agreement and (iv) to the trustee under the transaction documents whether as principal or surety and whether or not directly with another (all terms as defined) | |
Kurze Angaben The companys whole right title and interest in and to the beneficial interest in the additional scottish trust property being the scottish mortgage loans and the scottish mortgages relative thereto as defined in the supplemental declaration made in favour of the company in terms of clause 5.10 of the mortgage sale agreement and in and to the supplemental declaration. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of charge and assignment between the issuer, the chargee (the trustee) ,gmac-rfc limited (the administrator), gmac-rfc limited (the seller), chase manhattan bank (the principal paying agent and agent bank), chase manhattan bank luxembourg, S.A.(the paying agent), barclays bank PLC (the account bank, the liquidity provider and the gic provider), and others | Erstellt am 28. März 2001 Geliefert am 04. Apr. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies and liabilities whatsoever which from time to time become due owing or payable by the company (I) to the order of the trustee and/ or any receiver under this deed of charge the trust deed or the conditions at the times and in the manner provided therein (ii) under or in respect of the notes (iii) to ambac under the premium letter and the insurance and indemnity agreement and (iv) to the trustee under the transaction documents whether as principal or surety and whether or directly with another | |
Kurze Angaben All right title interest and benefit to and under the english mortgage loans and the english mortgages in the mortgage pooland all monies assured by or to become payable under the same. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0