FINCO CS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | FINCO CS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04134744 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von FINCO CS LIMITED?
- Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich FINCO CS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | c/o LUCID ISSUER SERVICES LIMITED Tankerton Works 12 Argyle Walk WC1H 8HA London England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von FINCO CS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| DAMOVO CORPORATE SERVICES LIMITED | 15. März 2002 | 15. März 2002 |
| DAMOVO UK FINANCE I LIMITED | 06. Sept. 2001 | 06. Sept. 2001 |
| ENTERPRISE SOLUTIONS UK FINANCE I LIMITED | 29. März 2001 | 29. März 2001 |
| DAMSONDALE LIMITED | 03. Jan. 2001 | 03. Jan. 2001 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FINCO CS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Jan. 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für FINCO CS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Jan. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Jan. 2017 | 44 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Jan. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Jan. 2016 | 53 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Jan. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Jan. 2015 | 57 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Lucid Issuer Services Limited Leroy House 436 Essex Road London N1 3QP zum C/O Lucid Issuer Services Limited Tankerton Works 12 Argyle Walk London WC1H 8HA am 25. Nov. 2015 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed damovo corporate services LIMITED\certificate issued on 02/04/15 | 3 Seiten | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Jan. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Salim Sarwar Alam als Sekretär am 26. Feb. 2015 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Robert Graham Hynd als Sekretär am 26. Feb. 2015 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Jan. 2014 | 28 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Salim Alam als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Jan. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Jan. 2013 | 29 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Jan. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Jan. 2012 | 30 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Jan. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Jan. 2011 | 28 Seiten | AA | ||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 7 Seiten | MEM/ARTS | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von FINCO CS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALAM, Salim Sarwar | Sekretär | Speldhurst Road W4 1BZ London 44 England | 195535740001 | |||||||
| MCCUSKER, Helen Bernadette | Geschäftsführer | Calabar Court Cathkin G73 5RL Glasgow 9 Scotland | Scotland | British | 158086570001 | |||||
| BOOTH, Rachel Sarah | Sekretär | 91 Harrison Road EH11 1LS Edinburgh | British | 43448790001 | ||||||
| HYND, Robert Graham | Sekretär | Dunglass Avenue G14 9ED Glasgow 27 Scotland | British | 31887890001 | ||||||
| MCMELLON, Christopher John | Sekretär | 12 Grovehill Crescent TR11 3HR Falmouth Cornwall | British | 43249730003 | ||||||
| CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 10 Upper Bank Street E14 5JJ London | 38508390004 | |||||||
| MASONS SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Sekretär | 30 Aylesbury Street EC1R 0ER London | 32643220001 | |||||||
| PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED | Sekretär | 1 Park Row LS1 5AB Leeds West Yorkshire | 76579530001 | |||||||
| ALAM, Salim Sarwar | Geschäftsführer | 44 Speldhurst Road W4 1BZ London | England | British | 122506270001 | |||||
| BISSETT, Graeme | Geschäftsführer | 123 Saint Vincent Street G2 5EA Glasgow | British | 79800380001 | ||||||
| BOOTH, Rachel Sarah | Geschäftsführer | 123 St Vincent Street G2 5EA Glasgow | British | 79930170001 | ||||||
| BOYLE, Joseph Anthony | Geschäftsführer | 12 Huntly Avenue G46 6LW Glasgow | Scotland | British | 96947560001 | |||||
| COLLINS, Michael David | Geschäftsführer | 2 Alexandra House Queenshill Close London Road SL5 7EQ Ascot Berkshire | United Kingdom | British | 122053370001 | |||||
| CONTRERAS, Robert Leonard | Geschäftsführer | 9 Thorp Arch Park LS23 7AP Wetherby West Yorkshire | United Kingdom | British | 93499270001 | |||||
| FITZGERALD, David James | Geschäftsführer | 55 Ridgway Place SW19 4SP London | England | Irish | 141363290001 | |||||
| FITZGERALD, David James | Geschäftsführer | Beechwood House RH12 4SD Faygate West Sussex | Irish | 75198210003 | ||||||
| FLYNN, Pearse | Geschäftsführer | Greystones Houston Road PA13 4NY Kilmacolm Renfrewshire | Irish | 75749140001 | ||||||
| LAYTON, Matthew Robert | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Flat 49 8 New Crane Wharf New Crane Place E1W 3TX London | British | 900019870001 | ||||||
| MCCUSKER, Helen Bernadette | Geschäftsführer | 2-42 Glasgow Road FG71 7BA Uddingston Glasgow Glasgow | British | 126380710001 | ||||||
| RICHARDS, Martin Edgar | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 89 Thurleigh Road SW12 8TY London | British | 900002870001 | ||||||
| SAMUEL, John | Geschäftsführer | Little Quebb Farm Eardisley HR3 6LP Hereford | British | 92480690001 | ||||||
| SLOAN, Michael Robert William, Mr. | Geschäftsführer | Kingsford Avenue G44 3EU Glasgow 43 | United Kingdom | British | 138578730001 | |||||
| STATHOPOULOS, Nikolaos | Geschäftsführer | Flat B 6 Redcliffe Place SW10 9DD London | Greek | 75198270001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei FINCO CS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finco Ii Sarl | 06. Apr. 2016 | Boulevard Royal L-2449 25a Luxembourg | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat FINCO CS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 11. Jan. 2007 Geliefert am 25. Jan. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any obligor to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An equitable mortgage | Erstellt am 22. Apr. 2005 Geliefert am 29. Apr. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the issuer and each guarantor to the secured creditors (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed charge the mortgaged assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Equitable mortgage of shares | Erstellt am 18. März 2005 Geliefert am 23. März 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any obligor to the secured creditors (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The mortgaged assets being the mortgaged shares and the related assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 11. Juni 2004 Geliefert am 30. Juni 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any obligor to the lenders (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 14. Mai 2004 Geliefert am 20. Mai 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any obligor to the secured creditors (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment by way of security of intercompany loans | Erstellt am 04. Mai 2001 Geliefert am 19. Mai 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally and whether as principal or surety or in any capacity whatsoever) of the assignor or any obligor to the secured creditors (or any of them) under or in relation to any one or more of the senior finance documents and/or the mezzanine finance documents all terms as defined | |
Kurze Angaben All the right title and interest present and future of the assignor in,to and under the intergroup loans together with all claims rights and remedies of the assignor and sums due to it in respect thereof. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Equitable mortgage of shares | Erstellt am 04. Mai 2001 Geliefert am 19. Mai 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally and whether as principal or surety or in any capacity whatsoever) of the company or any obligor to the secured creditors (or any of them) under or in relation to any one or more of the senior finance documents and/or the mezzanine finance documents all terms as defined | |
Kurze Angaben The company charges with full title guarantee the mortgaged assets being the mortgaged shares and the related assets and all other shares held in the future by it and/or any nominee on its behalf to the security agent by way of first fixed charge. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0