METRO NOMINEES (VICTORIA PLACE) LIMITED

METRO NOMINEES (VICTORIA PLACE) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMETRO NOMINEES (VICTORIA PLACE) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04139141
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von METRO NOMINEES (VICTORIA PLACE) LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen

    Wo befindet sich METRO NOMINEES (VICTORIA PLACE) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    100 Victoria Street
    SW1E 5JL London
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von METRO NOMINEES (VICTORIA PLACE) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    DELANCEY VICTORIA PLACE UK LIMITED25. Jan. 200125. Jan. 2001
    SPECIALITY SHOPS VICTORIA UK LIMITED23. Jan. 200123. Jan. 2001
    DELANCEY FIFTY FIVE LIMITED11. Jan. 200111. Jan. 2001

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von METRO NOMINEES (VICTORIA PLACE) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2017

    Welche sind die letzten Einreichungen für METRO NOMINEES (VICTORIA PLACE) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Application for strike off 19/09/2017
    RES13

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2017

    4 SeitenAA

    Ernennung von Ls Director Limited als Direktor am 02. Feb. 2017

    2 SeitenAP02

    Beendigung der Bestellung von Timothy Haden Scott als Geschäftsführer am 02. Feb. 2017

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Land Securities Management Services Limited als Direktor am 02. Feb. 2017

    2 SeitenAP02

    Ernennung von Mr Martin Richard Worthington als Direktor am 02. Feb. 2017

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Scott Cameron Parsons als Geschäftsführer am 02. Feb. 2017

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Paul Jonathan Goswell als Geschäftsführer am 02. Feb. 2017

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Despina Don-Wauchope als Geschäftsführer am 02. Feb. 2017

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Ailish Martina Christian-West als Geschäftsführer am 02. Feb. 2017

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 13. Jan. 2017 mit Aktualisierungen

    6 SeitenCS01

    Änderung der Details des Direktors für Ailish Martina Christian West am 12. Jan. 2017

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mrs Despina Don-Wauchope am 11. Jan. 2017

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Scott Cameron Parsons am 10. Jan. 2017

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Ls Company Secretaries Limited am 10. Jan. 2017

    1 SeitenCH04

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 5 Strand London WC2N 5AF zum 100 Victoria Street London SW1E 5JL am 10. Jan. 2017

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2016

    4 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Jan. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    8 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital27. Jan. 2016

    Kapitalaufstellung am 27. Jan. 2016

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2015

    4 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Ailish Martina Christian West am 01. Juni 2015

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Ailish Martina Christian am 24. Okt. 2014

    3 SeitenCH01

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Jan. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    8 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital28. Jan. 2015

    Kapitalaufstellung am 28. Jan. 2015

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Wer sind die Geschäftsführer von METRO NOMINEES (VICTORIA PLACE) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    LS COMPANY SECRETARIES LIMITED
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    United Kingdom
    Sekretär
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer4365193
    159674790001
    WORTHINGTON, Martin Richard
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant209653060001
    LAND SECURITIES MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer4156575
    74974580001
    LS DIRECTOR LIMITED
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer04299372
    133814600001
    DE SOUZA, Adrian Michael
    Strand
    WC2N 5AF London
    5
    United Kingdom
    Sekretär
    Strand
    WC2N 5AF London
    5
    United Kingdom
    160405730001
    DUDGEON, Peter Maxwell
    41 Links Road
    KT17 3PP Epsom
    Surrey
    Sekretär
    41 Links Road
    KT17 3PP Epsom
    Surrey
    British14674480002
    MOSS, Andrew Graham
    244 Willesden Lane
    NW2 5RE London
    Sekretär
    244 Willesden Lane
    NW2 5RE London
    BritishChartered Accountant4573140002
    PORTMAN ADMINISTRATION 1 LIMITED
    40 Portman Square
    W1H 0AA London
    Sekretär
    40 Portman Square
    W1H 0AA London
    93189540001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Bevollmächtigter Sekretär
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    AKERS, Richard John
    Strand
    WC2N 5AF London
    5
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Strand
    WC2N 5AF London
    5
    United Kingdom
    United KingdomEnglishChartered Surveyor73246590001
    ASHTON, Mark Arthur
    Oakfield
    Hollycombe Close
    GU30 7HR Liphook
    Hants
    Geschäftsführer
    Oakfield
    Hollycombe Close
    GU30 7HR Liphook
    Hants
    United KingdomBritishChartered Surveyor110886440001
    BLAKE, Ashley Peter
    Strand
    WC2N 5AF London
    5
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Strand
    WC2N 5AF London
    5
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Surveyor83319540002
    CHRISTIAN-WEST, Ailish Martina
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    United Kingdom
    United KingdomIrishChartered Surveyor139461680005
    DE BARR, Robert Henry
    Watermark Thames Lawn
    St Peter Street
    SL7 1QA Marlow
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Watermark Thames Lawn
    St Peter Street
    SL7 1QA Marlow
    Buckinghamshire
    EnglandBritishChartered Surveyor14885390006
    DON-WAUCHOPE, Despina
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant172870040001
    EMMETT, Graham Anthony Johnathan
    Rushmead
    Leigh Place
    KT11 2HL Cobham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Rushmead
    Leigh Place
    KT11 2HL Cobham
    Surrey
    BritishFinance Dir66041940002
    GOSWELL, Paul Jonathan
    Mulberry Lodge
    Mill Hill Barnes
    SW13 0HS London
    Geschäftsführer
    Mulberry Lodge
    Mill Hill Barnes
    SW13 0HS London
    United KingdomBritishSurveyor60475780002
    GOSWELL, Paul Jonathan
    Mulberry Lodge
    Mill Hill Barnes
    SW13 0HS London
    Geschäftsführer
    Mulberry Lodge
    Mill Hill Barnes
    SW13 0HS London
    United KingdomBritishSurveyor60475780002
    HADEN SCOTT, Timothy
    17 Woodcote Lane
    CR8 3HB Purley
    Surrey
    Geschäftsführer
    17 Woodcote Lane
    CR8 3HB Purley
    Surrey
    United KingdomBritishProperty Developer112246680001
    HADEN SCOTT, Timothy
    6 Russell Hill
    CR8 2JA Purley
    Surrey
    Geschäftsführer
    6 Russell Hill
    CR8 2JA Purley
    Surrey
    BritishProperty Investment63220740001
    LANCASTER, Anna Louise
    3 Manor Mansions
    Belzise Grove
    NW3 4NB London
    Geschäftsführer
    3 Manor Mansions
    Belzise Grove
    NW3 4NB London
    BritishChartered Surveyor100215320002
    LEUNG, Stephen Sui Sang
    West Barn Elses Farm
    Morleys Road
    TN14 6QX Sevenoaks Weald
    Kent
    Geschäftsführer
    West Barn Elses Farm
    Morleys Road
    TN14 6QX Sevenoaks Weald
    Kent
    United KingdomBritishChartered Accountant196161690001
    MARTIN, Herbert William
    Disraeli Road
    Putney
    SW15 2DS London
    64
    Geschäftsführer
    Disraeli Road
    Putney
    SW15 2DS London
    64
    United KingdomBritishDevelopment Director131189890001
    MOSS, Andrew Graham
    244 Willesden Lane
    NW2 5RE London
    Geschäftsführer
    244 Willesden Lane
    NW2 5RE London
    United KingdomBritishChartered Accountant4573140002
    PARSONS, Scott Cameron
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    United Kingdom
    EnglandCanadianProperty Director111671230001
    PARSONS, Scott Cameron
    82 Chelverton Road
    Putney
    SW15 1RL London
    Geschäftsführer
    82 Chelverton Road
    Putney
    SW15 1RL London
    BritishBusiness Dev Director98187650001
    RITBLAT, James William Jeremy
    24 St Petersburgh Place
    W2 4LB London
    Geschäftsführer
    24 St Petersburgh Place
    W2 4LB London
    EnglandBritishCompany Director38424950003
    WAGMAN, Colin Barry
    North Lodge
    25 Ringwood Avenue
    N2 9NT London
    Geschäftsführer
    North Lodge
    25 Ringwood Avenue
    N2 9NT London
    United KingdomBritishConsultant39329840001
    LAND SECURITIES MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    5 Strand
    WC2N 5AF London
    Geschäftsführer
    5 Strand
    WC2N 5AF London
    74974580001
    PORTMAN ADMINISTRATION 1 LIMITED
    40 Portman Square
    W1H 0AA London
    Geschäftsführer
    40 Portman Square
    W1H 0AA London
    93189540001
    PORTMAN ADMINISTRATION 2 LIMITED
    6th Floor Lansdowne House
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    Geschäftsführer
    6th Floor Lansdowne House
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    88224330004
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei METRO NOMINEES (VICTORIA PLACE) LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (England)
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer3874007
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat METRO NOMINEES (VICTORIA PLACE) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 20. Okt. 2006
    Geliefert am 31. Okt. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee or to the other finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H property k/a victoria place shopping centre victoria station london t/no NGL679829 and NGL830995. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 31. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Okt. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 09. Juli 2004
    Geliefert am 19. Juli 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee (whether on its own account or on behalf of any of the security beneficiaries) or to the other security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bradford & Bingley PLC
    Transaktionen
    • 19. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Okt. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 02. Juni 2004
    Geliefert am 10. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the chargor to the chargee whether on its own account or on behalf of any of the security beneficiaries or to the other security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The l/h property known as victoria place shopping centre victoria station london t/n NGL679829, the l/h property known as units 1 and 3 (also known as units 19 and 20) being the next and sainsburys units at victoria place shopping centre victoria station london t/n NGL830995. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bradford & Bingley PLC (Security Trustee)
    Transaktionen
    • 10. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Okt. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage made between (1) the first (as first chargor) (2) the speciality shops (victoria) limited ("second chargor") (as second chargor) (together the "chargors" and each a chargor") and (3) bradford & bingley PLC (as agent and trustee) ("agent")
    Erstellt am 06. März 2001
    Geliefert am 08. März 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The actual contingent present and/or future obligations and liabilities of the borrowers and/or the chargors to the agent and/or any of the lenders under or in connection with the finance documents (all terms as defined)
    Kurze Angaben
    By way of first ranking legal mortgage all estates or interests in the freehold leasehold and other immovable property including all that leasehold land and buildings being victoria place shopping centre victoria station buckingham palace road london SW1 title number NGL679829AND the proceeds of sale thereof and all buildings and trade and other fixtures on any such property belonging to the first chargor by way of first ranking fixed charge all plant machinery vehicles computers and office and other equipment owned by the first chargor both present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bradford & Bingley PLC
    Transaktionen
    • 08. März 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Okt. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0