METRO NOMINEES (CLAPHAM) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | METRO NOMINEES (CLAPHAM) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 04139144 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von METRO NOMINEES (CLAPHAM) LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
Wo befindet sich METRO NOMINEES (CLAPHAM) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Pearl Assurance House 319 Ballards Lane N12 8LY London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von METRO NOMINEES (CLAPHAM) LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
DELANCEY CLAPHAM UK LIMITED | 25. Jan. 2001 | 25. Jan. 2001 |
SPECIALITY SHOPS DEVELOPMENTS UK LIMITED | 23. Jan. 2001 | 23. Jan. 2001 |
DELANCEY FIFTY TWO LIMITED | 11. Jan. 2001 | 11. Jan. 2001 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von METRO NOMINEES (CLAPHAM) LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für METRO NOMINEES (CLAPHAM) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 10 Seiten | LIQ13 | ||||||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Aug. 2021 | 12 Seiten | LIQ03 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 1st Floor 26-28 Bedford Row London WC1R 4HE zum Pearl Assurance House 319 Ballards Lane London N12 8LY am 31. Juli 2021 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Aug. 2019 | 10 Seiten | LIQ03 | ||||||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Aug. 2018 | 11 Seiten | LIQ03 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2017 | 4 Seiten | AA | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 6th Floor, Lansdowne House Berkeley Square London W1J 6ER England zum 1st Floor 26-28 Bedford Row London WC1R 4HE am 11. Sept. 2017 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 041391440008 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul Jonathan Goswell als Geschäftsführer am 22. Juli 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 100 Victoria Street London SW1E 5JL United Kingdom zum 6th Floor, Lansdowne House Berkeley Square London W1J 6ER am 19. Mai 2017 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ls Company Secretaries Limited als Sekretär am 13. Apr. 2017 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ailish Martina Christian-West als Geschäftsführer am 13. Apr. 2017 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Despina Don-Wauchope als Geschäftsführer am 13. Apr. 2017 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Scott Cameron Parsons als Geschäftsführer am 13. Apr. 2017 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. Jan. 2017 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Ailish Martina Christian West am 12. Jan. 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mrs Despina Don-Wauchope am 11. Jan. 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Scott Cameron Parsons am 10. Jan. 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Ls Company Secretaries Limited am 10. Jan. 2017 | 1 Seiten | CH04 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 5 Strand London WC2N 5AF zum 100 Victoria Street London SW1E 5JL am 10. Jan. 2017 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von METRO NOMINEES (CLAPHAM) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HADEN SCOTT, Timothy | Geschäftsführer | 17 Woodcote Lane CR8 3HB Purley Surrey | United Kingdom | British | Property Developer | 112246680001 | ||||||||
DE SOUZA, Adrian Michael | Sekretär | Strand WC2N 5AF London 5 United Kingdom | 160405750001 | |||||||||||
DUDGEON, Peter Maxwell | Sekretär | 41 Links Road KT17 3PP Epsom Surrey | British | 14674480002 | ||||||||||
MOSS, Andrew Graham | Sekretär | 244 Willesden Lane NW2 5RE London | British | Chertered Accountant | 4573140002 | |||||||||
LS COMPANY SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Victoria Street SW1E 5JL London 100 United Kingdom |
| 159674790001 | ||||||||||
PORTMAN ADMINISTRATION 1 LIMITED | Sekretär | 40 Portman Square W1H 0AA London | 93189540001 | |||||||||||
WATERLOW SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003950001 | |||||||||||
AKERS, Richard John | Geschäftsführer | Strand WC2N 5AF London 5 United Kingdom | United Kingdom | English | Chartered Surveyor | 73246590001 | ||||||||
ASHTON, Mark Arthur | Geschäftsführer | Oakfield Hollycombe Close GU30 7HR Liphook Hants | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 110886440001 | ||||||||
BLAKE, Ashley Peter | Geschäftsführer | Strand WC2N 5AF London 5 United Kingdom | England | British | Chartered Surveyor | 83319540002 | ||||||||
CHRISTIAN-WEST, Ailish Martina | Geschäftsführer | Victoria Street SW1E 5JL London 100 United Kingdom | United Kingdom | Irish | Chartered Surveyor | 139461680005 | ||||||||
DE BARR, Robert Henry | Geschäftsführer | Watermark Thames Lawn St Peter Street SL7 1QA Marlow Buckinghamshire | England | British | Chartered Surveyor | 14885390006 | ||||||||
DON-WAUCHOPE, Despina | Geschäftsführer | Victoria Street SW1E 5JL London 100 United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 172870040001 | ||||||||
EMMETT, Graham Anthony Johnathan | Geschäftsführer | Rushmead Leigh Place KT11 2HL Cobham Surrey | British | Finance Director | 66041940002 | |||||||||
GOSWELL, Paul Jonathan | Geschäftsführer | Mulberry Lodge Mill Hill Barnes SW13 0HS London | United Kingdom | British | Surveyor | 60475780002 | ||||||||
GOSWELL, Paul Jonathan | Geschäftsführer | Mulberry Lodge Mill Hill Barnes SW13 0HS London | United Kingdom | British | Surveyor | 60475780002 | ||||||||
HADEN SCOTT, Timothy | Geschäftsführer | 6 Russell Hill CR8 2JA Purley Surrey | British | Property Investment | 63220740001 | |||||||||
LANCASTER, Anna Louise | Geschäftsführer | 3 Manor Mansions Belzise Grove NW3 4NB London | British | Chartered Surveyor | 100215320002 | |||||||||
LEUNG, Stephen Sui Sang | Geschäftsführer | West Barn Elses Farm Morleys Road TN14 6QX Sevenoaks Weald Kent | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 196161690001 | ||||||||
MARTIN, Herbert William | Geschäftsführer | Disraeli Road Putney SW15 2DS London 64 | United Kingdom | British | Development Director | 131189890001 | ||||||||
MOSS, Andrew Graham | Geschäftsführer | 244 Willesden Lane NW2 5RE London | United Kingdom | British | Chertered Accountant | 4573140002 | ||||||||
PARSONS, Scott Cameron | Geschäftsführer | Victoria Street SW1E 5JL London 100 United Kingdom | England | Canadian | Property Director | 111671230001 | ||||||||
PARSONS, Scott Cameron | Geschäftsführer | 82 Chelverton Road Putney SW15 1RL London | British | Business Dev Director | 98187650001 | |||||||||
RITBLAT, James William Jeremy | Geschäftsführer | 24 St Petersburgh Place W2 4LB London | England | British | Director | 38424950003 | ||||||||
WAGMAN, Colin Barry | Geschäftsführer | North Lodge 25 Ringwood Avenue N2 9NT London | United Kingdom | British | Consultant | 39329840001 | ||||||||
LAND SECURITIES MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Geschäftsführer | 5 Strand WC2N 5AF London | 74974580001 | |||||||||||
PORTMAN ADMINISTRATION 1 LIMITED | Geschäftsführer | 40 Portman Square W1H 0AA London | 93189540001 | |||||||||||
PORTMAN ADMINISTRATION 2 LIMITED | Geschäftsführer | 40 Portman Square W1H 0AA London | 88224330002 | |||||||||||
WATERLOW NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003940001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei METRO NOMINEES (CLAPHAM) LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land Securities Partnerships Limited | 06. Apr. 2016 | Victoria Street SW1E 5JL London 100 | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat METRO NOMINEES (CLAPHAM) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 09. Sept. 2014 Geliefert am 24. Sept. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung L/H property k/a unit 1, st john's hill clapham london. Belastungsgrundlage als Bare Trust: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security agreement | Erstellt am 09. Dez. 2011 Geliefert am 14. Dez. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben For details of property charged please refer to form MG01. Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 19. Okt. 2011 Geliefert am 27. Okt. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargors to the chargee or the other finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 20. Okt. 2006 Geliefert am 31. Okt. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee or to the other finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H and l/h property k/a shopstop@clapham centre clapham junction london and the windsor castle public house st johns hill clapham london t/no TGL83995 TGL656873 TGL47102 and TGL358487. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 09. Juli 2004 Geliefert am 19. Juli 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee (whether on its own account or on behalf of any of the security beneficiaries) or to the other security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 02. Juni 2004 Geliefert am 10. Juni 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargor to the chargee whether on its own account or on behalf of any of the security beneficiaries or to the other security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The f/h property known as the junction centre st john's hill clapham junction t/n TGL83995,. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A side letter (relating to a debenture dated 26 february 2001) | Erstellt am 12. Apr. 2002 Geliefert am 19. Apr. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben As under the debenture. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 26. Feb. 2001 Geliefert am 08. März 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under each finance document (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat METRO NOMINEES (CLAPHAM) LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0