JUDD FARRIS (NR) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | JUDD FARRIS (NR) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 04139510 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von JUDD FARRIS (NR) LIMITED?
- (7499) /
Wo befindet sich JUDD FARRIS (NR) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Hazlitt 4 Bouverie Street EC4Y 8AX London England |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von JUDD FARRIS (NR) LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für JUDD FARRIS (NR) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Ernennung von Medeco Developments Ltd als Sekretär am 04. Okt. 2011 | 2 Seiten | AP04 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 11. Jan. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Peter William Searle am 02. Dez. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom Project House 110-113 Tottenham Court Road London W1T 5AE England geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mrs Lindsay Horwood am 01. Dez. 2010 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Rücktritt eines Auditors | 2 Seiten | AA03 | ||||||||||
Verschiedenes Section 519 companies act 2006 | 2 Seiten | MISC | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Project House 110-113 Tottenham Court Road London W1T 5AE am 02. Dez. 2010 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Sara Mccracken als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 03. Jan. 2010 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Neil Wilson als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Ms Sara Mccracken als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Lindsay Horwood als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Melbourne als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Haresh Vaya als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Mr Neil Martin als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Peter William Searle als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Tyra Tutor als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Timothy Payne als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von JUDD FARRIS (NR) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HORWOOD, Lindsay | Sekretär | 4 Bouverie Street EC4Y 8AX London Hazlitt England | 150823430001 | |||||||||||
MEDECO DEVELOPMENTS LTD | Sekretär | 4 Bouverie Street EC4Y 8AX London Hazlitt House England |
| 164953840001 | ||||||||||
MARTIN, Neil | Geschäftsführer | 4 Bouverie Street EC4Y 8AX London Hazlitt England | England | British | Director | 126681070001 | ||||||||
SEARLE, Peter William | Geschäftsführer | 4 Bouverie Street EC4Y 8AX London Hazlitt England | England | British | None | 116102520004 | ||||||||
FARRIS, Mark Daniel | Sekretär | Mounts Farm Barn Cranbrook Road TN17 4ET Benenden Kent | British | Recruitment Consultant | 142385670001 | |||||||||
MCCRACKEN, Sara | Sekretär | 71 Elstree Way WD6 1WD Borehamwood Adecco House Hertfordshire | 150823610001 | |||||||||||
VAYA, Haresh, Secretary | Sekretär | Project House 110-113 Tottenham Court Road W1T 5AE London | British | Accountant | 117039150002 | |||||||||
TEMPLE SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 788-790 Finchley Road NW11 7TJ London | 900001120001 | |||||||||||
CROUCH, Robert Paul, Director | Geschäftsführer | Project House 110-113 Tottenham Court Road W1T 5AE London | Usa | United States | Director | 78292570001 | ||||||||
FARRIS, Mark Daniel | Geschäftsführer | Mounts Farm Barn Cranbrook Road TN17 4ET Benenden Kent | United Kingdom | British | Recruitment Consultant | 142385670001 | ||||||||
FEARNS, Jill | Geschäftsführer | 7 Oakfield Mews Oakfield M33 6NB Sale Cheshire | British | Recruitment Consultant | 53977930001 | |||||||||
JUDD, Dominic Alexander | Geschäftsführer | Witches Cottage Witches Lane TN22 3YD Fletching East Sussex | England | British | Recruitment Consultant | 142517420001 | ||||||||
MELBOURNE, John | Geschäftsführer | Project House 110-113 Tottenham Court Road W1T 5AE London | England | British | Director | 41048340001 | ||||||||
PAYNE, Timothy David, Director | Geschäftsführer | Project House 110-113 Tottenham Court Road W1T 5AE London | Usa | American | Director | 123943650001 | ||||||||
TUTOR, Tyra | Geschäftsführer | Project House 110-113 Tottenham Court Road W1T 5AE London | Usa | American | Director | 123943700001 | ||||||||
WILSON, Neil Linton | Geschäftsführer | Project House 110-113 Tottenham Court Road W1T 5AE London | England | British | Director | 157498090001 | ||||||||
COMPANY DIRECTORS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 788-790 Finchley Road NW11 7TJ London | 900001110001 |
Hat JUDD FARRIS (NR) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 24. Nov. 2008 Geliefert am 26. Nov. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
An omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 15. Juli 2008 Geliefert am 16. Juli 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
All assets debenture | Erstellt am 23. Sept. 2005 Geliefert am 27. Sept. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed and floating charge | Erstellt am 18. Dez. 2003 Geliefert am 30. Dez. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0