CASTERBRIDGE NURSERIES (GAYNES PARK) LTD
Überblick
| Unternehmensname | CASTERBRIDGE NURSERIES (GAYNES PARK) LTD |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04140242 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CASTERBRIDGE NURSERIES (GAYNES PARK) LTD?
- Vorschule (85100) / Erziehung
Wo befindet sich CASTERBRIDGE NURSERIES (GAYNES PARK) LTD?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 2 Crown Court NN10 6BS Rushden Northamptonshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CASTERBRIDGE NURSERIES (GAYNES PARK) LTD?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| GAYNES PARK NURSERY LIMITED | 12. Jan. 2001 | 12. Jan. 2001 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CASTERBRIDGE NURSERIES (GAYNES PARK) LTD?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2014 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für CASTERBRIDGE NURSERIES (GAYNES PARK) LTD?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für CASTERBRIDGE NURSERIES (GAYNES PARK) LTD?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mary Ann Tocio als Geschäftsführer am 01. Juni 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 12. Jan. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 12. Jan. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 12. Jan. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Ernennung von Stephen Kramer als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Stephen Dreier als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von David Lissy als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mary Ann Tocio als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Elizabeth Boland als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mary Tocio als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Lissy als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen Dreier als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Elizabeth Boland als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen Kramer als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Stephen Kramer als Sekretär | 3 Seiten | AP03 | ||||||||||
Verschiedenes Section 519 | 1 Seiten | MISC | ||||||||||
Ernennung von Elizabeth Boland als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von David Lissy als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CASTERBRIDGE NURSERIES (GAYNES PARK) LTD?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRAMER, Stephen | Sekretär | Crown Court NN10 6BS Rushden 2 Northamptonshire | 171973360001 | |||||||
| BOLAND, Elizabeth | Geschäftsführer | Crown Court NN10 6BS Rushden 2 Northamptonshire | United States | American | 70853820001 | |||||
| DREIER, Stephen | Geschäftsführer | Crown Court NN10 6BS Rushden 2 Northamptonshire | United States | American | 170443250001 | |||||
| LISSY, Dave | Geschäftsführer | Crown Court NN10 6BS Rushden 2 Northamptonshire | United States | American | 218331690001 | |||||
| BROSNAN, Paul | Sekretär | Croom House IRISH Croom Co Limerick Ireland | Irish | 102089360001 | ||||||
| DHANANI, Alnur Madatali | Sekretär | Simorgh Warren Road KT2 7HY Kingston Surrey | British | 2462470003 | ||||||
| HATHER, Jon | Sekretär | The Chambers Chelsea Harbour SW10 0XF London Suite 201 United Kingdom | British | 68848420004 | ||||||
| HURRAN, Anthony Robert | Sekretär | 10 St Marks Road Ealing W5 3JS London | British | 104970440001 | ||||||
| KRAMER, Stephen | Sekretär | Crown Court NN10 6BS Rushden 2 Northamptonshire | British | 169896160001 | ||||||
| MOORE, Matthew Jon | Sekretär | The Chambers Chelsea Harbour SW10 0XF London Suite 201 United Kingdom | British | 134350220001 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| BETTUM, Ole | Geschäftsführer | 54 Primrose Gardens NW3 4TP London | England | Norwegian | 50551730002 | |||||
| BOLAND, Elizabeth | Geschäftsführer | Crown Court NN10 6BS Rushden 2 Northamptonshire Uk | United States | American | 70853820001 | |||||
| BROSNAN, Paul | Geschäftsführer | The Chambers Chelsea Harbour SW10 0XF London Suite 201 United Kingdom | United Kingdom | Irish | 102089360002 | |||||
| CARNEY, Joseph Gerard | Geschäftsführer | 272 Gunnersbury Avenue W4 5QB London Suite 2 Chiswick Place | United Kingdom | Irish | 89273480001 | |||||
| DHANANI, Alnur Madatali | Geschäftsführer | Simorgh Warren Road KT2 7HY Kingston Surrey | United Kingdom | British | 2462470003 | |||||
| DREIER, Stephen | Geschäftsführer | Crown Court NN10 6BS Rushden 2 Northamptonshire Uk | United States | American | 170443250001 | |||||
| HEMSLEY, Maarten Duncan | Geschäftsführer | 265 Washington Street Duxbury Massachusetts 02332 Usa | United States | British | 69602210003 | |||||
| HURRAN, Anthony Robert | Geschäftsführer | The Chambers Chelsea Harbour SW10 0XF London Suite 201 United Kingdom | England | British | 184743670001 | |||||
| LISSY, Dave | Geschäftsführer | Crown Court NN10 6BS Rushden 2 Northamptonshire Uk | United States | American | 218331690001 | |||||
| MOORE, Matthew Jon | Geschäftsführer | The Chambers Chelsea Harbour SW10 0XF London Suite 201 United Kingdom | United Kingdom | British | 115340530001 | |||||
| PACE, Martin | Geschäftsführer | Christmas Farm Picketts Lane RH1 5RG Salfords Surrey | England | British | 74305820001 | |||||
| TERNOFSKY, Friedrich Ludwig Rudolf | Geschäftsführer | Kawartha Lodge Oak Grange Road West Clandon GU4 7UD Guildford Surrey | United Kingdom | Austrian | 11820520001 | |||||
| TOCIO, Mary Ann | Geschäftsführer | Crown Court NN10 6BS Rushden 2 Northamptonshire | Usa | Usa | 177507090001 | |||||
| TOCIO, Mary Ann | Geschäftsführer | Crown Court NN10 6BS Rushden 2 Northamptonshire Uk | Usa | Usa | 177507090001 | |||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Hat CASTERBRIDGE NURSERIES (GAYNES PARK) LTD Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 21. Dez. 2004 Geliefert am 06. Jan. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys and liabilities due or to become due from any obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 04. Dez. 2002 Geliefert am 06. Dez. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Freehold property 105 gaynes park road upminster essex t/n EX21073. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 04. Dez. 2002 Geliefert am 06. Dez. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 19. Dez. 2001 Geliefert am 08. Jan. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Property k/a 105 gaynes park road upminster RM14 2HX and all rights relating to the schedule property together with the contracts the book debts the intellectual property the plant and machinery the shares and derivative assets the goodwill and uncalled capital. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 30. Apr. 2001 Geliefert am 03. Mai 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 105 gaynes park road upminster RM14 2HX.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0