THE HILLARYS GROUP LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | THE HILLARYS GROUP LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04140621 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von THE HILLARYS GROUP LIMITED?
- Sonstige Herstellung n.e.c. (32990) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich THE HILLARYS GROUP LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Unit 2 Churchill Park Private Road No 2 Colwick NG4 2JR Nottingham Nottinghamshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von THE HILLARYS GROUP LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| HILLGATE (213) LIMITED | 12. Jan. 2001 | 12. Jan. 2001 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von THE HILLARYS GROUP LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für THE HILLARYS GROUP LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 041406210006 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Feb. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Feb. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Darren Hansel Lock als Geschäftsführer am 20. Feb. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Feb. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Andrew Richard Thomas am 12. März 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Feb. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Sept. 2017 bis 31. Dez. 2017 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 40 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2016 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Erklärung der Unternehmensgegenstände | 2 Seiten | CC04 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Feb. 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 12. Jan. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 02. Okt. 2015 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 12. Jan. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 02. Okt. 2015
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von THE HILLARYS GROUP LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEWIS, David Mathew Aubrey | Geschäftsführer | Private Road 2 Colwick Industrial Estate NG4 2JR Nottingham Hillarys Blinds Limited Nottinghamshire United Kingdom | United Kingdom | Australian | 110226830001 | |||||
| RISMAN, John Matthew | Geschäftsführer | Private Road 2 Colwick Industrial Estate NG4 2JR Nottingham Hillarys Blinds Limited Nottinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 107350020002 | |||||
| THOMAS, Andrew Richard | Geschäftsführer | Private Road 2 Colwick Industrial Estate NG4 2JR Nottingham Hillarys Blinds Limited Nottinghamshire England | England | British | 154618250004 | |||||
| DOBSON, Kevin Michael | Sekretär | Highways 3 Grantham Road Radcliffe On Trent NG12 2HB Nottingham | British | 95476170001 | ||||||
| NICHOLSON, James Brett | Sekretär | Laurel House 351 Mapperly Plains NG3 5RS Nottingham Nottinghamshire | British | 99628210001 | ||||||
| HILLGATE SECRETARIAL LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 7th Floor Hillgate House 26 Old Bailey EC4M 7HW London | 900018850001 | |||||||
| BURKE, David Richard Andrew | Geschäftsführer | 4 Adams Court DE7 8YF Ilkeston Derbyshire | British | 61576180002 | ||||||
| DALBY, Simon Andrew | Geschäftsführer | Private Road 2 Colwick Industrial Estate NG4 2JR Nottingham Hillarys Blinds Limited Nottinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 110227460002 | |||||
| DOBSON, Kevin Michael | Geschäftsführer | Highways 3 Grantham Road Radcliffe On Trent NG12 2HB Nottingham | United Kingdom | British | 95476170001 | |||||
| FERGUSON, Fiona Claire | Geschäftsführer | Cleveland Cottage Main Street NG23 5BA Claypole Nottinghamshire | British | 55116100001 | ||||||
| HOLMES, Roger Anthony | Geschäftsführer | 421 Flagstaff House 10 St George Wharf SW8 2LZ Vauxhall London | United Kingdom | British | 105159350001 | |||||
| LOCK, Darren Hansel | Geschäftsführer | Private Road 2 Colwick Industrial Estate NG4 2JR Nottingham Hillarys Blinds Limited Nottinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 131597650005 | |||||
| NICHOLSON, James Brett | Geschäftsführer | Laurel House 351 Mapperly Plains NG3 5RS Nottingham Nottinghamshire | British | 99628210001 | ||||||
| PETROW, Steven | Geschäftsführer | Flat 2 48 Lennox Gardens SW1X 0DJ London | United Kingdom | American | 96100200001 | |||||
| RUSSO, Lorenzo | Geschäftsführer | Flat 19 17 Eccleston Place SW1W 9NF London | Italian | 96100220001 | ||||||
| SHANKS, Michael Anthony | Geschäftsführer | Oakdene Main Street NG25 0UT Morton Nottinghamshire | British | 25653690004 | ||||||
| SNAPES, Michael Joseph | Geschäftsführer | Low Hill Cottage Low Hill Road, Roydon CM19 5JN Harlow Essex | British | 64079340001 | ||||||
| WILDIG, Simon Roger | Geschäftsführer | 11 Davis Road KT13 0XH Weybridge Surrey | British | 75978900002 | ||||||
| HILLGATE NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 7th Floor Hillgate House 26 Old Bailey EC4M 7HW London | 900018840001 | |||||||
| HILLGATE SECRETARIAL LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 7th Floor Hillgate House 26 Old Bailey EC4M 7HW London | 900018850001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei THE HILLARYS GROUP LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hillarys Blinds (Holdings) Limtied | 30. Juni 2016 | Private Road 2 Colwick Industrial Estate NG4 2JR Nottingham Unit 2 Churchill Park England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat THE HILLARYS GROUP LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 01. Aug. 2014 Geliefert am 04. Aug. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement | Erstellt am 21. Juni 2007 Geliefert am 02. Juli 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the group to the secured creditors (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A security agreement | Erstellt am 30. Juli 2004 Geliefert am 13. Aug. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the principal debtor to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Trust debenture made between (1) the company (2) the obligors and (3) the security trustee (all terms as defined) | Erstellt am 08. Mai 2001 Geliefert am 22. Mai 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies and liabilities (whether actual or contingent) due or to become due from or by any obligor to the lender under the terms of any finance document (all terms as defined) | |
Kurze Angaben All that freehold land known as units 2 & 3 colwick business park colwick industrial estate mile end colwick nottingham title number NT177997 all that freehold land known as unit 4 colwick business park as aforesaid title number NT179293 all that freehold land known as unit 2 churchill park colwick industrial estate mile end road colwick nottingham title number NT257445 all that freehold land known as units 3 & 4 churchill park as aforesaid title number NT272090 all that freehold land known as land at victoria park netherfield lane netherfield nottingham title number NT327077. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Trust debenture made between (1) the company (2) the obligors and (3) the security trustee (all terms as defined) | Erstellt am 08. Mai 2001 Geliefert am 22. Mai 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies and liabilities (whether actual or contingent) due or to become due from or by any obligor to the security trustee under the terms of any finance document (all terms as defined) | |
Kurze Angaben All that freehold land known as units 2 & 3 colwick business park colwick industrial estate mile end colwick nottingham title number NT177997 all that freehold land known as unit 4 colwick business park as aforesaid title number NT179293 all that freehold land known as unit 2 churchill park colwick industrial estate mile end road colwick nottingham title number NT257445 all that freehold land known as units 3 & 4 churchill park as aforesaid title number NT272090 all that freehold land known as land at victoria park netherfield lane netherfield nottingham title number NT327077. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture between the company and the royal bank of scotland PLC (the "security trustee") acting as security trustee for the finance parties | Erstellt am 08. Mai 2001 Geliefert am 21. Mai 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any finance party under or pursuant to any of the financing documents (including in particular under the guarantee). All terms as defined. | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0