VINTAGE DRINKS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameVINTAGE DRINKS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04141132
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von VINTAGE DRINKS LIMITED?

    • (5134) /

    Wo befindet sich VINTAGE DRINKS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    12-14 Carlton Place
    SO15 2EA Southampton
    Hampshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von VINTAGE DRINKS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CLASSIC DRINKS LIMITED15. Feb. 200115. Feb. 2001
    BROOMCO (2451) LIMITED15. Jan. 200115. Jan. 2001

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von VINTAGE DRINKS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis26. Juni 2010

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für VINTAGE DRINKS LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für VINTAGE DRINKS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    GAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    17 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 21. Juni 2013

    15 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 21. Juni 2012

    16 Seiten4.68

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator

    1 Seiten4.40

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    7 Seiten4.20

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren

    LRESEX

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * the Sovereign Distillery Wilson Road Huyton Business Park Liverpool Merseyside L36 6AD United Kingdom* am 14. Juni 2011

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 26. Juni 2010

    20 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 15. Jan. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital17. Jan. 2011

    Kapitalaufstellung am 17. Jan. 2011

    • Kapital: GBP 750,000
    SH01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Unit 14 Reginald Road Industrial Estate Brindley Road St Helens Merseyside WA9 4JB* am 22. Okt. 2010

    1 SeitenAD01

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed classic drinks LIMITED\certificate issued on 18/10/10
    3 SeitenCERTNM
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name18. Okt. 2010

    Beschluss zur Änderung der Firma am 13. Okt. 2010

    RES15

    Hinweis auf Namensänderung

    2 SeitenCONNOT

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Beschlüsse

    Resolutions
    28 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Satzung und/oder Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Erklärung der Unternehmensgegenstände

    2 SeitenCC04

    Jahresabschluss erstellt bis zum 27. Juni 2009

    21 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Alfred Joseph Vaughan am 24. Feb. 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Andrew Donald Smallman am 24. Feb. 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Simon John Oldroyd am 24. Feb. 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Mr Peter Luke Horsfall am 24. Feb. 2010

    1 SeitenCH03

    Wer sind die Geschäftsführer von VINTAGE DRINKS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HORSFALL, Peter Luke
    Carlton Place
    SO15 2EA Southampton
    12-14
    Hampshire
    Sekretär
    Carlton Place
    SO15 2EA Southampton
    12-14
    Hampshire
    British109453290001
    HALEWOOD, John Edward
    The Sovereign Distillery
    Wilson Road Huyton Business Park
    L36 6AD Liverpool
    Merseyside
    Geschäftsführer
    The Sovereign Distillery
    Wilson Road Huyton Business Park
    L36 6AD Liverpool
    Merseyside
    United KingdomBritish6757540009
    OLDROYD, Simon John
    Carlton Place
    SO15 2EA Southampton
    12-14
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Carlton Place
    SO15 2EA Southampton
    12-14
    Hampshire
    United KingdomBritish32198870002
    SMALLMAN, Andrew Donald
    Carlton Place
    SO15 2EA Southampton
    12-14
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Carlton Place
    SO15 2EA Southampton
    12-14
    Hampshire
    EnglandBritish55685640001
    VAUGHAN, Alfred Joseph
    Carlton Place
    SO15 2EA Southampton
    12-14
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Carlton Place
    SO15 2EA Southampton
    12-14
    Hampshire
    United KingdomBritish90987590002
    HORSFALL, Peter Luke
    31 Welman Way
    WA15 8WE Altrincham
    Cheshire
    Sekretär
    31 Welman Way
    WA15 8WE Altrincham
    Cheshire
    British109453290001
    OLDROYD, Simon John
    Spa Farmhouse
    Spa Lane Lathom
    L40 6JG Ormskirk
    Lancashire
    Sekretär
    Spa Farmhouse
    Spa Lane Lathom
    L40 6JG Ormskirk
    Lancashire
    British32198870002
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Bevollmächtigter Sekretär
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001
    WHARTON, Dale
    4 Kingsmede
    WN1 2NL Wigan
    Geschäftsführer
    4 Kingsmede
    WN1 2NL Wigan
    EnglandBritish74558220003
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016450001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001

    Hat VINTAGE DRINKS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture created without written instrument
    Erstellt am 20. Feb. 2009
    Geliefert am 20. Feb. 2009
    Teilweise erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Halewood International Holdings PLC
    Transaktionen
    • 20. Feb. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Okt. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 26 may 2000 and
    Erstellt am 23. Mai 2008
    Geliefert am 07. Juni 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Juni 2008Registrierung einer Belastung (395)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Erstellt am 11. Mai 2006
    Geliefert am 24. Mai 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement (ogsa) dated 26 may 2000 and
    Erstellt am 22. März 2005
    Geliefert am 24. März 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. März 2005Registrierung einer Belastung (395)
    All assets debenture deed
    Erstellt am 16. Sept. 2003
    Geliefert am 23. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 23. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Okt. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture deed
    Erstellt am 19. Feb. 2001
    Geliefert am 28. Feb. 2001
    Teilweise erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Feb. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Okt. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)

    Hat VINTAGE DRINKS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    22. Juni 2011Beginn der Liquidation
    15. Aug. 2014Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Alan David Fallows
    Barnett House 53 Fountain Street
    M2 2AN Manchester
    Praktiker
    Barnett House 53 Fountain Street
    M2 2AN Manchester
    Gordon John Johnston
    Hjs Recovery 12-14 Carlton Place
    SO15 2EA Southampton
    Hampshire
    Praktiker
    Hjs Recovery 12-14 Carlton Place
    SO15 2EA Southampton
    Hampshire
    Stephen Powell
    12/14 Carlton Place
    SO15 2EA Southampton
    Praktiker
    12/14 Carlton Place
    SO15 2EA Southampton

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0