VINTAGE DRINKS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | VINTAGE DRINKS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04141132 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von VINTAGE DRINKS LIMITED?
- (5134) /
Wo befindet sich VINTAGE DRINKS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 12-14 Carlton Place SO15 2EA Southampton Hampshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von VINTAGE DRINKS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| CLASSIC DRINKS LIMITED | 15. Feb. 2001 | 15. Feb. 2001 |
| BROOMCO (2451) LIMITED | 15. Jan. 2001 | 15. Jan. 2001 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von VINTAGE DRINKS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 26. Juni 2010 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für VINTAGE DRINKS LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für VINTAGE DRINKS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | GAZ2 | |||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 17 Seiten | 4.72 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 21. Juni 2013 | 15 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 21. Juni 2012 | 16 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator | 1 Seiten | 4.40 | ||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 4.19 | 7 Seiten | 4.20 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * the Sovereign Distillery Wilson Road Huyton Business Park Liverpool Merseyside L36 6AD United Kingdom* am 14. Juni 2011 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 26. Juni 2010 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Jan. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Unit 14 Reginald Road Industrial Estate Brindley Road St Helens Merseyside WA9 4JB* am 22. Okt. 2010 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed classic drinks LIMITED\certificate issued on 18/10/10 | 3 Seiten | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Hinweis auf Namensänderung | 2 Seiten | CONNOT | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 28 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Unternehmensgegenstände | 2 Seiten | CC04 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 27. Juni 2009 | 21 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Alfred Joseph Vaughan am 24. Feb. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Andrew Donald Smallman am 24. Feb. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Simon John Oldroyd am 24. Feb. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mr Peter Luke Horsfall am 24. Feb. 2010 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von VINTAGE DRINKS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORSFALL, Peter Luke | Sekretär | Carlton Place SO15 2EA Southampton 12-14 Hampshire | British | 109453290001 | ||||||
| HALEWOOD, John Edward | Geschäftsführer | The Sovereign Distillery Wilson Road Huyton Business Park L36 6AD Liverpool Merseyside | United Kingdom | British | 6757540009 | |||||
| OLDROYD, Simon John | Geschäftsführer | Carlton Place SO15 2EA Southampton 12-14 Hampshire | United Kingdom | British | 32198870002 | |||||
| SMALLMAN, Andrew Donald | Geschäftsführer | Carlton Place SO15 2EA Southampton 12-14 Hampshire | England | British | 55685640001 | |||||
| VAUGHAN, Alfred Joseph | Geschäftsführer | Carlton Place SO15 2EA Southampton 12-14 Hampshire | United Kingdom | British | 90987590002 | |||||
| HORSFALL, Peter Luke | Sekretär | 31 Welman Way WA15 8WE Altrincham Cheshire | British | 109453290001 | ||||||
| OLDROYD, Simon John | Sekretär | Spa Farmhouse Spa Lane Lathom L40 6JG Ormskirk Lancashire | British | 32198870002 | ||||||
| DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016460001 | |||||||
| WHARTON, Dale | Geschäftsführer | 4 Kingsmede WN1 2NL Wigan | England | British | 74558220003 | |||||
| DLA NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016450001 | |||||||
| DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016460001 |
Hat VINTAGE DRINKS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture created without written instrument | Erstellt am 20. Feb. 2009 Geliefert am 20. Feb. 2009 | Teilweise erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 26 may 2000 and | Erstellt am 23. Mai 2008 Geliefert am 07. Juni 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 11. Mai 2006 Geliefert am 24. Mai 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement (ogsa) dated 26 may 2000 and | Erstellt am 22. März 2005 Geliefert am 24. März 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| All assets debenture deed | Erstellt am 16. Sept. 2003 Geliefert am 23. Sept. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture deed | Erstellt am 19. Feb. 2001 Geliefert am 28. Feb. 2001 | Teilweise erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat VINTAGE DRINKS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0