R938 LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | R938 LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04141371 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von R938 LIMITED?
- Entwicklung von Geschäfts- und Haushaltssoftware (62012) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich R938 LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Pearl Assurance House 319 Ballards Lane N12 8LY London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von R938 LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ROSTIMA LIMITED | 15. Jan. 2001 | 15. Jan. 2001 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von R938 LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2013 |
Welche sind die letzten Einreichungen für R938 LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 16. Aug. 2016 | 16 Seiten | 2.35B | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 25. Feb. 2016 | 16 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge | 1 Seiten | F2.18 | ||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 2.14B | 6 Seiten | 2.16B | ||||||||||
Vorschlag des Verwalters | 33 Seiten | 2.17B | ||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed rostima LIMITED\certificate issued on 12/10/15 | 3 Seiten | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Hinweis auf Namensänderung | 2 Seiten | CONNOT | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Grant Thornton Uk Llp 1020 Eskdale Road Winnersh Wokingham RG41 5TS zum Pearl Assurance House 319 Ballards Lane London N12 8LY am 11. Sept. 2015 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines Verwalters | 1 Seiten | 2.12B | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Edward William Anthony Lascelles als Geschäftsführer am 30. März 2015 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 041413710011, erstellt am 30. März 2015 | 25 Seiten | MR01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Jan. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Colin George Eric Corbally als Geschäftsführer am 12. Sept. 2014 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Glenn Anthony Balfour Burns am 08. Okt. 2014 | 4 Seiten | CH01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 041413710009 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 8 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Eintragung der Belastung 041413710010, erstellt am 12. Sept. 2014 | 25 Seiten | MR01 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 041413710009, erstellt am 31. Juli 2014 | 25 Seiten | MR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Bryan Taylor als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Jan. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Glenn Anthony Balfour Burns am 19. Dez. 2012 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von R938 LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURNS, Glenn Anthony Balfour | Geschäftsführer | Campbell Road SL7 3GZ Marlow 11 Buckinghamshire England | Uk | United States | 52856690004 | |||||
| MOORE, Steven Nigel, Director | Geschäftsführer | Kriss Kringle Bailes Lane, Normandy GU3 2AX Guildford Surrey | Uk | British | 107805540001 | |||||
| MACCAW, Robin Guy | Sekretär | Tudor Cottage Whitchurch On Thames RG8 7EP Reading Berkshire | British | 80067480001 | ||||||
| HALLMARK SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 120 East Road N1 6AA London | 900004100001 | |||||||
| INTERNATIONAL REGISTRARS LIMITED | Sekretär | Finsgate 5-7 Cranwood Street EC1V 9EE London | 75643100001 | |||||||
| AITKEN, Steve | Geschäftsführer | 2 Apriory Road Waverton Nsw 2060 Australia | Australian | 74328390002 | ||||||
| BERKNOV, Kim | Geschäftsführer | 19 Enmore Gardens East Sheen SW14 8RF London | United Kingdom | Danish | 106297960001 | |||||
| BULLARD, Arthur Reader | Geschäftsführer | Hawkhurst House Hawkhurst Court RH14 0HS Wisborough Green | England | British | 61462270003 | |||||
| CORBALLY, Colin George Eric | Geschäftsführer | Parkland Drive AL3 4AH St Albans 1 Hertfordshire United Kingdom | England | British | 119811940001 | |||||
| LASCELLES, Edward William Anthony | Geschäftsführer | St. Helens Gardens W10 6LN London 43 | England | British | 78680750002 | |||||
| MACCAW, Robin Guy | Geschäftsführer | Tudor Cottage Whitchurch On Thames RG8 7EP Reading Berkshire | England | British | 80067480001 | |||||
| MARSH, John Richard, Dr | Geschäftsführer | 1 Prospect Row CB1 1DU Cambridge Cambridgeshire | United Kingdom | British | 67395100001 | |||||
| MOTT, David Edward Christian | Geschäftsführer | Long Barn Church Close Stanton St John OX33 1DN Oxford | England | British | 163744630001 | |||||
| STINTON, Nicholas Michael | Geschäftsführer | Lower Grosvenor Place SW1W 0EN London 10 United Kingdom | England | British | 153998240001 | |||||
| TAYLOR, Alan | Geschäftsführer | 22 Kinghorn Park SL6 7TX Maidenhead Berkshire | British | 51221440002 | ||||||
| TAYLOR, Bryan Lloyd | Geschäftsführer | Hatch Cottage Kent Street, Cowfold RH13 8BG Horsham West Sussex | England | British | 71356520002 | |||||
| WARD, Ashley | Geschäftsführer | 11 Ellison Road Barnes SW13 0AD London | United Kingdom | British | 41755590003 | |||||
| HALLMARK REGISTRARS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 120 East Road N1 6AA London | 900004090001 |
Hat R938 LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 30. März 2015 Geliefert am 31. März 2015 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung All freehold and leasehold property vested in the company both present and future together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery from time to time thereon and therein. All licences and patents (including applications and the rights to apply therefore), copyright, rights in trademarks whether registered or not, trade names, rights in service whether registered or not, registered designs, know-how and rights, confidential information now or at any time belonging to the company. Refer to instrument for more details. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 12. Sept. 2014 Geliefert am 18. Sept. 2014 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung All freehold and leasehold property vested in the company both present and future together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery from time to time thereon and therein. All licences and patents (including applications and the rights to apply therefore), copyright, rights in trademarks whether registered or not, trade names, rights in service marks whether registered or not, registered designs, know-how and rights confidential information now or at any time belonging to the company.. Refer to instrument for more details. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 31. Juli 2014 Geliefert am 07. Aug. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung All other freeholder and leasehold property vested in the company both present and future together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery from time to time thereon and therein. All licences and patents (including applications and the rights to apply therefore), copyrights, rights in trademarks whether registered or not, trade names, rights in service marks whether registered or not, registered designs, know-how and rights in confidential information now or at any time belonging to the company. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 22. Juli 2011 Geliefert am 29. Juli 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or rostima holdings limited (together the obligors and each as obligor) to the stockholders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 27. Aug. 2010 Geliefert am 03. Sept. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from rostima holdings limited and rostima limited to the original stockholders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Trust debenture | Erstellt am 01. Apr. 2010 Geliefert am 08. Apr. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Trust debenture | Erstellt am 04. Aug. 2009 Geliefert am 19. Aug. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the stockholders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Further charge | Erstellt am 11. Sept. 2008 Geliefert am 18. Sept. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 23. Feb. 2007 Geliefert am 07. März 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 31. März 2005 Geliefert am 09. Apr. 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag £14,062.50 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The sum of £14,062.50 and any additions thereto. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 08. Sept. 2004 Geliefert am 13. Sept. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat R938 LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| In Verwaltung |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0