LOOKLET LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameLOOKLET LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04142796
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von LOOKLET LIMITED?

    • (7011) /
    • (7499) /

    Wo befindet sich LOOKLET LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    5 North End Road
    Golders Green
    NW11 7RJ London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von LOOKLET LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ELINIA LIMITED17. Jan. 200117. Jan. 2001

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LOOKLET LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für LOOKLET LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    2 SeitenDS01

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    1 SeitenDISS40

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    6 SeitenAA

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt

    1 SeitenDISS16(SOAS)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    6 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    2 Seiten288a

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2006

    6 SeitenAA

    legacy

    7 Seiten363s

    legacy

    Seiten363(288)

    legacy

    2 Seiten288a

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2005

    6 SeitenAA

    legacy

    7 Seiten363s

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2004

    6 SeitenAA

    legacy

    7 Seiten363s

    legacy

    7 Seiten363s

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2003

    5 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten403a

    legacy

    2 Seiten403a

    legacy

    2 Seiten403a

    Wer sind die Geschäftsführer von LOOKLET LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    DEUTSCH, Chaim Leib
    Flat 5 Garfield
    17 Holmbrook Drive
    NW4 2LU London
    Sekretär
    Flat 5 Garfield
    17 Holmbrook Drive
    NW4 2LU London
    British61133060001
    DEUTSCH, Chaim Leib
    Flat 5 Garfield
    17 Holmbrook Drive
    NW4 2LU London
    Geschäftsführer
    Flat 5 Garfield
    17 Holmbrook Drive
    NW4 2LU London
    EnglandBritish61133060001
    GURVITZ, Joseph
    296 Golders Green Road
    NW11 9PY London
    Geschäftsführer
    296 Golders Green Road
    NW11 9PY London
    United KingdomBritish90042110003
    GURVITZ, Meir
    296 Golders Green Road
    NW11 9PY London
    Geschäftsführer
    296 Golders Green Road
    NW11 9PY London
    EnglandBritish43943590002
    VECHT, Dina
    Flat 2 Stanview Court
    5 Queens Road Barnet
    NW4 2TH London
    Geschäftsführer
    Flat 2 Stanview Court
    5 Queens Road Barnet
    NW4 2TH London
    United KingdomBritish127487970001
    COMRUSCO UK LIMITED
    Plas Y Coed House
    3 Cwrt Y Cadno
    CF5 4PJ St Fagans
    Cardiff
    Sekretär
    Plas Y Coed House
    3 Cwrt Y Cadno
    CF5 4PJ St Fagans
    Cardiff
    73901430001
    WALGATE SERVICES LIMITED
    25 North Row
    W1K 6DJ London
    Sekretär
    25 North Row
    W1K 6DJ London
    59142480001
    GUY, Paul Meyrick
    Erw Wen
    Rudry Road Lisvane
    CF14 0SN Cardiff
    South Wales
    Geschäftsführer
    Erw Wen
    Rudry Road Lisvane
    CF14 0SN Cardiff
    South Wales
    WalesBritish47149550001
    JONES, Stephen Rhys
    Meliden House 65 Stanwell Road
    CF64 3LR Penarth
    South Glamorgan
    Geschäftsführer
    Meliden House 65 Stanwell Road
    CF64 3LR Penarth
    South Glamorgan
    WalesBritish52907050003
    TWAMLEY, Paul James
    88a Plymouth Road
    Penarth
    CF64 5DL Cardiff
    Geschäftsführer
    88a Plymouth Road
    Penarth
    CF64 5DL Cardiff
    British27438640006
    WARWICK, Timothy James
    Plas Y Coed 3 Cwrt Y Cadno
    St Fagans
    CF5 4PJ Cardiff
    Wales
    Geschäftsführer
    Plas Y Coed 3 Cwrt Y Cadno
    St Fagans
    CF5 4PJ Cardiff
    Wales
    British65745040001

    Hat LOOKLET LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 22. Jan. 2004
    Geliefert am 02. Feb. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Real Estate Capital Limited
    Transaktionen
    • 02. Feb. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 21. Juli 2003
    Geliefert am 05. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrower to the bank (and/or to the hedging counterparty) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land being land lying to the south of dunleavy drive celtic gateway cardiff bay cardiff wales t/n CYM56681. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 05. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Feb. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of rental income
    Erstellt am 05. Feb. 2003
    Geliefert am 18. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title and interest in and to the rental income.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Feb. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 20. Dez. 2001
    Geliefert am 04. Jan. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land and all buildings at dunleavy drive celtic gateway cardiff t/n GYM965142. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Jan. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Feb. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge and assignment of agreement by way of security (the "deed")
    Erstellt am 20. Dez. 2001
    Geliefert am 04. Jan. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title and interest in or arising out or in respect of all the agreements: agreement for lease dated 3/9/01 between the company and british telecommunications PLC. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Jan. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Feb. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge and assignment of agreement by way of security (the "deed")
    Erstellt am 20. Dez. 2001
    Geliefert am 04. Jan. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title and interest in or arising out or in respect of all the agreements: a construction contract dated 20/12/01 between the company and john mowlem & company PLC. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Jan. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Feb. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over a deposit
    Erstellt am 20. Dez. 2001
    Geliefert am 04. Jan. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    With all title guarantee of the company,the deposit to the bank by way of fixed charge, leeds city branch - sort code 05-00-20 - business account - elinia limited project account - 11207592. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Jan. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Feb. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 20. Dez. 2001
    Geliefert am 04. Jan. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Jan. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Feb. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0