RIVERGRANGE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameRIVERGRANGE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04143652
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von RIVERGRANGE LIMITED?

    • (7011) /
    • (7012) /
    • (7020) /

    Wo befindet sich RIVERGRANGE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    49 Watford Way
    London
    NW4 3JH
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von RIVERGRANGE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2004

    Welche sind die letzten Einreichungen für RIVERGRANGE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Beendigung der Liquidation

    1 SeitenL64.07

    Gerichtsbeschluss zur Liquidation

    1 SeitenCOCOMP

    Gerichtsbeschluss zur Liquidation

    3 SeitenCOCOMP

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    5 Seiten405(1)

    legacy

    5 Seiten363a

    legacy

    5 Seiten363a

    legacy

    5 Seiten363a

    legacy

    6 Seiten363a

    legacy

    6 Seiten395

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten287

    Wer sind die Geschäftsführer von RIVERGRANGE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HADAR, Anne Francoise
    Haim Landau Street
    58670 Holon
    5
    Israel
    Sekretär
    Haim Landau Street
    58670 Holon
    5
    Israel
    Other138899520001
    DINSTEIN, Zvi
    Hey Beyar Street
    62998 Tel Aviv
    24
    Israel
    Geschäftsführer
    Hey Beyar Street
    62998 Tel Aviv
    24
    Israel
    Israeli138899480001
    BEARMAN, Clive Paul
    107 Green Lane
    HA6 1AP Northwood
    Middlesex
    Sekretär
    107 Green Lane
    HA6 1AP Northwood
    Middlesex
    British74741360001
    GROSSFELD, Gal
    24/1 Beit Haeshell Street
    68025 Tel Aviv Jaffa
    68025
    Israel
    Sekretär
    24/1 Beit Haeshell Street
    68025 Tel Aviv Jaffa
    68025
    Israel
    Israeli120582660001
    REILLY, Julian Hugh George
    Oak Tree House
    3 Gravel Hill
    UB8 1PB Uxbridge
    Sekretär
    Oak Tree House
    3 Gravel Hill
    UB8 1PB Uxbridge
    British10384040002
    L & A SECRETARIAL LIMITED
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    Bevollmächtigter Sekretär
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    900001450001
    SLC CORPORATE SERVICES LIMITED
    42-46 High Street
    KT10 9QY Esher
    Surrey
    Sekretär
    42-46 High Street
    KT10 9QY Esher
    Surrey
    74654310001
    WALGATE SERVICES LIMITED
    25 North Row
    W1K 6DJ London
    Sekretär
    25 North Row
    W1K 6DJ London
    59142480001
    COHEN, Matisyahu Nachum
    20 Hazedef Street
    66107 Tel Aviv Jaffa
    66107
    Israel
    Geschäftsführer
    20 Hazedef Street
    66107 Tel Aviv Jaffa
    66107
    Israel
    American120990560001
    COWAN, Paterson
    Flat 8 Limes Court
    23 Brondesbury Park
    NW6 7BS London
    Geschäftsführer
    Flat 8 Limes Court
    23 Brondesbury Park
    NW6 7BS London
    British80150120002
    GROSSFELD, Gal
    24/1 Beit Haeshell Street
    68025 Tel Aviv Jaffa
    68025
    Israel
    Geschäftsführer
    24/1 Beit Haeshell Street
    68025 Tel Aviv Jaffa
    68025
    Israel
    Israeli120582660001
    MAIMON, Jehuda
    Taberkin 16
    Tel Aviv
    69357
    Geschäftsführer
    Taberkin 16
    Tel Aviv
    69357
    Israeli100974630001
    SAUNDERS, Philip James
    1 Vale Close
    W9 1RR London
    Geschäftsführer
    1 Vale Close
    W9 1RR London
    United KingdomBritish68270500001
    YOSHPE, Gideon
    8 Reynolds Close
    NW11 7EA London
    Geschäftsführer
    8 Reynolds Close
    NW11 7EA London
    Israeli73657620002
    L & A REGISTRARS LIMITED
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    900001440001

    Hat RIVERGRANGE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 25. Juni 2007
    Geliefert am 04. Juli 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from dorot malta to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Property k/a 68/74 church street croydon t/n SGL530831 all its property insurances and insurance policies. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Murlin Limited
    Transaktionen
    • 04. Juli 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Rental assignation
    Erstellt am 10. Jan. 2005
    Geliefert am 25. Jan. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The benefit of all rent and other sums payable under the lease entered into between dock lane properties limited and imperial chemical industries PLC dated 27/6/2001 and 3/7/2001 (the "lease"), together with such arrears, all vat (if any) and all interest payable on such monies. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 25. Jan. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 31. Dez. 2004
    Geliefert am 12. Jan. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings being 68 to 74 church street croydon greater london t/n SGL530831. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 12. Jan. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. März 2009Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
      • Aktenzeichen 1
    Standard security which was presented for registration in scotland on 17 january 2005 and
    Erstellt am 29. Dez. 2004
    Geliefert am 21. Jan. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All and whole the subjects on the south east side of old bridge road, ayr t/no. AYR37378.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 21. Jan. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rental assignation
    Erstellt am 29. Dez. 2004
    Geliefert am 15. Jan. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All rents payable under the lease dated 27 june and 3 july and registered on 9 august all 2001 together with such arrears (if any) existing at the date of the charge. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 15. Jan. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Second legal charge
    Erstellt am 13. Mai 2004
    Geliefert am 21. Mai 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from dock lane properties limited and/or snowgram limited and/or their subsidiaries or related parties to the chargee (lender) and all sums deposited by the lender with 0BANK of scotland and with israel discount bank to secure facilities which are or will be advanced to the dock lane group and or its subsidiaries or related parties
    Kurze Angaben
    Land at church street croydon t/no. SGL530831.
    Berechtigte Personen
    • Dorot Properties and Holdings Limited and Dorot Malta Limited
    Transaktionen
    • 21. Mai 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Jan. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge containing fixed and floating charges
    Erstellt am 21. Nov. 2001
    Geliefert am 22. Nov. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 22. Nov. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Jan. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on the 17 august 2001 and
    Erstellt am 09. Aug. 2001
    Geliefert am 29. Aug. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All and whole the subjects k/a 1 old bridge road ayr t/n ayr 037378.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 29. Aug. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Jan. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on the 17TH august 2001 and
    Erstellt am 09. Aug. 2001
    Geliefert am 29. Aug. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All and whole the sublects extending to 0.31 acres ot thereby at st.mary's industria; estate,dumfries t/n dmf 008569.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 29. Aug. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Jan. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 09. Aug. 2001
    Geliefert am 22. Aug. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 22. Aug. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Jan. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat RIVERGRANGE LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Jonathan Howard Gershinson
    27 Soho Square
    W1D 3AY London
    Receiver Manager
    27 Soho Square
    W1D 3AY London
    Ania Packman
    27 Soho Square
    W1D 3AY London
    Receiver Manager
    27 Soho Square
    W1D 3AY London
    2
    DatumTyp
    24. Aug. 2010Aufgelöst am
    01. Sept. 2009Antragsdatum
    11. Mai 2010Abschluss der Liquidation
    04. Nov. 2009Beginn der Liquidation
    Zwangsliquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    The Official Receiver Or London
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    Praktiker
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0