D.U.K.E. PROPERTIES (MARSH MILLS) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | D.U.K.E. PROPERTIES (MARSH MILLS) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04148580 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von D.U.K.E. PROPERTIES (MARSH MILLS) LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
Wo befindet sich D.U.K.E. PROPERTIES (MARSH MILLS) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | The Shard 32 London Bridge Street SE1 9SG London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von D.U.K.E. PROPERTIES (MARSH MILLS) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| VALAD PROPERTIES (MARSH MILLS) LIMITED | 31. Jan. 2008 | 31. Jan. 2008 |
| ROK 011 LIMITED | 19. Dez. 2001 | 19. Dez. 2001 |
| ROKFORCE LIMITED | 26. Jan. 2001 | 26. Jan. 2001 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von D.U.K.E. PROPERTIES (MARSH MILLS) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für D.U.K.E. PROPERTIES (MARSH MILLS) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 14 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Feb. 2022 | 13 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 1st Floor Unit 16 Manor Court Business Park Scarborough YO11 3TU zum The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG am 10. März 2021 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 6 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Cromwell Corporate Secretarial Limited am 07. Sept. 2020 | 1 Seiten | CH04 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Juni 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2019 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2018 | 24 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Juni 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. Dez. 2018 bis 30. Sept. 2018 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Juni 2018 bis 31. Dez. 2018 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Juni 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2017 | 25 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Juni 2017 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Valsec Director Limited am 24. Feb. 2017 | 1 Seiten | CH02 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Valad Secretarial Services Limited am 24. Feb. 2017 | 1 Seiten | CH04 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Neil Kenneth Robertson als Geschäftsführer am 24. Feb. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr James Edward Maddy als Direktor am 24. Feb. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2016 | 23 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 26. Jan. 2017 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von D.U.K.E. PROPERTIES (MARSH MILLS) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROMWELL CORPORATE SECRETARIAL LIMITED | Sekretär | Spaces, Lochrin Square, 1 Lochrin Square 92-98 Fountainbridge EH3 9QA Edinburgh Cromwell Property Group United Kingdom |
| 133355520004 | ||||||||||
| MADDY, James Edward | Geschäftsführer | Unit 16 Manor Court Business Park YO11 3TU Scarborough 1st Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 137459000002 | |||||||||
| CROMWELL DIRECTOR LIMITED | Geschäftsführer | Floor Unit 16 Manor Court Business Park YO11 3TU Scarborough 1st United Kingdom |
| 102622300003 | ||||||||||
| TURNBULL, Julian Patrick | Sekretär | The Knoll Marsh Green EX5 2ES Exeter Devon | English | 11548360002 | ||||||||||
| OVALSEC LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 2 Temple Back East Temple Quay BS1 6EG Bristol | 900002570001 | |||||||||||
| BAILEY, Michael William John | Geschäftsführer | 1 Biddington Way EX14 2GU Honiton Devon | British | 104839850001 | ||||||||||
| CHRISTIE, Ross Arneil | Geschäftsführer | Whichway House 149 Marine Drive Rottingdean BN2 7GU Brighton East Sussex | England | British | 106468680002 | |||||||||
| HARBOTTLE, David John | Geschäftsführer | Primrose Bank Teignmouth Road TQ14 9PL Bishopsteignton Devon | British | 39542750003 | ||||||||||
| HOLE, Nicholas Ian | Geschäftsführer | Beech Trees Lane TQ12 5TW Ipplepen Windmill Brake Devon | United Kingdom | British | 128347270001 | |||||||||
| HOWE, Robert Philip Graham | Geschäftsführer | Floor Unit 16 Manor Court Business Park YO11 3TU Scarborough 1st United Kingdom | United Kingdom | British, | 100940120001 | |||||||||
| KAY, Mark Russell | Geschäftsführer | Mamhead Court Mamhead EX6 8HX Exeter | British | 1472550001 | ||||||||||
| KENNEDY, Fraser James | Geschäftsführer | Unit 16 Manor Court Business Park YO11 3TU Scarborough 1st Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 121610350003 | |||||||||
| ROBERTSON, Neil Kenneth | Geschäftsführer | Unit 16 Manor Court Business Park YO11 3TU Scarborough 1st Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 158937210001 | |||||||||
| SHEPHERD, Marcus Owen | Geschäftsführer | 64 Clarence Road TW11 0BW Teddington Middx | United Kingdom | British | 41925000003 | |||||||||
| SLIPPER, Andrew Martin | Geschäftsführer | 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House North Yorkshire | England | British | 8512670001 | |||||||||
| SNOOK, Garvis David | Geschäftsführer | 20 Hirst Court 20 Gatliff Road SW1W 8QD London | British | 70647210002 | ||||||||||
| TANDY, Didier Michel | Geschäftsführer | 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House North Yorkshire | England | British | 69909950001 | |||||||||
| TREACY, Claire | Geschäftsführer | Unit 16 Manor Court Business Park YO11 3TU Scarborough 1st Floor United Kingdom | United Kingdom | Irish | 189529610001 | |||||||||
| EUROPA DIRECTOR LIMITED | Geschäftsführer | Europa House 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough North Yorkshire | 102560510001 | |||||||||||
| OVAL NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 2 Temple Back East Temple Quay BS1 6EG Bristol | 900002560001 | |||||||||||
| TEESLAND SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Geschäftsführer | 93 George Street EH2 3ES Edinburgh | 90707230001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei D.U.K.E. PROPERTIES (MARSH MILLS) LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
|---|---|---|---|
| Mr Robin Baird | 27. Jan. 2017 | Castle Street St Helier JE4 5UT Jersey 13 Jersey | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: Jersey | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Mr Philip Lawrence Turpin | 27. Jan. 2017 | Castle Street St Helier JE4 5UT Jersey 13 Jersey | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: Jersey | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für D.U.K.E. PROPERTIES (MARSH MILLS) LIMITED?
| Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
|---|---|---|
| 26. Jan. 2017 | 27. Jan. 2017 | Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es keine registrierungspflichtige Person oder registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen gibt. |
Hat D.U.K.E. PROPERTIES (MARSH MILLS) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Supplemental legal mortgage | Erstellt am 27. Apr. 2012 Geliefert am 03. Mai 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H 91 st modwen road, plymouth t/no DN190498;. With all buildings, fixtures and fixed plant and machinery at any time thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 22. März 2012 Geliefert am 30. März 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of accession and charge | Erstellt am 28. Aug. 2009 Geliefert am 11. Sept. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the charging company’s and any other chargor’s indebtedness to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All land in england and wales,all its rights at the accession deed date,all trade debts and other debts see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 28. Dez. 2007 Geliefert am 05. Jan. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Block j marsh mills plymouth devon t/no DN190498. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. Dez. 2007 Geliefert am 05. Jan. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage deed | Erstellt am 29. Jan. 2004 Geliefert am 10. Feb. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/a block j, marsh mills, plymouth, devon, t/n dn 190498. together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat D.U.K.E. PROPERTIES (MARSH MILLS) LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0