DAISY CORPORATE SERVICES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | DAISY CORPORATE SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04166889 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von DAISY CORPORATE SERVICES LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich DAISY CORPORATE SERVICES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Lindred House 20 Lindred Road Brierfield BB9 5SR Nelson |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von DAISY CORPORATE SERVICES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| DAMOVO UK LIMITED | 29. Aug. 2001 | 29. Aug. 2001 |
| ERICSSON ENTERPRISES LIMITED | 24. Apr. 2001 | 24. Apr. 2001 |
| ENTERPRISE SOLUTIONS UK LIMITED | 29. März 2001 | 29. März 2001 |
| LEATHERBROOK LIMITED | 23. Feb. 2001 | 23. Feb. 2001 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DAISY CORPORATE SERVICES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2022 |
Welche sind die letzten Einreichungen für DAISY CORPORATE SERVICES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Stephen Alan Smith als Geschäftsführer am 31. Juli 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Feb. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2022 | 6 Seiten | AA | ||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse Dwf Company Secretarial Services Limited 1 Scott Place 2 Hardman Street Manchester M3 3AA verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||
Die Adresse der Registerinspektion wurde auf Dwf Company Secretarial Services Limited 1 Scott Place 2 Hardman Street Manchester M3 3AA geändert | 1 Seiten | AD02 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Feb. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr David Lewis Mcglennon am 30. Nov. 2021 | 2 Seiten | CH01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2021 | 6 Seiten | AA | ||
Ernennung von Mr Neil Philip Thompson als Direktor am 12. Nov. 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2020 | 7 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Feb. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Feb. 2020 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2019 | 31 Seiten | AA | ||
Notification of Daisy Telecoms Limited as a person with significant control on 28. März 2019 | 2 Seiten | PSC02 | ||
Cessation of Daisy Intermediate Holdings Limited as a person with significant control on 28. März 2019 | 1 Seiten | PSC07 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Daisy House Lindred Road Business Park Nelson BB9 5SR zum Lindred House 20 Lindred Road Brierfield Nelson BB9 5SR am 29. Apr. 2019 | 1 Seiten | AD01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Feb. 2019 mit Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Beendigung der Bestellung von David Lewis Mcglennon als Sekretär am 01. Feb. 2019 | 1 Seiten | TM02 | ||
Beendigung der Bestellung von Nathan Richard Marke als Geschäftsführer am 01. Feb. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2018 | 36 Seiten | AA | ||
Ernennung von Mr David Lewis Mcglennon als Direktor am 22. Juni 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von DAISY CORPORATE SERVICES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCGLENNON, David Lewis | Geschäftsführer | 20 Lindred Road Brierfield BB9 5SR Nelson Lindred House | United Kingdom | British | 181536600002 | |||||
| THOMPSON, Neil Philip | Geschäftsführer | 20 Lindred Road Brierfield BB9 5SR Nelson Lindred House | England | British | 158049040002 | |||||
| BOOTH, Rachel Sarah | Sekretär | 91 Harrison Road EH11 1LS Edinburgh | British | 43448790001 | ||||||
| CHASSER, Brian Armstrong | Sekretär | 2 Manor Drive Cuckfield RH17 5BT Haywards Heath West Sussex | British | 19630950001 | ||||||
| DANNEAU, Frederick George | Sekretär | Houghton Road Maidenbower RH10 7JL Crawley 7 West Sussex United Kindgom | English | 118948010001 | ||||||
| GRIGG, Alfred Patrick | Sekretär | 2 Bridge Court Southey Road Wimbledon SW19 1PH London | Australian | 98444040003 | ||||||
| LANDER, Clinton John | Sekretär | Queens Gardens W2 3AF London Flat 1, 53 United Kingdom | 154266070001 | |||||||
| MCGLENNON, David Lewis | Sekretär | Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Daisy House England | 195325290001 | |||||||
| PRESCOTT, William Anthony | Sekretär | 8 Blackbridge Lane RH12 1RP Horsham West Sussex | British | 76135270001 | ||||||
| WALKER, Sarah Louise | Sekretär | 66 Radnor Road KT13 8JU Weybridge Surrey | British | 87254370001 | ||||||
| CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 10 Upper Bank Street E14 5JJ London | 900005620001 | |||||||
| BISSETT, Graeme | Geschäftsführer | 123 Saint Vincent Street G2 5EA Glasgow | British | 79800380001 | ||||||
| BOYLE, Joseph Anthony | Geschäftsführer | 12 Huntly Avenue G46 6LW Glasgow | Scotland | British | 96947560001 | |||||
| BUTCHER, Paul Russell | Geschäftsführer | Clifton Heights Horsham Road RH4 2DS Dorking 13 Surrey England | United Kingdom | British | 134724030001 | |||||
| CHASSER, Brian Armstrong | Geschäftsführer | 2 Manor Drive Cuckfield RH17 5BT Haywards Heath West Sussex | British | 19630950001 | ||||||
| CONTRERAS, Robert Leonard | Geschäftsführer | 9 Thorp Arch Park LS23 7AP Wetherby West Yorkshire | United Kingdom | British | 93499270001 | |||||
| COOK, Ian Michael | Geschäftsführer | Pudds Orchard Long Lane HP3 0NE Bovingdon Hertfordshire | United Kingdom | British | 93834540001 | |||||
| DANNEAU, Frederick George | Geschäftsführer | Houghton Road Maidenbower RH10 7JL Crawley 7 West Sussex United Kindgom | England | English | 118948010001 | |||||
| DEAN, Nicholas Timothy | Geschäftsführer | Wheelers Farm House Nutbean Lane RG7 1XL Swallowfield Berkshire | England | British | 156979080001 | |||||
| DENMARK, Stephen Charles | Geschäftsführer | Derry Cottage Malthouse Lane GU3 3PS Guildford Surrey | British | 92624190001 | ||||||
| DOAK, Bryan | Geschäftsführer | Hunter Crescent KA10 7AH Troon 69 Ayrshire | United Kingdom | British | 111233190001 | |||||
| FITZGERALD, David James | Geschäftsführer | Beechwood House RH12 4SD Faygate West Sussex | Irish | 75198210003 | ||||||
| FLYNN, Pearse | Geschäftsführer | Greystones Houston Road PA13 4NY Kilmacolm Renfrewshire | Irish | 75749140001 | ||||||
| GILLESPIE, Graham Richard William | Geschäftsführer | Broadlands Business Park Langhurstwood Road RH12 4QP Horsham West Sussex | United Kingdom | British | 161312160002 | |||||
| GRIGGS, Gavin Peter | Geschäftsführer | Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Daisy House | England | British | 154536120001 | |||||
| LANDER, Clinton John | Geschäftsführer | Flat 1 53 Queens Gardens W23AF London | United Kingdom | Australian | 116986510002 | |||||
| LAYTON, Matthew Robert | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Flat 49 8 New Crane Wharf New Crane Place E1W 3TX London | British | 900019870001 | ||||||
| MARKE, Nathan Richard | Geschäftsführer | Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Daisy House England | United Kingdom | British | 194292450001 | |||||
| MCKEIGUE, David Joseph | Geschäftsführer | 1 Highwaymans Ridge GU20 6JY Windlesham Surrey | British | 97676570002 | ||||||
| MULLER, Neil Keith | Geschäftsführer | Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Daisy House England | England | British | 252490400001 | |||||
| PAYNE, Simon David | Geschäftsführer | Broadlands Business Park Langhurstwood Road RH12 4QP Horsham West Sussex | United Kingdom | British | 163190690001 | |||||
| RENUCCI, Paolo Giovanni Amato | Geschäftsführer | Lucys Lodge Cedar Drive SL6 9DZ Cookham Berkshire | United Kingdom | British | 87406170003 | |||||
| RICHARDS, Martin Edgar | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 89 Thurleigh Road SW12 8TY London | British | 900002870001 | ||||||
| RILEY, Matthew Robinson | Geschäftsführer | Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Daisy House England | United Kingdom | British | 178585250001 | |||||
| SMITH, Jonathan | Geschäftsführer | Holly Tree Cottage Broome Hall, Coldharbour RH5 6HJ Dorking Surrey | England | British | 65159060002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei DAISY CORPORATE SERVICES LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daisy Telecoms Limited | 28. März 2019 | 20 Lindred Road Brierfield BB9 5SR Nelson Lindred House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Daisy Intermediate Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Daisy House Lancashire England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat DAISY CORPORATE SERVICES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 11. Jan. 2007 Geliefert am 25. Jan. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any obligor to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge of deposit | Erstellt am 08. Feb. 2006 Geliefert am 23. Feb. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The deposit initially of £150,000 credited to account designation 20038480 with the bank and any addition to that deposit and any deposit from time to time of any other currency description or designation which derives in whole or in part from or out of such initial deposit or account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 11. Juni 2004 Geliefert am 30. Juni 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any obligor to the lenders (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security assignment | Erstellt am 20. Dez. 2001 Geliefert am 09. Jan. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The company charges to ing by way of a fixed charge all the apparatus (as such term is defined in the assignment) the subject of the relevant msa;. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 04. Mai 2001 Geliefert am 19. Mai 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally and whether as principal or surety or in any capacity whatsoever) of the assignor or any obligor to the secured creditors (or any of them) under or in relation to any one or more of the senior finance documents and/or the mezzanine finance documents all terms as defined | |
Kurze Angaben The real property telecommunication centre ericsson way burgess hill west sussex RH15 9UB licensed,building 2,kelburn court birchwood warrington,cheshire WA3 6JA licensed,unit 4 chessington industrial estate lion park avenue chessington surrey KT9 1ST licensed for further details of the property charged please refer to the form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0