ECOGANIX LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ECOGANIX LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04169467 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ECOGANIX LIMITED?
- Sanierungsmaßnahmen und andere Abfallwirtschaftsdienste (39000) / Wasserversorgung; Abwasserentsorgung, Abfallwirtschaft und Behebung von Umweltverschmutzungen
- Umweltberatungsaktivitäten (74901) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich ECOGANIX LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Portland House Belmont Business Park DH1 1TW Durham England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ECOGANIX LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ENVAR LIMITED | 28. Feb. 2001 | 28. Feb. 2001 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ECOGANIX LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ECOGANIX LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Beendigung der Liquidation | 1 Seiten | L64.07 | ||
Mitteilung über den Abschluss des freiwilligen Vergleichs | 8 Seiten | CVA4 | ||
Gerichtsbeschluss zur Liquidation | 3 Seiten | COCOMP | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Supervisors des freiwilligen Vergleichs bis 30. Sept. 2019 | 17 Seiten | CVA3 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom PO Box 60 PO Box 60 Barnard Castle DL12 2BL United Kingdom zum Portland House Belmont Business Park Durham DH1 1TW am 12. Feb. 2019 | 1 Seiten | AD01 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Ecoganix Worcester Depot Throckmorton Trials and Industrial Park Long Lane Throckmorton Worcestershire WR10 2JH United Kingdom zum PO Box 60 PO Box 60 Barnard Castle DL12 2BL am 11. Feb. 2019 | 1 Seiten | AD01 | ||
Erfüllung der Belastung 041694670005 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2018 | 9 Seiten | AA | ||
Mitteilung an den Unternehmensregister über den Inkrafttreten des freiwilligen Vergleichs | 5 Seiten | CVA1 | ||
Eintragung der Belastung 041694670006, erstellt am 09. Okt. 2018 | 25 Seiten | MR01 | ||
Ernennung von Mrs Pamela Julie Ready als Direktor am 13. Sept. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von James Adam Peat als Geschäftsführer am 13. Sept. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2017 | 8 Seiten | AA | ||
Beendigung der Bestellung von Thomlinson Kiddle Associates Limited als Sekretär am 19. Apr. 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||
Beendigung der Bestellung von Pamela Julie Ready als Geschäftsführer am 04. Apr. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||
Notification of Schosween 42 Limited as a person with significant control on 04. Apr. 2018 | 2 Seiten | PSC02 | ||
Cessation of Winterhall Commercial Limited as a person with significant control on 04. Apr. 2018 | 1 Seiten | PSC07 | ||
Ernennung von Mr James Adam Peat als Direktor am 04. Apr. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Ecoganix Worcester Depot Throckmorton Trials and Industrial Park Long Lane Throckmorton Worcestershire W10 2JH England zum Ecoganix Worcester Depot Throckmorton Trials and Industrial Park Long Lane Throckmorton Worcestershire WR10 2JH am 26. März 2018 | 1 Seiten | AD01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. Feb. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 9 Ingmanthorpe Hall Montagu Lane Wetherby West Yorkshire LS22 5EH England zum Ecoganix Worcester Depot Throckmorton Trials and Industrial Park Long Lane Throckmorton Worcestershire W10 2JH am 15. März 2018 | 1 Seiten | AD01 | ||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2016 | 16 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. Feb. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||
Ernennung von Thomlinson Kiddle Associates Limited als Sekretär am 01. Feb. 2017 | 2 Seiten | AP04 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von ECOGANIX LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| READY, Arthur John William | Geschäftsführer | Belmont Business Park DH1 1TW Durham Portland House England | England | British | 157245120001 | |||||||||||||
| READY, Pamela Julie | Geschäftsführer | Belmont Business Park DH1 1TW Durham Portland House England | England | British | 159382690002 | |||||||||||||
| CLARKE, Michael James | Sekretär | Pendeford Business Park Pendeford WV9 5AP Wolverhampton Pendeford House England | British | 154594640001 | ||||||||||||||
| DANIELS, Patricia Ann | Sekretär | Ingmanthorpe Hall Montagu Lane LS22 5EH Wetherby 2 West Yorkshire England | 179956700001 | |||||||||||||||
| MAWBY, Trevor John Charles | Sekretär | 18 Luard Road CB2 2PJ Cambridge Cambridgeshire | British | 1793510001 | ||||||||||||||
| PALMER, Tony John | Sekretär | Starsmere Wichenford WR6 6YY Worcester Worcestershire | British | 42430240002 | ||||||||||||||
| COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 | |||||||||||||||
| THOMLINSON KIDDLE ASSOCIATES LIMITED | Sekretär | Hampton-On-The-Hill CV35 8QR Warwick 4 England |
| 224158880001 | ||||||||||||||
| BURWOOD, Stephen Alan | Geschäftsführer | Montagu Lane LS22 5EH Wetherby 9 Ingmanthorpe Hall West Yorkshire England | England | British | 142855310001 | |||||||||||||
| CLARKE, Michael James | Geschäftsführer | Ingmanthorpe Hall Montagu Lane LS22 5EH Wetherby 10 West Yorkshire England | England | British | 154591790014 | |||||||||||||
| COLLIER, Stephen Howard | Geschäftsführer | Lindum The Green OX17 3NE Adderbury Oxfordshire | United Kingdom | British | 42290550002 | |||||||||||||
| CORNS, David Andrew | Geschäftsführer | Ingmanthorpe Hall Montagu Lane LS22 5EH Wetherby 10 West Yorkshire England | England | British | 97574340001 | |||||||||||||
| DANIELS, Patricia Ann | Geschäftsführer | Ingmanthorpe Hall Montagu Lane LS22 5EH Wetherby 2 West Yorkshire England | England | British | 142855320001 | |||||||||||||
| DOBLE, Simon James | Geschäftsführer | Appledore Oxenton GL52 9SE Cheltenham Gloucestershire | England | British | 120672080001 | |||||||||||||
| ELLIOTT, William | Geschäftsführer | 20 Eliot Close GU15 1LW Camberley Surrey | United Kingdom | British | 62232390002 | |||||||||||||
| HALL, David John Logan | Geschäftsführer | Sandicroft Wonham Way Peaslake GU5 9PA Guildford Surrey | British | 52254100001 | ||||||||||||||
| PALMER, Tony John | Geschäftsführer | Starsmere Wichenford WR6 6YY Worcester Worcestershire | England | British | 42430240002 | |||||||||||||
| PEAT, James Adam | Geschäftsführer | Throckmorton Trials And Industrial Park Long Lane WR10 2JH Throckmorton Ecoganix Worcester Depot Worcestershire United Kingdom | Spain | British | 245574010001 | |||||||||||||
| READY, Pamela Julie | Geschäftsführer | Throckmorton Trials And Industrial Park Long Lane WR10 2JH Throckmorton Ecoganix Worcester Depot Worcestershire United Kingdom | England | British | 159382690001 | |||||||||||||
| SPELLER, Colin Stuart | Geschäftsführer | Ingmanthorpe Hall Montagu Lane LS22 5EH Wetherby 10 West Yorkshire England | England | British | 84519850001 | |||||||||||||
| COMBINED NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NA London | 900000090001 | |||||||||||||||
| COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ECOGANIX LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schosween 42 Limited | 04. Apr. 2018 | Tickton HU17 9RX Beverley Tickton Hall England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Winterhall Commercial Limited | 06. Apr. 2016 | Ingmanthorpe Hall Montagu Lane LS22 5EH Wetherby 9 West Yorkshire England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat ECOGANIX LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 09. Okt. 2018 Geliefert am 09. Okt. 2018 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung By way of first legal mortgage, all land (as defined below) belonging to the company at the date of the debenture including without limitation that described in part 1 of schedule 2 to the debenture (a copy of which schedule is attached to this form MR01 ).. in the debenture “land” means all estates and other interests in freehold, leasehold or other immovable property (wherever situated) or in which the company has an interest and:-. (I) all buildings and fixtures (including trade fixtures but not including tenant’s fixtures) and fixed plant and machinery at any time thereon;. (Ii) all easements, rights and agreements in respect of such property;. (Iii) all proceeds of sale of such property; and. The benefit of all covenants given in respect of such property. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 12. Dez. 2014 Geliefert am 12. Dez. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 03. Sept. 2013 Geliefert am 04. Sept. 2013 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 02. Jan. 2009 Geliefert am 06. Jan. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 16. Dez. 2008 Geliefert am 24. Dez. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 18. Apr. 2005 Geliefert am 20. Apr. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat ECOGANIX LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Freiwillige Unternehmenssanierung (CVA) |
| ||||||||||||||||||||||
| 2 |
| Zwangsliquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0