SIMON CARVES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSIMON CARVES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04169897
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von SIMON CARVES LIMITED?

    • (7487) /

    Wo befindet sich SIMON CARVES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Floor 8, Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von SIMON CARVES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    SEMBCORP SIMON-CARVES LIMITED18. Feb. 200218. Feb. 2002
    SIMON-CARVES LIMITED29. Mai 200129. Mai 2001
    PRECIS (1999) LIMITED28. Feb. 200128. Feb. 2001

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SIMON CARVES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für SIMON CARVES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    23 SeitenLIQ14

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 18. Dez. 2019

    21 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 18. Dez. 2018

    20 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 18. Dez. 2017

    19 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 18. Dez. 2017

    19 SeitenLIQ03

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 7 More London Riverside London SE1 2RT zum Floor 8, Central Square 29 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4DL am 11. Okt. 2017

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Insolvenzgerichtsbeschluss

    Court order insolvency:court order - removal/replacement of liquidator
    10 SeitenLIQ MISC OC

    Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator

    1 Seiten4.40

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 18. Dez. 2016

    17 Seiten4.68

    Insolvenzmeldung

    Insolvency:secretary of state certificate of release of liquidator
    1 SeitenLIQ MISC

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Insolvenzgerichtsbeschluss

    Court order insolvency:court order replacement/removal of liquidator
    10 SeitenLIQ MISC OC

    Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator

    1 Seiten4.40

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 18. Dez. 2015

    10 Seiten4.68

    Beendigung der Bestellung von Sanjay Goel als Geschäftsführer am 02. Juni 2015

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Luv Chhabra als Geschäftsführer am 20. Mai 2015

    2 SeitenTM01

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 18. Dez. 2014

    10 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 18. Dez. 2013

    10 Seiten4.68

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    3 SeitenF10.2

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 19. Dez. 2012

    18 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 06. Juni 2012

    16 Seiten2.24B

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    1 Seiten2.34B

    Wer sind die Geschäftsführer von SIMON CARVES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SANGHA, Balbir
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Floor 8, Central Square
    West Yorkshire
    Sekretär
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Floor 8, Central Square
    West Yorkshire
    155955870001
    PUNJ, Atul
    10, Prithvi Raj Road
    FOREIGN New Delhi
    110011
    India
    Geschäftsführer
    10, Prithvi Raj Road
    FOREIGN New Delhi
    110011
    India
    IndiaIndianDirector114685720001
    HOLLOWAY, Mark Adrian
    79 Cassiobury Drive
    WD1 3AG Watford
    Hertfordshire
    Sekretär
    79 Cassiobury Drive
    WD1 3AG Watford
    Hertfordshire
    British60953190001
    HOON, Linda Siew Kin
    32a Duchess Walk
    Singapore
    FOREIGN 268946
    Sekretär
    32a Duchess Walk
    Singapore
    FOREIGN 268946
    SingaporeanGroup Company Secretary62846590001
    JOHNSTON, David Alan
    31 Cheviot Close
    Ramsbottom
    BL0 9LL Bury
    Lancashire
    Sekretär
    31 Cheviot Close
    Ramsbottom
    BL0 9LL Bury
    Lancashire
    BritishCompany Secretary63219320001
    LIM LI LI, Cheryl
    56k Kings Road
    S (288120)
    Singapore
    Sekretär
    56k Kings Road
    S (288120)
    Singapore
    SingaporeanIn -House Counsel114774230001
    LOW, Meng Wai
    26 Dover Crescent 15-61
    FOREIGN Singapore
    Singapore
    Sekretär
    26 Dover Crescent 15-61
    FOREIGN Singapore
    Singapore
    British80682390001
    OOI WEI HSIN, Jonathan
    Blk 412a Fernvale Link Apartment
    08-21
    FOREIGN Singapore
    S (791412)
    Sekretär
    Blk 412a Fernvale Link Apartment
    08-21
    FOREIGN Singapore
    S (791412)
    SingaporeanIn House Counsel113770310001
    WALSH, Darren Jon
    18 Hope Place
    L1 9BG Liverpool
    Merseyside
    Sekretär
    18 Hope Place
    L1 9BG Liverpool
    Merseyside
    BritishSolicitor119984180001
    YANG, Chia Wei
    243 Bukit Panjang Ring Road
    06-175 Singapore
    670243
    Singapore
    Sekretär
    243 Bukit Panjang Ring Road
    06-175 Singapore
    670243
    Singapore
    SingaporeanAsst Legal Manager95235900001
    OFFICE ORGANIZATION & SERVICES LIMITED
    Level 1 Exchange House
    Primrose Stret
    EC2A 2HS London
    Bevollmächtigter Sekretär
    Level 1 Exchange House
    Primrose Stret
    EC2A 2HS London
    900019420001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BHATTACHARYA, Kiriti Madhav
    Sandhurst Drive
    SK9 2GP Wilmslow
    2
    Cheshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Sandhurst Drive
    SK9 2GP Wilmslow
    2
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomIndianEngineer151682690001
    BOWDEN, Alwyn Keith
    244 Southport Road
    Scarisbrick
    PR8 5LF Southport
    Merseyside
    Geschäftsführer
    244 Southport Road
    Scarisbrick
    PR8 5LF Southport
    Merseyside
    BritishCompany Director76196540001
    CATT, Richard John
    Avenings School Lane
    RH17 7JE Danehill
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Avenings School Lane
    RH17 7JE Danehill
    West Sussex
    EnglandBritishLawyer1367810004
    CHAIN, Shau Woo Paul
    14-A Hua Guan Avenue
    FOREIGN Singapore
    589112
    Geschäftsführer
    14-A Hua Guan Avenue
    FOREIGN Singapore
    589112
    Singapore CitizenPresident76196650001
    CHHABRA, Luv
    H-16/4, Dlf City
    Phrase-I,
    Gurgaon
    Haryana 122002
    India
    Geschäftsführer
    H-16/4, Dlf City
    Phrase-I,
    Gurgaon
    Haryana 122002
    India
    IndiaIndianDirector149395790001
    CHHABRA, Luv
    H-16/4, Dlf City
    Phrase-I,
    Gurgaon
    Haryana 122002
    India
    Geschäftsführer
    H-16/4, Dlf City
    Phrase-I,
    Gurgaon
    Haryana 122002
    India
    IndiaIndianDirector149395790001
    GARG, Sandeep
    D-173 Ist Floor
    Narmada Apts
    Alaknanda
    New Delhi 110019
    India
    Geschäftsführer
    D-173 Ist Floor
    Narmada Apts
    Alaknanda
    New Delhi 110019
    India
    IndiaIndianDirector139368850001
    GOEL, Sanjay
    House No.3, Birch Court,
    Nirvana Country,
    South City-2
    Gurgaon 122 018
    India
    Geschäftsführer
    House No.3, Birch Court,
    Nirvana Country,
    South City-2
    Gurgaon 122 018
    India
    IndiaIndianEngineer127946230001
    GUPTA, Pawan Kumar
    Laburnum
    Sushant Lok Phase I
    Gurgaon
    126
    Haryana 122002
    India
    Geschäftsführer
    Laburnum
    Sushant Lok Phase I
    Gurgaon
    126
    Haryana 122002
    India
    IndianDirector134283380001
    HENRY, Keith Nicholas
    Amberwood Court
    Warreners Lane
    KT13 0LQ Weybridge
    Surrey
    Geschäftsführer
    Amberwood Court
    Warreners Lane
    KT13 0LQ Weybridge
    Surrey
    EnglandBritishEngineer802560006
    HO, Kiam Kheong
    41 Sandhurst Drive
    SK9 2GP Wilmslow
    Cheshire
    Geschäftsführer
    41 Sandhurst Drive
    SK9 2GP Wilmslow
    Cheshire
    SingaporeEngineer97669860001
    HO, Nee Sin
    No 4 Chuan Close
    FOREIGN Singapore
    554879
    Singapore
    Geschäftsführer
    No 4 Chuan Close
    FOREIGN Singapore
    554879
    Singapore
    SingaporeSingaporeanSenior Vice President172498180002
    KAUSHIK, Vimal Kishore
    S-27/1-D, Dlf Qutab Enclave
    Phase-111
    Gurgaon
    Haryana 122002
    India
    Geschäftsführer
    S-27/1-D, Dlf Qutab Enclave
    Phase-111
    Gurgaon
    Haryana 122002
    India
    IndianDirector114685780001
    LEGGETT, Mark Richard
    11 Strawberry How
    Strawberry How Road
    CA13 9XZ Cockermouth
    Cumbria
    Geschäftsführer
    11 Strawberry How
    Strawberry How Road
    CA13 9XZ Cockermouth
    Cumbria
    United KingdomBritishDirector118607310001
    MAY, John Stephen, Mr.
    12 Hall Hill
    SK10 5ED Bollington
    Cheshire
    Geschäftsführer
    12 Hall Hill
    SK10 5ED Bollington
    Cheshire
    United KingdomBritishAccountant171198380001
    NOLAN, Niall Joseph
    14 Savona Close
    Wimbledon
    SW19 4HT London
    Geschäftsführer
    14 Savona Close
    Wimbledon
    SW19 4HT London
    United KingdomIrishAccountant114924350001
    POH KOK, David Neo
    41 Mimosa Terrace
    FOREIGN Singapore
    805739
    Geschäftsführer
    41 Mimosa Terrace
    FOREIGN Singapore
    805739
    SingaporeSr Vp Finance Admin76196590001
    PUNJ, Atul
    10, Prithvi Raj Road
    FOREIGN New Delhi
    110011
    India
    Geschäftsführer
    10, Prithvi Raj Road
    FOREIGN New Delhi
    110011
    India
    IndiaIndianDirector114685720001
    REDBURN, Timothy John
    Little Abbotts Snower Hill Road
    RH3 7AQ Betchworth
    Surrey
    Geschäftsführer
    Little Abbotts Snower Hill Road
    RH3 7AQ Betchworth
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director22018030002
    THAM, Kok Peng
    34 Brighton Crescent
    FOREIGN Singapore
    559185
    Geschäftsführer
    34 Brighton Crescent
    FOREIGN Singapore
    559185
    SingaporeanExecutive Vice President84725700001
    VANDREVALA, Phiroz Adi
    Prithvi Raj Road
    FOREIGN New Delhi
    23
    110 003
    India
    Geschäftsführer
    Prithvi Raj Road
    FOREIGN New Delhi
    23
    110 003
    India
    IndiaIndianExecutive Director107226910002
    WALTMAIER, Brian
    10 Betchworth Way
    SK10 2PA Macclesfield
    Cheshire
    Geschäftsführer
    10 Betchworth Way
    SK10 2PA Macclesfield
    Cheshire
    BritishEngineer97670230001
    WONG, Heang Fine
    23 Faber Drive
    129353
    Singapore
    Geschäftsführer
    23 Faber Drive
    129353
    Singapore
    SingaporeanPresident & Ceo85679160001

    Hat SIMON CARVES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 01. Feb. 2011
    Geliefert am 09. Feb. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Punj Lloyd Pte LTD
    Transaktionen
    • 09. Feb. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Deed of assignment
    Erstellt am 03. Jan. 2008
    Geliefert am 04. Jan. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All book debts and other debts, all insurances. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Icici Bank UK PLC
    Transaktionen
    • 04. Jan. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment
    Erstellt am 03. Jan. 2008
    Geliefert am 04. Jan. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Book debts and other debts, all insurances. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bank
    Transaktionen
    • 04. Jan. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 03. Jan. 2008
    Geliefert am 04. Jan. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts, buildings, fixtures, fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bank
    Transaktionen
    • 04. Jan. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment
    Erstellt am 03. Jan. 2008
    Geliefert am 04. Jan. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All book debts and other debts, all insu. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Trading as Rabobank International),Singapore Branch
    Transaktionen
    • 04. Jan. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Feb. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 03. Jan. 2008
    Geliefert am 04. Jan. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts, buildings, fixtures, fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Trading as Rabobank International),Singapore Branch
    Transaktionen
    • 04. Jan. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Feb. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 29. Nov. 2006
    Geliefert am 18. Dez. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the plant machinery, fixtures and fittings, furniture, goodwill, uncalled capital, debts and credit balances. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Icici Bank UK Limited
    Transaktionen
    • 18. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Mai 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of charge
    Erstellt am 18. Okt. 2004
    Geliefert am 27. Okt. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge the deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Tenam Sal
    Transaktionen
    • 27. Okt. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Dez. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 28. Aug. 2001
    Geliefert am 30. Aug. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Aug. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Dez. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat SIMON CARVES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    07. Juli 2011Beginn der Verwaltung
    19. Dez. 2012Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Zelf Hussain
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praktiker
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Robert Jonathan Hunt
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praktiker
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    David James Kelly
    101 Barbirolli Square
    Lower Mosley Street
    M2 3PW Manchester
    Praktiker
    101 Barbirolli Square
    Lower Mosley Street
    M2 3PW Manchester
    2
    DatumTyp
    19. Dez. 2012Beginn der Liquidation
    24. Juli 2020Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Zelf Hussain
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praktiker
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Robert Jonathan Hunt
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praktiker
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Roger Gareth Hale
    One Kingsway
    CF10 3PW Cardiff
    Praktiker
    One Kingsway
    CF10 3PW Cardiff
    Ross David Connock
    2 Glass Wharf
    BS2 0EL Bristol
    Avon
    Praktiker
    2 Glass Wharf
    BS2 0EL Bristol
    Avon

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0