ED STONE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ED STONE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04170969 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ED STONE LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich ED STONE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Media House Bartley Wood Business Park RG27 9UP Hook Hampshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ED STONE LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| CHELTRADING 299 LIMITED | 01. März 2001 | 01. März 2001 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ED STONE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2014 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für ED STONE LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für ED STONE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 30. Dez. 2015
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 08. Dez. 2015
| 3 Seiten | SH01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 1 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
legacy | 94 Seiten | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE1 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. März 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 92 Seiten | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE1 | ||||||||||
Ernennung von Mine Ozkan Hifzi als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Caroline Withers als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. März 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Robert Dominic Dunn als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Robert Gale als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE1 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Caroline Bernadette Elizabeth Withers am 14. März 2013 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. März 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ED STONE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMES, Gillian Elizabeth | Sekretär | Bartley Wood Business Park RG27 9UP Hook Media House Hampshire | 151021030001 | |||||||
| DUNN, Robert Dominic | Geschäftsführer | Bartley Wood Business Park RG27 9UP Hook Media House Hampshire | England | British | 179134020002 | |||||
| HIFZI, Mine Ozkan | Geschäftsführer | Bartley Wood Business Park RG27 9UP Hook Media House Hampshire | England | British | 182167230001 | |||||
| BURNS, Clive | Sekretär | The Cottage Lamer Hill Gate Lower Gustard Wood AL4 8RX Wheathampstead Hertfordshire | British | 71073800001 | ||||||
| QUADRANGLE SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 95 The Promenade GL50 1WG Cheltenham Gloucestershire | 84239630001 | |||||||
| VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 160 Great Portland Street W1W 5QA London | 101107380002 | |||||||
| BURDICK, Charles James | Geschäftsführer | 9 Ormonde Place SW1W 8HX London | British-American | 52311710004 | ||||||
| GALE, Robert Charles | Geschäftsführer | Bartley Wood Business Park RG27 9UP Hook Media House Hampshire | England | British | 96956740001 | |||||
| LUIZ, Mark Walter | Geschäftsführer | 165 Cranley Gardens N10 3AE London | British | 37860010002 | ||||||
| MACKENZIE, Robert Mario | Geschäftsführer | Great Portland Street W1W 5QA London 160 London United Kingdom | United Kingdom | British | 47785600002 | |||||
| OPIE, Lisa Moreen | Geschäftsführer | 6 Millfield HP4 2PB Berkhamsted Hertfordshire | United Kingdom | British | 88563310001 | |||||
| SMITH, Neil Reynolds | Geschäftsführer | Brettwood Green Lane Churt GU10 2PA Farnham Surrey | British | 79956240002 | ||||||
| STENHAM, Anthony William Paul | Geschäftsführer | 4 The Grove Highgate N6 6JU London | British | 8281170001 | ||||||
| TILLBROOK, Joanne Christine | Geschäftsführer | Bartley Wood Business Park RG27 9UP Hook Media House Hampshire | United Kingdom | British | 164134250001 | |||||
| TILLBROOK, Joanne Christine | Geschäftsführer | Bartley Wood Business Park RG27 9UP Hook Media House Hampshire | United Kingdom | British | 164134250001 | |||||
| TILLBROOK, Joanne Christine | Geschäftsführer | Bartley Wood Business Park RG27 9UP Hook Media House Hampshire | United Kingdom | British | 164134250001 | |||||
| WALL, Malcolm Robert | Geschäftsführer | The Close 2 Longfield Drive East Sheen SW14 7AU London | England | British | 178772080002 | |||||
| WITHERS, Caroline Bernadette Elizabeth | Geschäftsführer | Bartley Wood Business Park RG27 9UP Hook Media House Hampshire | United Kingdom | British | 140137570002 | |||||
| STOORNE INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 95 The Promenade GL50 1WG Cheltenham Gloucestershire | 900002940001 | |||||||
| STOORNE SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 95 The Promenade GL50 1WG Cheltenham Gloucestershire | 900002930001 | |||||||
| VIRGIN MEDIA DIRECTORS LIMITED | Geschäftsführer | 160 Great Portland Street W1W 5QA London | 101107430002 | |||||||
| VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED | Geschäftsführer | 160 Great Portland Street W1W 5QA London | 101107380002 |
Hat ED STONE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Composite debenture | Erstellt am 29. Juni 2010 Geliefert am 08. Juli 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due to the chargee, all monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and all monies due or to become due from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Confirmation deed | Erstellt am 15. Apr. 2010 Geliefert am 04. Mai 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) on any account whatosover under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The chargor acknowledges and agrees to the new sfa and the transactions contemplated thereby and confirm all payment and performance obligations contingent or otherwise and undertakings arising under or in connection with its respective agreements, guarantees, pledges and grants of encumbrances under and subject to the terms of the group intercreditor agreement and each security document to which it is party. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite debenture | Erstellt am 19. Jan. 2010 Geliefert am 22. Jan. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due to the chargee from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite debenture | Erstellt am 19. Jan. 2010 Geliefert am 22. Jan. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due to the chargee from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite debenture | Erstellt am 03. März 2006 Geliefert am 10. März 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due to the chargee, from the obligors (or any one or more of them) to the finance parties (or any one or more of them) on any account whatsoever, from all or any of the obligors to the restructuring swap counterparties and/or the existing hedge counter parties and to the new hedge counterparties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite debenture | Erstellt am 10. Mai 2005 Geliefert am 18. Mai 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any of the chargors to the beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of deposit and charge on cash deposit | Erstellt am 12. Dez. 2002 Geliefert am 19. Dez. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All sums from time to time standing to the credit of the deposit account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0