BLUE GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | BLUE GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 04171692 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BLUE GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED?
- Aktivitäten von Zeitarbeitsagenturen (78200) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich BLUE GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O Dickson Minto W.S Level 13, Broadgate Tower 20 Primrose Street EC2A 2EW London United Kingdom |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von BLUE GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
BLUE GROUP INTERNATIONAL HOLDING LIMITED | 30. Jan. 2003 | 30. Jan. 2003 |
BLUE GROUP INTERNATIONAL LIMITED | 25. Juli 2002 | 25. Juli 2002 |
MEGAMODE HOLDINGS LIMITED | 08. März 2001 | 08. März 2001 |
ANGLOBRIDGE LIMITED | 02. März 2001 | 02. März 2001 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BLUE GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 01. Jan. 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BLUE GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 7 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 6 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Juli 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Healthcare Locums Ltd 10 Old Bailey London EC4M 7NG England zum C/O Dickson Minto W.S Level 13, Broadgate Tower 20 Primrose Street London EC2A 2EW am 31. Aug. 2018 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 041716920007 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 041716920008 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Peter David Sullivan als Geschäftsführer am 30. Juni 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 01. Jan. 2017 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 53 Seiten | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT2 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Juli 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 03. Jan. 2016 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 53 Seiten | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | AGREEMENT2 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Juli 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ian Malcolm Ketchin als Geschäftsführer am 27. Apr. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Michael Anthony Warren als Direktor am 27. Apr. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O C/O Healthcare Locums Plc 10 Old Bailey London EC4M 7NG zum C/O Healthcare Locums Ltd 10 Old Bailey London EC4M 7NG am 28. Apr. 2016 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 28. Dez. 2014 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von BLUE GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURKE, Stephen Philip | Geschäftsführer | Level 13, Broadgate Tower 20 Primrose Street EC2A 2EW London C/O Dickson Minto W.S United Kingdom | United Kingdom | British | Group Ceo | 163884030001 | ||||||||
WARREN, Michael Anthony | Geschäftsführer | Level 13, Broadgate Tower 20 Primrose Street EC2A 2EW London C/O Dickson Minto W.S United Kingdom | England | British | Cfo | 207605900001 | ||||||||
HUGHES, Martin | Sekretär | c/o C/O Healthcare Locums Plc Old Bailey EC4M 7NG London 10 | 153438760001 | |||||||||||
JARVIS, Diane | Sekretär | Tudor Cottage Ranks Green CM3 2BG Fairstead Essex | British | Director | 79818790001 | |||||||||
SEGEL, Stephen Mark | Sekretär | 70 Pine Gardens KT5 8LH Surbiton Surrey | British | 30391560004 | ||||||||||
CHALFEN SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 3rd Floor 19 Phipp Street EC2A 4NP London | 900013320001 | |||||||||||
MH SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Staples Court 11 Staple Inn Buildings WC1V 7QH London | 39754020001 | |||||||||||
BLEASDALE, Kathleen Veronica | Geschäftsführer | The Cedars 3 Telegraph Cottage Warren Road KT2 7HU Kingston Upon Thames Surrey | United Kingdom | British | Director | 67650680001 | ||||||||
BRETT, Edward James Timothy | Geschäftsführer | 19 Holland Street W8 4NA London | England | British | Banker | 71229370002 | ||||||||
BROMWICH, Paul Jonathon | Geschäftsführer | 16 Lower Village Hornbeams RH16 4GT Haywards Heath | British | Director | 75466760002 | |||||||||
BYGRAVE, Susan Jane | Geschäftsführer | c/o C/O Healthcare Locums Plc Old Bailey EC4M 7NG London 10 | United Kingdom | British | Chief Financial Officer | 114989650001 | ||||||||
CHITTENDEN, Paul John | Geschäftsführer | 22 The Lyons East Street TN9 1DQ Tonbridge Kent | United Kingdom | British | Director | 78789920005 | ||||||||
GLUCKLICH, Thomas Charles | Geschäftsführer | Mill House Mill Lane ME9 7TD Hartlip Kent | British | Consultant | 35568290002 | |||||||||
HENDERSON, Robert David Charles | Geschäftsführer | Old Bailey EC4M 7NG London 10 | United Kingdom | British | Senior Non-Executive Director | 43565270004 | ||||||||
HEPBURN, Carole | Geschäftsführer | 8 Hesper Mews SW5 0HH London | British | Operations Director | 117956110001 | |||||||||
HUME, Christopher John | Geschäftsführer | 3 Alexander Mews CM12 9AD Billericay Essex | United Kingdom | British | Recruitment Consultant | 124969310001 | ||||||||
JARVIS, Diane | Geschäftsführer | c/o C/O Healthcare Locums Plc Old Bailey EC4M 7NG London 10 | United Kingdom | British | Director | 153221320003 | ||||||||
JESSUP, William | Geschäftsführer | c/o C/O Healthcare Locums Plc Old Bailey EC4M 7NG London 10 | England | British | Group Ceo | 43937890001 | ||||||||
JESSUP, William | Geschäftsführer | Slade House Hinwick NN29 7JB Wellingborough Northamptonshire | England | British | Accountant | 43937890001 | ||||||||
KAR, Simon | Geschäftsführer | Flat 1 100 Crystal Palace Park Road SE26 6UP London | British | Business Development Director | 74905700001 | |||||||||
KETCHIN, Ian Malcolm | Geschäftsführer | c/o Healthcare Locums Ltd Old Bailey EC4M 7NG London 10 England | England | British | Fd | 93777900002 | ||||||||
LAWRENCE, Kenneth William | Geschäftsführer | 4 The Headway KT17 1UJ Ewell Surrey | United Kingdom | British | Venture Capitalist | 40388380001 | ||||||||
MCPHERSON, Daniel Andre | Geschäftsführer | Wapping Wall E1W 3TH London Flat 7 Great Jubilee Wharf 78 | England | British | Manager | 131658250001 | ||||||||
MCRAE, Andrew James | Geschäftsführer | 20 Manor Court Road W7 3EL London | England | British | Director | 2890800003 | ||||||||
PENGE, Dino | Geschäftsführer | Oakdene Axes Lane RH1 5QL Outwood Surrey | British | Recruitment Consultant | 67002060007 | |||||||||
RICHES, David Charles | Geschäftsführer | c/o C/O Healthcare Locums Plc Old Bailey EC4M 7NG London 10 | United Kingdom | British | Group Financial Controller | 35182670002 | ||||||||
SEGEL, Stephen Mark | Geschäftsführer | 70 Pine Gardens KT5 8LH Surbiton Surrey | United Kingdom | British | Finance Director | 30391560004 | ||||||||
SULLIVAN, Peter David | Geschäftsführer | Old Bailey EC4M 7NG London 10 United Kingdom | United Kingdom | Australian | Company Director | 159131570001 | ||||||||
ZAFAR, John | Geschäftsführer | 712 Point West 116 Cromwell Road SW7 4XH London | British | Company Director | 75761110005 | |||||||||
CAREER PLUS OPTIONS LIMITED | Geschäftsführer | Old Bailey EC4M 7NG London 10 United Kingdom |
| 146224070001 | ||||||||||
CHALFEN NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 3rd Floor 19 Phipp Street EC2A 4NP London | 900013310001 | |||||||||||
MH DIRECTORS LIMITED | Geschäftsführer | 12 Great James Street WC1N 3DR London | 40574860001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei BLUE GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angel Acquisitions Limited | 06. Apr. 2016 | Old Bailey EC4M 7NG London 10 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat BLUE GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 15. Juni 2015 Geliefert am 18. Juni 2015 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 15. Juni 2015 Geliefert am 18. Juni 2015 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 17. Dez. 2010 Geliefert am 30. Dez. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the security trustee and the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
All assets debenture | Erstellt am 18. Aug. 2010 Geliefert am 26. Aug. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 18. Aug. 2010 Geliefert am 26. Aug. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any one or more of the principals to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 18. Aug. 2010 Geliefert am 26. Aug. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Group debenture | Erstellt am 20. Apr. 2007 Geliefert am 04. Mai 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each present or future charging company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 09. Apr. 2001 Geliefert am 17. Apr. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat BLUE GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0