REMOTE PROPERTIES 2200 (B) LIMITED

REMOTE PROPERTIES 2200 (B) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameREMOTE PROPERTIES 2200 (B) LIMITED
    UnternehmensstatusVerwalter bestellt
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04171884
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von REMOTE PROPERTIES 2200 (B) LIMITED?

    • (7011) /

    Wo befindet sich REMOTE PROPERTIES 2200 (B) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von REMOTE PROPERTIES 2200 (B) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    INHOCO 2274 LIMITED02. März 200102. März 2001

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von REMOTE PROPERTIES 2200 (B) LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am28. Feb. 2011
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am30. Nov. 2011
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis28. Feb. 2010

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für REMOTE PROPERTIES 2200 (B) LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis02. März 2017
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung16. März 2017
    ÜberfälligJa

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für REMOTE PROPERTIES 2200 (B) LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss
    ÜberfälligJa

    Welche sind die letzten Einreichungen für REMOTE PROPERTIES 2200 (B) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    legacy

    3 SeitenLQ01

    legacy

    2 SeitenLQ02

    Beendigung der Bestellung von Valad Secretarial Services Limited als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Valsec Director Limited als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Christian Bearman als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    legacy

    3 SeitenLQ01

    Jahresrückblick erstellt bis 02. März 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital07. März 2011

    Kapitalaufstellung am 07. März 2011

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Valad Secretarial Services Limited am 09. Dez. 2010

    3 SeitenCH04

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 28. Feb. 2010

    7 SeitenAA

    Änderung der Details des Sekretärs für Valad Secretarial Services Limited am 16. Sept. 2010

    3 SeitenCH04

    Jahresrückblick erstellt bis 02. März 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Valsec Director Limited am 02. März 2010

    2 SeitenCH02

    Änderung der Details des Sekretärs für Valad Secretarial Services Limited am 02. März 2010

    2 SeitenCH04

    Ernennung von Mr Christian James Alexander Bearman als Direktor

    3 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von James Maddy als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Ernennung von James Edward Maddy als Direktor

    3 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Didier Tandy als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Änderung der Details des Direktors für Didier Michel Tandy am 22. Okt. 2009

    3 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Didier Michel Tandy am 22. Okt. 2009

    3 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Didier Michel Tandy am 07. Okt. 2009

    3 SeitenCH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 28. Feb. 2009

    7 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    9 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    6 Seiten288a

    Wer sind die Geschäftsführer von REMOTE PROPERTIES 2200 (B) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    DI CIACCA, Cesidio Martin
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    Sekretär
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    British1267050001
    MCCABE, Sandra
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    The White House
    North Yorkshire
    Sekretär
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    The White House
    North Yorkshire
    British920260005
    NAIK, Varsha
    14 Brearley Close
    Pavilion Way
    HA8 9YT Edgware
    Middlesex
    Sekretär
    14 Brearley Close
    Pavilion Way
    HA8 9YT Edgware
    Middlesex
    BritishGroup Financial Controller101693390001
    A B & C SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Bevollmächtigter Sekretär
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006570001
    VALAD SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    3 Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    1st Floor Exchange Place 3
    United Kingdom
    Sekretär
    3 Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    1st Floor Exchange Place 3
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    RegistrierungsnummerSC219311
    133355520001
    BEARMAN, Christian James Alexander
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    EnglandBritishChief Operating Officer-Europe110436370002
    CORLETT, Robert John
    102 Deacon Road
    KT2 6LU Kingston Upon Thames
    Surrey
    Geschäftsführer
    102 Deacon Road
    KT2 6LU Kingston Upon Thames
    Surrey
    EnglandBritishChartered Surveyor72399980002
    GILMAN, Peter John
    The Sashes
    Holgate Lane Boston Spa
    LS23 6BN Wetherby
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    The Sashes
    Holgate Lane Boston Spa
    LS23 6BN Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director35528040001
    LIGHTBODY, Bruce Robson
    148 Almsford Drive
    HG2 8EE Harrogate
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    148 Almsford Drive
    HG2 8EE Harrogate
    North Yorkshire
    BritishSolicitor75214270001
    MADDY, James Edward
    Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House 20
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House 20
    North Yorkshire
    United KingdomBritishChartered Accountant137459000001
    MCBRIDE, Stephen Paul
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    United KingdomBritishFinancial Controller56953000002
    MCCABE, Kevin Charles
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    BritishChartered Surveyor109250000001
    OLIVER, Paul Francis
    Curlew House 58 Grove Park Gardens
    Chiswick
    W4 3RZ London
    Geschäftsführer
    Curlew House 58 Grove Park Gardens
    Chiswick
    W4 3RZ London
    United KingdomBritishChief Executive14735150002
    SHEPHERD, Marcus Owen
    64 Clarence Road
    TW11 0BW Teddington
    Middx
    Geschäftsführer
    64 Clarence Road
    TW11 0BW Teddington
    Middx
    United KingdomBritishChartered Accountant41925000003
    TANDY, Didier Michel
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    EnglandBritishChartered Surveyor69909950001
    TANDY, Didier Michel
    9 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    Geschäftsführer
    9 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    EnglandBritishChartered Surveyor69909950001
    TUTTON, Jeremy John
    31 Chester Way
    Kennington
    SE11 4UR London
    Geschäftsführer
    31 Chester Way
    Kennington
    SE11 4UR London
    BritishFinancial Controller100816670001
    INHOCO FORMATIONS LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006560001
    VALSEC DIRECTOR LIMITED
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    England
    Geschäftsführer
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    England
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer5307786
    102622300002

    Hat REMOTE PROPERTIES 2200 (B) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Composite debenture and guarantee
    Erstellt am 28. Juni 2006
    Geliefert am 12. Juli 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company the chargors and each of them to the finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The l/h property at plot 1175 thorpe park leeds t/n WYK734083, part of plot 1250 thorpe park leeds t/n WYK691297, plot 2100 thorpe park leeds t/n WYK691298, for details of further properties charged, please refer to form 395, fixed and floating charges over all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Capmark Bank Europe PLC (Security Trustee)
    Transaktionen
    • 12. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 127. Mai 2011Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (LQ01)
    • 115. März 2013Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (LQ02)
    • 115. März 2013Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (LQ01)
      • Aktenzeichen 1
    Debenture
    Erstellt am 10. Apr. 2003
    Geliefert am 11. Apr. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any chargor to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 07. März 2003
    Geliefert am 17. März 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or become due from any chargor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 17. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 31. März 2001
    Geliefert am 10. Apr. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company formerly known as remote properties 2200 (b) limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Plot 1250 thorpe park leeds. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 10. Apr. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 31. März 2001
    Geliefert am 10. Apr. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company formerly known as remote properties 2200 (b) limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 10. Apr. 2001Registrierung einer Belastung (395)

    Hat REMOTE PROPERTIES 2200 (B) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Hugh Lawrence Dorins
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    Receiver Manager
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    Robert Stokely
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    Receiver Manager
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    Colin Richard Jennings
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    Receiver Manager
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0