REMOTE PROPERTIES 2200 (B) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | REMOTE PROPERTIES 2200 (B) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Verwalter bestellt |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 04171884 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von REMOTE PROPERTIES 2200 (B) LIMITED?
- (7011) /
Wo befindet sich REMOTE PROPERTIES 2200 (B) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Europa House 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough North Yorkshire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von REMOTE PROPERTIES 2200 (B) LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
INHOCO 2274 LIMITED | 02. März 2001 | 02. März 2001 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von REMOTE PROPERTIES 2200 (B) LIMITED?
Überfällig | Ja |
---|---|
Nächster Jahresabschluss | |
Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 28. Feb. 2011 |
Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Nov. 2011 |
Letzter Jahresabschluss | |
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 28. Feb. 2010 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für REMOTE PROPERTIES 2200 (B) LIMITED?
Überfällig | Ja |
---|---|
Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 02. März 2017 |
Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 16. März 2017 |
Überfällig | Ja |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für REMOTE PROPERTIES 2200 (B) LIMITED?
Jahresabschluss |
|
---|
Welche sind die letzten Einreichungen für REMOTE PROPERTIES 2200 (B) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
legacy | 3 Seiten | LQ01 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | LQ02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Valad Secretarial Services Limited als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Valsec Director Limited als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christian Bearman als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | LQ01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. März 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Valad Secretarial Services Limited am 09. Dez. 2010 | 3 Seiten | CH04 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 28. Feb. 2010 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Valad Secretarial Services Limited am 16. Sept. 2010 | 3 Seiten | CH04 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. März 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Valsec Director Limited am 02. März 2010 | 2 Seiten | CH02 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Valad Secretarial Services Limited am 02. März 2010 | 2 Seiten | CH04 | ||||||||||
Ernennung von Mr Christian James Alexander Bearman als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von James Maddy als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von James Edward Maddy als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Didier Tandy als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Didier Michel Tandy am 22. Okt. 2009 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Didier Michel Tandy am 22. Okt. 2009 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Didier Michel Tandy am 07. Okt. 2009 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 28. Feb. 2009 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 9 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 6 Seiten | 288a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von REMOTE PROPERTIES 2200 (B) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DI CIACCA, Cesidio Martin | Sekretär | 45 Blairston Avenue G71 8SA Bothwell Lanarkshire | British | 1267050001 | ||||||||||
MCCABE, Sandra | Sekretär | 13 Deepdale Avenue YO11 2UQ Scarborough The White House North Yorkshire | British | 920260005 | ||||||||||
NAIK, Varsha | Sekretär | 14 Brearley Close Pavilion Way HA8 9YT Edgware Middlesex | British | Group Financial Controller | 101693390001 | |||||||||
A B & C SECRETARIAL LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 900006570001 | |||||||||||
VALAD SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Sekretär | 3 Semple Street EH3 8BL Edinburgh 1st Floor Exchange Place 3 United Kingdom |
| 133355520001 | ||||||||||
BEARMAN, Christian James Alexander | Geschäftsführer | 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House North Yorkshire | England | British | Chief Operating Officer-Europe | 110436370002 | ||||||||
CORLETT, Robert John | Geschäftsführer | 102 Deacon Road KT2 6LU Kingston Upon Thames Surrey | England | British | Chartered Surveyor | 72399980002 | ||||||||
GILMAN, Peter John | Geschäftsführer | The Sashes Holgate Lane Boston Spa LS23 6BN Wetherby West Yorkshire | England | British | Company Director | 35528040001 | ||||||||
LIGHTBODY, Bruce Robson | Geschäftsführer | 148 Almsford Drive HG2 8EE Harrogate North Yorkshire | British | Solicitor | 75214270001 | |||||||||
MADDY, James Edward | Geschäftsführer | Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House 20 North Yorkshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 137459000001 | ||||||||
MCBRIDE, Stephen Paul | Geschäftsführer | Gryffe Main Street Upper Poppleton YO26 6EL York North Yorkshire | United Kingdom | British | Financial Controller | 56953000002 | ||||||||
MCCABE, Kevin Charles | Geschäftsführer | The White House 13 Deepdale Avenue YO11 2UQ Scarborough North Yorkshire | British | Chartered Surveyor | 109250000001 | |||||||||
OLIVER, Paul Francis | Geschäftsführer | Curlew House 58 Grove Park Gardens Chiswick W4 3RZ London | United Kingdom | British | Chief Executive | 14735150002 | ||||||||
SHEPHERD, Marcus Owen | Geschäftsführer | 64 Clarence Road TW11 0BW Teddington Middx | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 41925000003 | ||||||||
TANDY, Didier Michel | Geschäftsführer | 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House North Yorkshire | England | British | Chartered Surveyor | 69909950001 | ||||||||
TANDY, Didier Michel | Geschäftsführer | 9 Warrington Crescent W9 1ED London | England | British | Chartered Surveyor | 69909950001 | ||||||||
TUTTON, Jeremy John | Geschäftsführer | 31 Chester Way Kennington SE11 4UR London | British | Financial Controller | 100816670001 | |||||||||
INHOCO FORMATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 900006560001 | |||||||||||
VALSEC DIRECTOR LIMITED | Geschäftsführer | 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House North Yorkshire England |
| 102622300002 |
Hat REMOTE PROPERTIES 2200 (B) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Composite debenture and guarantee | Erstellt am 28. Juni 2006 Geliefert am 12. Juli 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company the chargors and each of them to the finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The l/h property at plot 1175 thorpe park leeds t/n WYK734083, part of plot 1250 thorpe park leeds t/n WYK691297, plot 2100 thorpe park leeds t/n WYK691298, for details of further properties charged, please refer to form 395, fixed and floating charges over all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| ||||
Debenture | Erstellt am 10. Apr. 2003 Geliefert am 11. Apr. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any chargor to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 07. März 2003 Geliefert am 17. März 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or become due from any chargor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 31. März 2001 Geliefert am 10. Apr. 2001 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company formerly known as remote properties 2200 (b) limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Plot 1250 thorpe park leeds. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 31. März 2001 Geliefert am 10. Apr. 2001 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company formerly known as remote properties 2200 (b) limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat REMOTE PROPERTIES 2200 (B) LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Receiver/Manager bestellt |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0