BMGL REALISATIONS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | BMGL REALISATIONS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 04172055 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BMGL REALISATIONS LIMITED?
- Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich BMGL REALISATIONS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Kpmg Llp 8 Salisbury Square EC4Y 8BB London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von BMGL REALISATIONS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
BON MARCHE GROUP LIMITED | 05. März 2001 | 05. März 2001 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BMGL REALISATIONS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 03. Apr. 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BMGL REALISATIONS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 7 Seiten | 4.72 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Capital Link Windsor Road Cardiff CF24 5NG Wales am 15. Nov. 2012 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 4.19 | 5 Seiten | 4.20 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. März 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Hinweis auf Namensänderung | 2 Seiten | CONNOT | ||||||||||
Ernennung von Mr Roy George Ellis als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Killick als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. März 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 03. Apr. 2010 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O the Peacock Group Atlantic House Tyndall Street Cardiff CF10 4PS am 31. Aug. 2010 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. März 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 28. März 2009 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 29. März 2008 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2007 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 |
Wer sind die Geschäftsführer von BMGL REALISATIONS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELLIS, Roy George | Sekretär | 57 St Lawrence Park NP16 6DP Chepstow Gwent | British | 116788900001 | ||||||
BURNS, Neil Anthony | Geschäftsführer | 8 Ffordd Gwern St. Fagans CF5 6PB Cardiff | Wales | British | Group Operations Director | 62596180004 | ||||
ELLIS, Roy George | Geschäftsführer | 8 Salisbury Square EC4Y 8BB London Kpmg Llp | Wales | British | Director | 161784490001 | ||||
KIRK, Richard Stanley, Mr. | Geschäftsführer | Palace Gardens Terrace W8 4RP London 34 United Kingdom | United Kingdom | British | Chief Executive | 54276260003 | ||||
FELLOWS, Jonathan | Sekretär | 26 Ladywood Road Four Oaks B74 2QN Sutton Coldfield West Midlands | British | Director Of Finance | 118296490001 | |||||
GREEN, Lynn Maria | Sekretär | 9 Wentworth Court HD6 3XD Brighouse West Yorkshire | British | 65529350001 | ||||||
KILLICK, Mike David | Sekretär | 1 Fryth Wood NP16 6DU Chepstow Newport | British | Group Financial Controller | 83828320001 | |||||
CHETTLEBURGHS SECRETARIAL LTD | Bevollmächtigter Sekretär | 20 Holywell Row EC2A 4XH London Temple House | 900021480001 | |||||||
ADVANI, Mark | Geschäftsführer | 15 Cotton Close Millers Quay DE13 7BF Alrewas Staffordshire | United Kingdom | British | Venture Capital | 86862950001 | ||||
BRYANT, Keith Ralph | Geschäftsführer | Claremont Tidenham NP16 7JF Chepstow | United Kingdom | British | Finance Director | 54831150003 | ||||
BULLAS, Steven Robert | Geschäftsführer | 87 Brockholes Lane, Brockholes HD9 7EB Holmfirth Rockleigh Yorkshire | England | British | Chief Executive | 96918430003 | ||||
CHIMA, Gurchait Singh | Geschäftsführer | Norwood View 29 Norwood Park HD2 2DU Huddersfield West Yorkshire | British | Director | 14031160001 | |||||
CHIMA, Gurnaik Singh | Geschäftsführer | Four Winds 61 Church Lane South Crosland HD4 7DD Huddersfield West Yorkshire | British | Director | 7655680001 | |||||
FELLOWS, Jonathan | Geschäftsführer | 26 Ladywood Road Four Oaks B74 2QN Sutton Coldfield West Midlands | England | British | Director Of Finance | 118296490001 | ||||
KILLICK, Michael David | Geschäftsführer | 1 Fryth Wood NP16 6DU Chepstow Monmouthshire | Wales | British | Director | 75927820002 | ||||
RUBIN, Janet Catherine Mary | Geschäftsführer | 11 Blakesley Avenue W5 2DN London | United Kingdom | British | Director | 50127880001 | ||||
TAYLOR CLAGUE, Albert Clive | Geschäftsführer | Swindon Hill Swindon Lane, Kirkby Overblow HG3 1HJ Harrogate North Yorkshire | British | Director | 83048220001 | |||||
WALKER, David Anthony | Geschäftsführer | The Knowles Grimescar Road Fixby HD2 2EB Huddersfield West Yorkshire | England | British | Accountant | 32549000002 | ||||
WILLIAMS, Ian Malcolm | Geschäftsführer | Victoria Springs HO9 2NB Holmfirth 16 West Yorkshire | United Kingdom | British | Retail Director | 129501260001 |
Hat BMGL REALISATIONS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 23. Jan. 2006 Geliefert am 31. Jan. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargors to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All right title and interest in the non-consent mortgaged property the additional property the tangible moveable property the accounts the intellectual property the charged intellectual property any goodwill and rights in relation to the uncalled capital the investments the shares and all dividends. By way of floating charge all assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 13. Aug. 2002 Geliefert am 15. Aug. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All obligations and liabilities due or to become due from each chargor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 06. Juli 2001 Geliefert am 18. Juli 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All money and liabilities now or hereafter due owing or incurred to the secured parties (or any of them) by the company and bon marche holdings limited, bon marche limited, hilton fashions limited and inhoco 336 limited in whatsoever manner | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A composite guarantee and debenture | Erstellt am 06. Juli 2001 Geliefert am 11. Juli 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies obligations and liabilities for the time being due owing or incurred by the company to the security trustee, the beneficiaries or any of them under or in connection with the loan note instrument and the guarantee and indemnity of each of the bon marche holdings limited, bon marche limited, inhoco 336 limited and hilton fashions limited as contained in the deed | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat BMGL REALISATIONS LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0