BMGL REALISATIONS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBMGL REALISATIONS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04172055
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BMGL REALISATIONS LIMITED?

    • Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen

    Wo befindet sich BMGL REALISATIONS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von BMGL REALISATIONS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    BON MARCHE GROUP LIMITED05. März 200105. März 2001

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BMGL REALISATIONS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis03. Apr. 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für BMGL REALISATIONS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    7 Seiten4.72

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Capital Link Windsor Road Cardiff CF24 5NG Wales am 15. Nov. 2012

    2 SeitenAD01

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    5 Seiten4.20

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren am 09. Nov. 2012

    LRESEX

    Jahresrückblick erstellt bis 05. März 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital02. Apr. 2012

    Kapitalaufstellung am 02. Apr. 2012

    • Kapital: GBP 50,000
    SH01

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 31. Jan. 2012

    RES15

    Hinweis auf Namensänderung

    2 SeitenCONNOT

    Ernennung von Mr Roy George Ellis als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Michael Killick als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 05. März 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 03. Apr. 2010

    7 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O the Peacock Group Atlantic House Tyndall Street Cardiff CF10 4PS am 31. Aug. 2010

    1 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 05. März 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 28. März 2009

    7 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 29. März 2008

    7 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    3 Seiten288a

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2007

    5 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten287

    Wer sind die Geschäftsführer von BMGL REALISATIONS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ELLIS, Roy George
    57 St Lawrence Park
    NP16 6DP Chepstow
    Gwent
    Sekretär
    57 St Lawrence Park
    NP16 6DP Chepstow
    Gwent
    British116788900001
    BURNS, Neil Anthony
    8 Ffordd Gwern
    St. Fagans
    CF5 6PB Cardiff
    Geschäftsführer
    8 Ffordd Gwern
    St. Fagans
    CF5 6PB Cardiff
    WalesBritishGroup Operations Director62596180004
    ELLIS, Roy George
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Kpmg Llp
    Geschäftsführer
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Kpmg Llp
    WalesBritishDirector161784490001
    KIRK, Richard Stanley, Mr.
    Palace Gardens Terrace
    W8 4RP London
    34
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Palace Gardens Terrace
    W8 4RP London
    34
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Executive54276260003
    FELLOWS, Jonathan
    26 Ladywood Road
    Four Oaks
    B74 2QN Sutton Coldfield
    West Midlands
    Sekretär
    26 Ladywood Road
    Four Oaks
    B74 2QN Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishDirector Of Finance118296490001
    GREEN, Lynn Maria
    9 Wentworth Court
    HD6 3XD Brighouse
    West Yorkshire
    Sekretär
    9 Wentworth Court
    HD6 3XD Brighouse
    West Yorkshire
    British65529350001
    KILLICK, Mike David
    1 Fryth Wood
    NP16 6DU Chepstow
    Newport
    Sekretär
    1 Fryth Wood
    NP16 6DU Chepstow
    Newport
    BritishGroup Financial Controller83828320001
    CHETTLEBURGHS SECRETARIAL LTD
    20 Holywell Row
    EC2A 4XH London
    Temple House
    Bevollmächtigter Sekretär
    20 Holywell Row
    EC2A 4XH London
    Temple House
    900021480001
    ADVANI, Mark
    15 Cotton Close
    Millers Quay
    DE13 7BF Alrewas
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    15 Cotton Close
    Millers Quay
    DE13 7BF Alrewas
    Staffordshire
    United KingdomBritishVenture Capital86862950001
    BRYANT, Keith Ralph
    Claremont
    Tidenham
    NP16 7JF Chepstow
    Geschäftsführer
    Claremont
    Tidenham
    NP16 7JF Chepstow
    United KingdomBritishFinance Director54831150003
    BULLAS, Steven Robert
    87
    Brockholes Lane, Brockholes
    HD9 7EB Holmfirth
    Rockleigh
    Yorkshire
    Geschäftsführer
    87
    Brockholes Lane, Brockholes
    HD9 7EB Holmfirth
    Rockleigh
    Yorkshire
    EnglandBritishChief Executive96918430003
    CHIMA, Gurchait Singh
    Norwood View 29 Norwood Park
    HD2 2DU Huddersfield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Norwood View 29 Norwood Park
    HD2 2DU Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishDirector14031160001
    CHIMA, Gurnaik Singh
    Four Winds 61 Church Lane
    South Crosland
    HD4 7DD Huddersfield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Four Winds 61 Church Lane
    South Crosland
    HD4 7DD Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishDirector7655680001
    FELLOWS, Jonathan
    26 Ladywood Road
    Four Oaks
    B74 2QN Sutton Coldfield
    West Midlands
    Geschäftsführer
    26 Ladywood Road
    Four Oaks
    B74 2QN Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritishDirector Of Finance118296490001
    KILLICK, Michael David
    1 Fryth Wood
    NP16 6DU Chepstow
    Monmouthshire
    Geschäftsführer
    1 Fryth Wood
    NP16 6DU Chepstow
    Monmouthshire
    WalesBritishDirector75927820002
    RUBIN, Janet Catherine Mary
    11 Blakesley Avenue
    W5 2DN London
    Geschäftsführer
    11 Blakesley Avenue
    W5 2DN London
    United KingdomBritishDirector50127880001
    TAYLOR CLAGUE, Albert Clive
    Swindon Hill
    Swindon Lane, Kirkby Overblow
    HG3 1HJ Harrogate
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Swindon Hill
    Swindon Lane, Kirkby Overblow
    HG3 1HJ Harrogate
    North Yorkshire
    BritishDirector83048220001
    WALKER, David Anthony
    The Knowles Grimescar Road
    Fixby
    HD2 2EB Huddersfield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    The Knowles Grimescar Road
    Fixby
    HD2 2EB Huddersfield
    West Yorkshire
    EnglandBritishAccountant32549000002
    WILLIAMS, Ian Malcolm
    Victoria Springs
    HO9 2NB Holmfirth
    16
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Victoria Springs
    HO9 2NB Holmfirth
    16
    West Yorkshire
    United KingdomBritishRetail Director129501260001

    Hat BMGL REALISATIONS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 23. Jan. 2006
    Geliefert am 31. Jan. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the chargors to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title and interest in the non-consent mortgaged property the additional property the tangible moveable property the accounts the intellectual property the charged intellectual property any goodwill and rights in relation to the uncalled capital the investments the shares and all dividends. By way of floating charge all assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Goldman Sachs Credit Partners L.P. as Security Trustees for and on Behalf of the Securedparties
    Transaktionen
    • 31. Jan. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 13. Aug. 2002
    Geliefert am 15. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations and liabilities due or to become due from each chargor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 06. Juli 2001
    Geliefert am 18. Juli 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All money and liabilities now or hereafter due owing or incurred to the secured parties (or any of them) by the company and bon marche holdings limited, bon marche limited, hilton fashions limited and inhoco 336 limited in whatsoever manner
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 18. Juli 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Aug. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A composite guarantee and debenture
    Erstellt am 06. Juli 2001
    Geliefert am 11. Juli 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies obligations and liabilities for the time being due owing or incurred by the company to the security trustee, the beneficiaries or any of them under or in connection with the loan note instrument and the guarantee and indemnity of each of the bon marche holdings limited, bon marche limited, inhoco 336 limited and hilton fashions limited as contained in the deed
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Four Winds Trust Whose Trustee is Orbis Trustees (Jersey) Limited
    Transaktionen
    • 11. Juli 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Aug. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat BMGL REALISATIONS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    09. Nov. 2012Beginn der Liquidation
    19. Feb. 2014Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    John David Thomas Milsom
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Jeremy Simon Spratt
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0