BRANDSPACE (WILMSLOW) LIMITED

BRANDSPACE (WILMSLOW) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBRANDSPACE (WILMSLOW) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04175866
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BRANDSPACE (WILMSLOW) LIMITED?

    • Medienvertretungsdienste (73120) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich BRANDSPACE (WILMSLOW) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von BRANDSPACE (WILMSLOW) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    PROMOTION SPACE LIMITED24. März 200324. März 2003
    CPL HOLDINGS LIMITED29. Aug. 200129. Aug. 2001
    PARTNERSHIPS@ LIMITED08. März 200108. März 2001

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BRANDSPACE (WILMSLOW) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für BRANDSPACE (WILMSLOW) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    18 SeitenLIQ14

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 27. März 2018

    16 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 27. März 2017

    12 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 27. März 2016

    12 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 27. März 2015

    11 Seiten4.68

    Insolvenzmeldung

    Insolvency:secretary of state release of liquidator
    1 SeitenLIQ MISC

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Insolvenzgerichtsbeschluss

    Court order insolvency:block transfer order - replacement of liquidator
    47 SeitenLIQ MISC OC

    Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator

    1 Seiten4.40

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 28. März 2014

    16 Seiten2.24B

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    1 Seiten2.34B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 04. Okt. 2013

    13 Seiten2.24B

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    1 SeitenF2.18

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    8 Seiten2.16B

    Vorschlag des Verwalters

    35 Seiten2.17B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 2Nd Floor Egginton House 25-28 Buckingham Gate London SW1E 6LD England* am 18. Apr. 2013

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 7Th Floor South Artillery House 11-19 Artillery Row London London SW1P 1RT England* am 27. März 2013

    1 SeitenAD01

    Ernennung von Ms Michelle De Young als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Paul Soanes als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Sean Fay als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Sandfield House Water Lane Wilmslow Cheshire SK9 5AR* am 13. Sept. 2012

    1 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 08. März 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital22. März 2012

    Kapitalaufstellung am 22. März 2012

    • Kapital: GBP 1,188.61
    SH01

    Wer sind die Geschäftsführer von BRANDSPACE (WILMSLOW) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    DE YOUNG, Michelle Anna-Lisa
    Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    150
    Geschäftsführer
    Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    150
    EnglandBritish140102770001
    HIGHAM, Robin Jeremy Charles
    46 Fernwood
    Marple Bridge
    SK6 5BE Stockport
    Cheshire
    Sekretär
    46 Fernwood
    Marple Bridge
    SK6 5BE Stockport
    Cheshire
    British22089740001
    LORD, Julian
    32 Fletcher Drive
    Disley
    SK12 2ND Stockport
    Cheshire
    Sekretär
    32 Fletcher Drive
    Disley
    SK12 2ND Stockport
    Cheshire
    British102300760001
    SOAR, Guy Jason
    40 Brookfield Avenue
    Timperley
    WA15 6TH Altrincham
    Cheshire
    Sekretär
    40 Brookfield Avenue
    Timperley
    WA15 6TH Altrincham
    Cheshire
    British96671300001
    SOAR, Guy Jason
    40 Brookfield Avenue
    Timperley
    WA15 6TH Altrincham
    Cheshire
    Sekretär
    40 Brookfield Avenue
    Timperley
    WA15 6TH Altrincham
    Cheshire
    British96671300001
    OCS CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    Minshull House
    67 Wellington Road North
    SK4 2LP Stockport
    Cheshire
    Sekretär
    Minshull House
    67 Wellington Road North
    SK4 2LP Stockport
    Cheshire
    71518050017
    COCKSHUTT, Diane
    2 Place Road
    WA14 4HH Altrincham
    Cheshire
    Geschäftsführer
    2 Place Road
    WA14 4HH Altrincham
    Cheshire
    British75151590001
    FAY, Sean Ernan
    Floor South Artillery House
    11-19 Artillery Row London
    SW1P 1RT London
    7th
    England
    Geschäftsführer
    Floor South Artillery House
    11-19 Artillery Row London
    SW1P 1RT London
    7th
    England
    United KingdomIrish84925400001
    FUSCO, Robert
    3 Blenheim Close
    SK9 2DN Wilmslow
    Cheshire
    Geschäftsführer
    3 Blenheim Close
    SK9 2DN Wilmslow
    Cheshire
    British105982320001
    HIGHAM, Robin Jeremy Charles
    46 Fernwood
    Marple Bridge
    SK6 5BE Stockport
    Cheshire
    Geschäftsführer
    46 Fernwood
    Marple Bridge
    SK6 5BE Stockport
    Cheshire
    UkBritish22089740001
    HIGHAM, Robin Jeremy Charles
    46 Fernwood
    Marple Bridge
    SK6 5BE Stockport
    Cheshire
    Geschäftsführer
    46 Fernwood
    Marple Bridge
    SK6 5BE Stockport
    Cheshire
    UkBritish22089740001
    HOWARD, Peter
    Lower Stone Ridge
    Green Lane, Disley
    SK12 2AL Stockport
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Lower Stone Ridge
    Green Lane, Disley
    SK12 2AL Stockport
    Cheshire
    United KingdomBritish77112140001
    HUGHES, Stephan Michael
    492 Hempshaw Lane
    SK2 5TL Stockport
    Cheshire
    Geschäftsführer
    492 Hempshaw Lane
    SK2 5TL Stockport
    Cheshire
    United KingdomBritish95176800002
    LORD, Julian
    32 Fletcher Drive
    Disley
    SK12 2ND Stockport
    Cheshire
    Geschäftsführer
    32 Fletcher Drive
    Disley
    SK12 2ND Stockport
    Cheshire
    EnglandBritish102300760001
    SOANES, Paul Henry
    Sparrow Row
    Chobham
    GU24 8TA Woking
    Woodside
    Surrey
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Sparrow Row
    Chobham
    GU24 8TA Woking
    Woodside
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish68377030007
    SOAR, Guy Jason
    Lime Grove
    Timperley
    WA15 6PJ Altrincham
    27
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Lime Grove
    Timperley
    WA15 6PJ Altrincham
    27
    Cheshire
    United KingdomBritish96671300002
    SOAR, Guy Jason
    40 Brookfield Avenue
    Timperley
    WA15 6TH Altrincham
    Cheshire
    Geschäftsführer
    40 Brookfield Avenue
    Timperley
    WA15 6TH Altrincham
    Cheshire
    British96671300001
    OCS DIRECTORS LIMITED
    Minshull House
    67 Wellington Road North
    SK4 2LP Stockport
    Cheshire
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Minshull House
    67 Wellington Road North
    SK4 2LP Stockport
    Cheshire
    900021490001

    Hat BRANDSPACE (WILMSLOW) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 30. Juni 2010
    Geliefert am 08. Juli 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to beocme due from any member of the group to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Octopus Capital for Enterprise Fund L.P.
    Transaktionen
    • 08. Juli 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Erstellt am 02. Nov. 2009
    Geliefert am 13. Nov. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Nov. 2009Registrierung einer Belastung (MG01)
    Composite guarantee and debentures
    Erstellt am 14. Juli 2009
    Geliefert am 31. Juli 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Octopus Investments Limited
    Transaktionen
    • 31. Juli 2009Registrierung einer Belastung (395)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Erstellt am 30. Apr. 2008
    Geliefert am 07. Mai 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Mai 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 30. Apr. 2008
    Geliefert am 07. Mai 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Mai 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 30. Apr. 2008
    Geliefert am 07. Mai 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Octopus Investments Limited as Security Trustee
    Transaktionen
    • 07. Mai 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 28. Nov. 2007
    Geliefert am 11. Dez. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Yorkshire Bank)
    Transaktionen
    • 11. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Mai 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 30. Apr. 2007
    Geliefert am 11. Mai 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Octopus Investments Limited (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 11. Mai 2007Registrierung einer Belastung (395)

    Hat BRANDSPACE (WILMSLOW) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    05. Apr. 2013Beginn der Verwaltung
    28. März 2014Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Jeremy Mark Willmont
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Praktiker
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Phillip Rodney Sykes
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Praktiker
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    2
    DatumTyp
    28. März 2014Beginn der Liquidation
    16. Jan. 2019Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Jeremy Mark Willmont
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Vorgeschlagener Liquidator
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Phillip Rodney Sykes
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Vorgeschlagener Liquidator
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Jeremy Mark Willmont
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Praktiker
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Phillip Rodney Sykes
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Praktiker
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Neville Side
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Praktiker
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0