PAYMENTSHIELD LIFE UNDERWRITING SERVICES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | PAYMENTSHIELD LIFE UNDERWRITING SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04179465 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PAYMENTSHIELD LIFE UNDERWRITING SERVICES LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich PAYMENTSHIELD LIFE UNDERWRITING SERVICES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Paymentshield House Wight Moss Way PR8 4HQ Southport Merseyside |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PAYMENTSHIELD LIFE UNDERWRITING SERVICES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für PAYMENTSHIELD LIFE UNDERWRITING SERVICES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. März 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Ms Diane Cougill als Direktor am 13. Nov. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Antonios Erotocritou als Geschäftsführer am 13. Nov. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 21 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. März 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||
Ernennung von Dean Clarke als Sekretär am 11. Dez. 2018 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Geoffrey Costerton Gouriet als Sekretär am 11. Dez. 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jacqueline Anne Gregory als Sekretär am 03. Aug. 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Mr Geoffrey Costerton Gouriet als Sekretär am 03. Aug. 2018 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. März 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Antonios Erotocritou als Direktor am 02. März 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Stephen Mugge als Geschäftsführer am 02. März 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. März 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr David Christopher Ross als Direktor am 20. Dez. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Jacqueline Anne Gregory als Sekretär am 20. Dez. 2016 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 26 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jennifer Owens als Sekretär am 01. März 2016 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. März 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Mark Stephen Mugge am 25. Nov. 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von PAYMENTSHIELD LIFE UNDERWRITING SERVICES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLARKE, Dean | Sekretär | Paymentshield House Wight Moss Way PR8 4HQ Southport Merseyside | 253940120001 | |||||||
| COUGILL, Diane | Geschäftsführer | Paymentshield House Wight Moss Way PR8 4HQ Southport Merseyside | United Kingdom | British | 158614590002 | |||||
| ROSS, David Christopher | Geschäftsführer | Paymentshield House Wight Moss Way PR8 4HQ Southport Merseyside | United Kingdom | Irish | 222326970001 | |||||
| CLARK, Samuel Thomas Budgen | Sekretär | Paymentshield House Wight Moss Way PR8 4HQ Southport Merseyside | 169016560001 | |||||||
| EVANS, Paul William John | Sekretär | 2 Stokes Hall Avenue Leyland PR25 3FA Preston Lancashire | British | 44044870002 | ||||||
| GIFFORD, Nicola | Sekretär | Paymentshield House Wight Moss Way PR8 4HQ Southport Merseyside | 147967520001 | |||||||
| GOURIET, Geoffrey Costerton | Sekretär | Paymentshield House Wight Moss Way PR8 4HQ Southport Merseyside | 249087400001 | |||||||
| GREGORY, Jacqueline Anne | Sekretär | Paymentshield House Wight Moss Way PR8 4HQ Southport Merseyside | 221912790001 | |||||||
| JOHNSTON, Graham Hamilton | Sekretär | 13 Glencairn Park Road GL50 2ND Cheltenham Gloucestershire | British | 120581050001 | ||||||
| OWENS, Jennifer | Sekretär | Paymentshield House Wight Moss Way PR8 4HQ Southport Merseyside | 183285330001 | |||||||
| POWELL, Vernon David | Sekretär | 18 Sunnybank Road Helmshore BB4 4PF Rossendale Lancashire | British | 65823910002 | ||||||
| FORM 10 SECRETARIES FD LTD | Bevollmächtigter Sekretär | 39a Leicester Road Salford M7 4AS Manchester Lancashire | 900014000001 | |||||||
| BOULGER, Graham | Geschäftsführer | 2 Church Gardens Euxton PR7 6LF Chorley Lancashire | United Kingdom | British | 85225620001 | |||||
| COTTRELL, Lee Michael | Geschäftsführer | 6 Old School Drive Longton PR4 5YU Preston Lancashire | British | 86782930002 | ||||||
| COTTRELL, Patricia | Geschäftsführer | 4 Longshaw Close Rufford L40 1XD Ormskirk Lancashire | British | 10934240003 | ||||||
| CULLUM, Peter Geoffrey | Geschäftsführer | Paymentshield House Wight Moss Way PR8 4HQ Southport Merseyside | England | British | 59873490009 | |||||
| DIXON, Richard John | Geschäftsführer | Paymentshield House Wight Moss Way PR8 4HQ Southport Merseyside | England | British | 109138230001 | |||||
| EGAN, Scott | Geschäftsführer | Paymentshield House Wight Moss Way PR8 4HQ Southport Merseyside | United Kingdom | British | 169209310001 | |||||
| EROTOCRITOU, Antonios | Geschäftsführer | Paymentshield House Wight Moss Way PR8 4HQ Southport Merseyside | United Kingdom | Cypriot | 167795710001 | |||||
| EVANS, Paul William John | Geschäftsführer | 2 Stokes Hall Avenue Leyland PR25 3FA Preston Lancashire | British | 44044870002 | ||||||
| GALJAARD, Neil Edward | Geschäftsführer | Paymentshield House Wight Moss Way PR8 4HQ Southport Merseyside | United Kingdom | British | 99083340001 | |||||
| HODGES, Mark Steven | Geschäftsführer | Paymentshield House Wight Moss Way PR8 4HQ Southport Merseyside | United Kingdom | British | 58444370003 | |||||
| JOHNSON, Timothy David | Geschäftsführer | Paymentshield House Wight Moss Way PR8 4HQ Southport Merseyside | England | British | 140206600001 | |||||
| JOHNSTON, Graham Hamilton | Geschäftsführer | 13 Glencairn Park Road GL50 2ND Cheltenham Gloucestershire | England | British | 120581050001 | |||||
| MACIVER, Kenneth | Geschäftsführer | The Poplars The Green TN12 8JS Horsmonden Kent | British | 70920700002 | ||||||
| MUGGE, Mark Stephen | Geschäftsführer | Paymentshield House Wight Moss Way PR8 4HQ Southport Merseyside | England | British | 162920630005 | |||||
| PATRICK, Ian William James | Geschäftsführer | Paymentshield House Wight Moss Way PR8 4HQ Southport Merseyside | United Kingdom | British | 75028400004 | |||||
| PENDER, Stuart Macpherson | Geschäftsführer | Paymentshield House Wight Moss Way PR8 4HQ Southport Merseyside | Scotland | British | 284879040001 | |||||
| POWELL, Vernon David | Geschäftsführer | 18 Sunnybank Road Helmshore BB4 4PF Rossendale Lancashire | England | British | 65823910002 | |||||
| RIDING, Gareth James | Geschäftsführer | 20 Springwood Drive Rufford L40 1XB Ormskirk Lancashire | England | British | 73696810003 | |||||
| RIDING, Michael Darren | Geschäftsführer | 6 Cherry Orchard Longridge PR3 3PQ Preston Lancashire | British | 72100570008 | ||||||
| RIDING, Richard | Geschäftsführer | 7 Longshaw Close Rufford L40 1XD Ormskirk Lancashire | British | 25438550004 | ||||||
| STONE, Ann Marie | Geschäftsführer | 7 Lismore Park Waterloo Road Birkdale PR8 2FY Southport Merseyside | British | 98890470001 | ||||||
| TRAYNOR, Christopher | Geschäftsführer | Burnside Gate ML3 6NP Hamilton 4 Lanarkshire | United Kingdom | British | 135054750001 | |||||
| FORM 10 DIRECTORS FD LTD | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 39a Leicester Road Salford M7 4AS Manchester Lancashire | 900013990001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei PAYMENTSHIELD LIFE UNDERWRITING SERVICES LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paymentshield Limited | 06. Apr. 2016 | Wight Moss Way PR8 4HQ Southport Paymentshield House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat PAYMENTSHIELD LIFE UNDERWRITING SERVICES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of accession to a debenture dated 1 november 2006 and | Erstellt am 29. Juni 2009 Geliefert am 13. Juli 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 27. Apr. 2009 Geliefert am 06. Mai 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 10. Dez. 2007 Geliefert am 21. Dez. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 08. Nov. 2006 Geliefert am 14. Nov. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any of the chargors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 08. Nov. 2006 Geliefert am 14. Nov. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any of the chargors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 13. Aug. 2004 Geliefert am 25. Aug. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0