HDG2018 LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameHDG2018 LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04180966
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von HDG2018 LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich HDG2018 LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Jupiter House Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Essex
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von HDG2018 LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    HALLMARK DEVELOPMENTS GROUP LIMITED18. Nov. 200818. Nov. 2008
    NEWPORT PROPERTIES LIMITED16. März 200116. März 2001

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HDG2018 LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Jan. 2020

    Welche sind die letzten Einreichungen für HDG2018 LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Beendigung der Bestellung von Norman Edward Ewen als Geschäftsführer am 18. Jan. 2022

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Norman Edward Ewen als Sekretär am 18. Jan. 2022

    1 SeitenTM02

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    19 SeitenLIQ14

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Geänderte Geschäftsanschrift vom The Barn Monument Offices Maldon Road Woodham Mortimer, Maldon Essex CM9 6SN zum Jupiter House Warley Hill Business Park the Drive Brentwood Essex CM13 3BE am 17. Mai 2021

    2 SeitenAD01

    Vermögensübersicht

    10 SeitenLIQ02

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren am 11. März 2021

    LRESEX

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Jan. 2020

    3 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr Stephen Derek Everington am 01. Juli 2020

    2 SeitenCH01

    Bestätigungserklärung erstellt am 16. März 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Jan. 2019

    2 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 16. März 2019 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Notification of Hallmark Developments (Essex) Ltd as a person with significant control on 04. Apr. 2018

    2 SeitenPSC02

    Notification of Hallmark Developments (Essex) Limited as a person with significant control on 04. Apr. 2018

    2 SeitenPSC02

    Cessation of Norman Edward Ewen as a person with significant control on 04. Apr. 2018

    1 SeitenPSC07

    Cessation of Stephen Derek Everington as a person with significant control on 04. Apr. 2018

    1 SeitenPSC07

    Beschlüsse

    Resolutions
    3 SeitenRESOLUTIONS
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name15. Aug. 2018

    Namensänderung durch Beschluss

    NM01
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 15. Aug. 2018

    RES15

    Eigenkapitalrückkauf.

    3 SeitenSH03

    Beendigung der Bestellung von Barry Andrew Brown als Geschäftsführer am 04. Apr. 2018

    1 SeitenTM01

    Cessation of Barry Andrew Brown as a person with significant control on 04. Apr. 2018

    1 SeitenPSC07

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Juli 2018 bis 31. Jan. 2019

    1 SeitenAA01

    Löschung von Aktien. Kapitalaufstellung am 04. Apr. 2018

    • Kapital: GBP 200
    4 SeitenSH06

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Juli 2017

    2 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 16. März 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Wer sind die Geschäftsführer von HDG2018 LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    EVERINGTON, Stephen Derek
    Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Jupiter House
    Essex
    Geschäftsführer
    Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Jupiter House
    Essex
    EnglandBritish89416910007
    EWEN, Norman Edward
    Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Jupiter House
    Essex
    Sekretär
    Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Jupiter House
    Essex
    British28027870003
    GILBERT, Paul William
    7 Parkway
    Gidea Park
    RM2 5NT Romford
    Essex
    Sekretär
    7 Parkway
    Gidea Park
    RM2 5NT Romford
    Essex
    British10393450001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Bevollmächtigter Sekretär
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    BROWN, Barry Andrew
    17 Park Rise
    AL5 3AP Harpenden
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    17 Park Rise
    AL5 3AP Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish81596280001
    EWEN, Norman Edward
    Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Jupiter House
    Essex
    Geschäftsführer
    Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Jupiter House
    Essex
    EnglandBritish28027870003
    GILBERT, Paul William
    7 Parkway
    Gidea Park
    RM2 5NT Romford
    Essex
    Geschäftsführer
    7 Parkway
    Gidea Park
    RM2 5NT Romford
    Essex
    EnglandBritish10393450001
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei HDG2018 LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Hallmark Developments (Essex) Limited
    Maldon Road
    Woodham Mortimer
    CM9 6SN Maldon
    The Barn, Monument Offices
    Essex
    England
    04. Apr. 2018
    Maldon Road
    Woodham Mortimer
    CM9 6SN Maldon
    The Barn, Monument Offices
    Essex
    England
    Nein
    RechtsformLimited Company
    RegistrierungslandEngland & Wales
    RechtsgrundlageCompanies Acts In England & Wales
    RegistrierungsortCompanies Register In England & Wales
    Registrierungsnummer04744551
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    Hallmark Developments (Essex) Ltd
    The Barn, Monument Offices, Maldon Road,
    Woodham Mortimer
    CM9 6SN Maldon
    The Barn
    Essex
    United Kingdom
    04. Apr. 2018
    The Barn, Monument Offices, Maldon Road,
    Woodham Mortimer
    CM9 6SN Maldon
    The Barn
    Essex
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited Company
    RegistrierungslandEngland & Wales
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortRegister Of Companies In England & Wales
    Registrierungsnummer04744551
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    Mr Stephen Derek Everington
    The Barn Monument Offices
    Maldon Road
    CM9 6SN Woodham Mortimer, Maldon
    Essex
    06. Apr. 2016
    The Barn Monument Offices
    Maldon Road
    CM9 6SN Woodham Mortimer, Maldon
    Essex
    Ja
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: England
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Anteile an der Gesellschaft.
    Mr Norman Edward Ewen
    The Barn Monument Offices
    Maldon Road
    CM9 6SN Woodham Mortimer, Maldon
    Essex
    06. Apr. 2016
    The Barn Monument Offices
    Maldon Road
    CM9 6SN Woodham Mortimer, Maldon
    Essex
    Ja
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: England
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Anteile an der Gesellschaft.
    Mr Barry Andrew Brown
    The Barn Monument Offices
    Maldon Road
    CM9 6SN Woodham Mortimer, Maldon
    Essex
    06. Apr. 2016
    The Barn Monument Offices
    Maldon Road
    CM9 6SN Woodham Mortimer, Maldon
    Essex
    Ja
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: England
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat HDG2018 LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of assignment of rental income
    Erstellt am 12. Juli 2010
    Geliefert am 15. Juli 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Rental income from shop unit 3 roche close rochford.
    Berechtigte Personen
    • Santander UK PLC
    Transaktionen
    • 15. Juli 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 06. Dez. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of assignment of rental income
    Erstellt am 12. Juli 2010
    Geliefert am 15. Juli 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Rental income from shop unit 2 roche close rochford.
    Berechtigte Personen
    • Santander UK PLC
    Transaktionen
    • 15. Juli 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 06. Dez. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of assignment of rental income
    Erstellt am 12. Juli 2010
    Geliefert am 15. Juli 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Rental income from shop unit 1 roche close rochford.
    Berechtigte Personen
    • Santander UK PLC
    Transaktionen
    • 15. Juli 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 06. Dez. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of assignment of rental income
    Erstellt am 12. Juli 2010
    Geliefert am 15. Juli 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Rental income from unit 1 block b roche close rochford.
    Berechtigte Personen
    • Santander UK PLC
    Transaktionen
    • 15. Juli 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 06. Dez. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of assignment of rental income
    Erstellt am 12. Juli 2010
    Geliefert am 15. Juli 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Rental income from unit 2 block b roche close rochford.
    Berechtigte Personen
    • Santander UK PLC
    Transaktionen
    • 15. Juli 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 06. Dez. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of assignment of rental income
    Erstellt am 12. Juli 2010
    Geliefert am 15. Juli 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Rental income from unit 3 block b roche close rochford.
    Berechtigte Personen
    • Santander UK PLC
    Transaktionen
    • 15. Juli 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 06. Dez. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal and general charge
    Erstellt am 12. Juli 2010
    Geliefert am 15. Juli 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H premises shop unit 3 roche close rochford (also k/a 7 roche close) all the company's uncalled capital for the time being and all its intellectual property rights and all other f/h and l/h property the company's stock in trade and plant all it's land interests it's book debts by way of assignment the related rights the company's undertaking by way of floating charge.
    Berechtigte Personen
    • Santander UK PLC
    Transaktionen
    • 15. Juli 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 06. Dez. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal and general charge
    Erstellt am 12. Juli 2010
    Geliefert am 15. Juli 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H premises shop unit 2 roche close rochford (also k/a 6 roche close) all the company's uncalled capital for the time being and all its intellectual property rights and all other f/h and l/h property the company's stock in trade and plant all it's land interests it's book debts by way of assignment the related rights the company's undertaking by way of floating charge.
    Berechtigte Personen
    • Santander UK PLC
    Transaktionen
    • 15. Juli 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 06. Dez. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal and general charge
    Erstellt am 12. Juli 2010
    Geliefert am 15. Juli 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H premises shop unit 1 roche close rochford (also k/a 5 roche close) all the company's uncalled capital for the time being and all its intellectual property rights and all other f/h and l/h property the company's stock in trade and plant all it's land interests it's book debts by way of assignment the related rights the company's undertaking by way of floating charge.
    Berechtigte Personen
    • Santander UK PLC
    Transaktionen
    • 15. Juli 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 06. Dez. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal and general charge
    Erstellt am 12. Juli 2010
    Geliefert am 15. Juli 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H premises unit 1 block b roche close rochford (also k/a 3 roche close) all the company's uncalled capital for the time being and all its intellectual property rights and all other f/h and l/h property the company's stock in trade and plant all it's land interests it's book debts by way of assignment the related rights the company's undertaking by way of floating charge.
    Berechtigte Personen
    • Santander UK PLC
    Transaktionen
    • 15. Juli 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 06. Dez. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal and general charge
    Erstellt am 12. Juli 2010
    Geliefert am 15. Juli 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H premises unit 2 block b roche close rochford (also k/a 2 roche close) all the company's uncalled capital for the time being and all its intellectual property rights and all other f/h and l/h property the company's stock in trade and plant all it's land interests it's book debts by way of assignment the related rights the company's undertaking by way of floating charge.
    Berechtigte Personen
    • Santander UK PLC
    Transaktionen
    • 15. Juli 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 06. Dez. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal and general charge
    Erstellt am 12. Juli 2010
    Geliefert am 15. Juli 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H premises unit 3 block b roche close rochford (aslo k/a 1 roche close) all the company's uncalled capital for the time being and all its intellectual property rights and all other f/h and l/h property the company's stock in trade and plant all it's land interests it's book debts by way of assignment the related rights the company's undertaking by way of floating charge.
    Berechtigte Personen
    • Santander UK PLC
    Transaktionen
    • 15. Juli 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 06. Dez. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 18. Nov. 2004
    Geliefert am 04. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transaktionen
    • 04. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Mai 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 18. Nov. 2004
    Geliefert am 23. Nov. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land at the rear of 3-7 heath drive gidea park romford essex t/n EGL446524.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transaktionen
    • 23. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Mai 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat HDG2018 LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    11. März 2021Beginn der Liquidation
    11. Apr. 2022Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Glyn Mummery
    Jupiter House Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Essex
    Praktiker
    Jupiter House Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Essex
    Paul Atkinson
    Jupiter House Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Essex
    Praktiker
    Jupiter House Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Essex

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0