AH MEDICAL PROPERTIES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | AH MEDICAL PROPERTIES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04188281 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von AH MEDICAL PROPERTIES LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich AH MEDICAL PROPERTIES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | The Brew House Greenalls Avenue WA4 6HL Warrington England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von AH MEDICAL PROPERTIES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| AH MEDICAL PROPERTIES PLC | 11. Jan. 2007 | 11. Jan. 2007 |
| ASHLEY HOUSE PROPERTIES LIMITED | 19. Apr. 2004 | 19. Apr. 2004 |
| SOHO HEALTH PLAZA LTD | 01. Aug. 2001 | 01. Aug. 2001 |
| FIRVALE LIMITED | 27. März 2001 | 27. März 2001 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von AH MEDICAL PROPERTIES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für AH MEDICAL PROPERTIES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Ungeprüfter Jahresabschluss, gekürzt, bis 31. März 2020 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 12. Apr. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ungeprüfter Jahresabschluss, gekürzt, bis 31. März 2019 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 12. Apr. 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2018 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 12. Apr. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift The Brew House Greenalls Avenue Warrington England WA4 6HL verlegt | 1 Seiten | AD04 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom Capita Registrars Bourne House 34 Beckenham Road Beckenham Kent BR3 4TU zum The Brew House Greenalls Avenue Warrington WA4 6HL geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Cessation of Assura Group Limited as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Notification of Assura Plc as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Simon Darke als Geschäftsführer am 08. Jan. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Orla Ball als Direktor am 08. Jan. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2017 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 12. Apr. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2016 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Andrew Simon Darke am 20. Apr. 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 12. Apr. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Andrew Simon Darke am 15. Dez. 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2015 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Andrew Simon Darke am 27. Aug. 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 12. Apr. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Assura Limited am 16. Dez. 2014 | 1 Seiten | CH02 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von AH MEDICAL PROPERTIES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALL, Orla Marie | Geschäftsführer | WA4 6HL Greenalls Avenue The Brew House Warrington United Kingdom | England | British | 199861060001 | |||||||||
| ASSURA CS LIMITED | Geschäftsführer | Greenalls Avenue WA4 6HL Warrington The Brew House England England |
| 149895250002 | ||||||||||
| BAILEY, David Charles | Sekretär | Cemlyn Ton Road Llangybi NP15 1PA Usk Monmouthshire | British | 95338890001 | ||||||||||
| MINION, Kate Elizabeth | Sekretär | Willow Place Falcons Croft HP10 0NP Wooburn Moor Buckinghamshire | British | 69215500004 | ||||||||||
| RONALDSON, Stephen Frank | Sekretär | 221 Sheen Lane East Sheen SW14 8LE London | British | 1772340003 | ||||||||||
| FIRST SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 72 New Bond Street W1S 1RR London | 900000780001 | |||||||||||
| BROWN, John Kenneth | Geschäftsführer | 9 Lochbroom Drive Newton Mearns G77 5DY Glasgow | Scotland | British | 462890004 | |||||||||
| BURTON, Anthony David | Geschäftsführer | Beechwood House Halls Hole Road TN2 4RD Tunbridge Wells Kent | Uk | British | 3513950001 | |||||||||
| DARKE, Andrew Simon | Geschäftsführer | Greenalls Avenue WA4 6HL Warrington The Brew House Cheshire United Kingdom | England | British | 65166580004 | |||||||||
| GUNN, John Humphrey | Geschäftsführer | Edwardes Square W8 6HE London 23 | England | British | 705110002 | |||||||||
| GUNN, John Humphrey | Geschäftsführer | 23 Edwardes Square W8 6HE London | England | British | 705110002 | |||||||||
| HOLMES, Jonathan | Geschäftsführer | 61 The Spinney HP9 1SA Beaconsfield Bucks | British | 107261280001 | ||||||||||
| MINION, Stephen Gregory | Geschäftsführer | Linkswood Cottage 2 Linkswood Road Burnham SL1 8AT Slough Berkshire | England | British | 40537330005 | |||||||||
| RAWLINGS, Nigel Keith | Geschäftsführer | Hollin Lane SK9 4JH Styal 18 Cheshire | England | British | 7127460001 | |||||||||
| WALKER, Bruce Layland | Geschäftsführer | 59 Chiswick Staithe Hartington Road W4 3TP London | United Kingdom | British | 82714410001 | |||||||||
| WEAVER, Christopher Giles Herron | Geschäftsführer | Greywalls Hotel EH31 2EG Gullane Lothian | Scotland | British | 1251050001 | |||||||||
| WILKINSON, Peter John | Geschäftsführer | 5 Lauds Close RG9 1UX Henley On Thames Oxfordshire | United Kingdom | British | 34867100001 | |||||||||
| FIRST DIRECTORS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 72 New Bond Street W1S 1RR London | 900000770001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei AH MEDICAL PROPERTIES LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assura Group Limited | 06. Apr. 2016 | La Grande Rue GY4 6RT St Martin's Old Bank Chambers Guernsey | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Assura Plc | 06. Apr. 2016 | Greenalls Avenue WA4 6HL Warrington The Brew House England England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat AH MEDICAL PROPERTIES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 05. Juli 2010 Geliefert am 08. Juli 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the secured parties and to any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of assigment | Erstellt am 12. Mai 2006 Geliefert am 25. Mai 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All the rights titles benefits and interests of the company to all monies from time to time due to the company under the lease in respect of medical cente kepple lane garstang lancashire,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental deed | Erstellt am 27. Jan. 2006 Geliefert am 14. Feb. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All monies deposited with the trustee. By way of floating charge all property assets rights revenues present and future including uncalled share capital (if any). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of assignment | Erstellt am 09. Dez. 2005 Geliefert am 14. Dez. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All the rights titles benefits and interests of the company to all monies from time to time due to the company under the lease. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of assignment | Erstellt am 25. Okt. 2005 Geliefert am 28. Okt. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All the rights titles benefits and interests of the company to all monies from time to time due to the company under the lease/S. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of assignment | Erstellt am 22. Sept. 2005 Geliefert am 23. Sept. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All the rights titles benefits and interests of the company to all monies from time to time due to the company under the lease in respect of land being at brook square trafalgar street west scarborough. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental deed | Erstellt am 11. März 2005 Geliefert am 26. März 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H property at kepple lane garstang preston including all buildings, erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenant's fixtures) and fixed plant and machinery, all moneys deposited with the trustee. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental deed (being supplemental to a deed of legal charge dated 14 october 2004) | Erstellt am 25. Jan. 2005 Geliefert am 02. Feb. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Land being part land on the west side of the road leading from brill to thame, brill, including all buildings erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fixed plant and machinery. All monies deposited with the trustee;. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental deed | Erstellt am 01. Dez. 2004 Geliefert am 17. Dez. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Land on the south side of longmead avenue great baddow essex together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fixed plant and machinery thereon, all improvements and additions thereto and all easements rights licences appurtenant thereto, subject to and with the benefit of all existing leases underleases tenancies agreements to lease rights covenants under conditions affecting the same but otherwise free from encumbrance. All moneys from time to time deposited with the trustee. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental deed (being supplemental to a deed of legal charge dated 14 october 2004) | Erstellt am 29. Okt. 2004 Geliefert am 13. Nov. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Land at brook square scarborough including all buildings erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fixed plant and machinery. All monies deposited with the trustee. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of assignment and charge | Erstellt am 14. Okt. 2004 Geliefert am 27. Okt. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All right title benefit and interest in the development agreement dated 3 september 2004 and in the assignment dated 14 october 2004. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of legal charge | Erstellt am 14. Okt. 2004 Geliefert am 27. Okt. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from ashley house PLC to the general practice finance corporation limited ('trustee') under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Land adjoining coombe girls school clarence avenue new malden kingston upon thames together with all buildings erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fittings thereon. All monies deposited with the trustee. By way of floating charge all property assets rights revenues present and future including uncalled share capital (if any). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0