BALMUIR DEVELOPMENTS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | BALMUIR DEVELOPMENTS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 04191304 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BALMUIR DEVELOPMENTS LIMITED?
- (7032) /
Wo befindet sich BALMUIR DEVELOPMENTS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | c/o JML BUSINESS SERVICES LTD 25 Church Street GU7 1EL Godalming Surrey United Kingdom |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von BALMUIR DEVELOPMENTS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
PARKCOM PROPERTIES LIMITED | 27. Apr. 2001 | 27. Apr. 2001 |
CAPSTANQUAY LIMITED | 30. März 2001 | 30. März 2001 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BALMUIR DEVELOPMENTS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BALMUIR DEVELOPMENTS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. März 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2010 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Catteshall Mill Catteshall Road Godalming Surrey GU7 1NJ Uk am 06. Okt. 2010 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mrs Alexandra Caroline Mackay Haining am 06. Apr. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Andrew Haining am 06. Apr. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mrs Alexandra Caroline Mackay Haining am 06. Apr. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2009 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. März 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Andrew Haining am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Ms Joanna Mary Mackenzie Lee am 01. Okt. 2009 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mrs Alexandra Caroline Mackay Haining am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2008 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2007 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 6 Seiten | MA | ||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 12 Seiten | MA | ||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed parkcom properties LIMITED\certificate issued on 24/05/07 | 2 Seiten | CERTNM |
Wer sind die Geschäftsführer von BALMUIR DEVELOPMENTS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACKENZIE LEE, Joanna Mary | Sekretär | Brook Road Sandhills GU8 5UR Wormley Redlands Surrey England | British | 15820670003 | ||||||
HAINING, Alexandra Caroline Mackay | Geschäftsführer | Route De Jerbourg GY4 6BH St Martins Couin De Vacque Guernsey | United Kingdom | British | Director | 105312650010 | ||||
HAINING, Andrew | Geschäftsführer | Route De Jerbourg GY4 6BH St Martins Couin De Vacque Guernsey | Guernsey | British | Investment Banker | 42196640021 | ||||
BARBOUR, Dominic James | Sekretär | 57a Highbury Hill N5 1SU London | British | 55349040001 | ||||||
SECRETARIAL APPOINTMENTS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 16 Churchill Way CF10 2DX Cardiff | 900017270001 | |||||||
BOTTS, John Chester | Geschäftsführer | 21 Argyll Road W8 7DA London | United Kingdom | American | Investment Banker | 2943960001 | ||||
TRUSTY, Scott Norman | Geschäftsführer | 5 Beach Lane GU2 4EN Guildford Surrey | England | British | Property Developer | 1882300016 | ||||
CORPORATE APPOINTMENTS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 16 Churchill Way CF10 2DX Cardiff | 900017260001 |
Hat BALMUIR DEVELOPMENTS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Charge over fixed deposit | Erstellt am 13. Dez. 2004 Geliefert am 17. Dez. 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever 10 | |
Kurze Angaben All moneys from time to time held to the credit of the mortgagor by the bank on account number 08379777, sort code 18-00-02 designated "coutts & company re: parkcom properties limited". | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 13. Dez. 2004 Geliefert am 17. Dez. 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land and buildings k/a national grid science and technology laboratories, springfield drive, leatherhead t/nos. SY646634 and SY680242. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 13. Dez. 2004 Geliefert am 17. Dez. 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Property with t/nos. SY646634 and SY680242 and the proceeds of sale thereof and all moneys to be received under any policy of insurance effected in respect of the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 05. Nov. 2004 Geliefert am 11. Nov. 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/a griffin house, west street, woking. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of charge over credit balances | Erstellt am 29. Okt. 2004 Geliefert am 05. Nov. 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Details of charged account(s) barclays bank PLC re parkcom properties limited business tracker account account number 90447099. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security agreement | Erstellt am 24. Okt. 2002 Geliefert am 28. Okt. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of charge over credit balances | Erstellt am 16. Juli 2002 Geliefert am 22. Juli 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Barclays bank PLC re parkcom properties limited business premium account number 90139076. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 20. Aug. 2001 Geliefert am 23. Aug. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the finance documents | |
Kurze Angaben All that f/h property at parkside business park quinton road coventry t/no WM746125. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed charge | Erstellt am 09. Aug. 2001 Geliefert am 11. Aug. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Any sums certified by the fit out employer's agent as properly due to the contractor pursuant to the fit out contract and paid by lsc to the contractor under the fit out contract in relation to the link or any part of of the fit out works carried out or completed on or within the property prior to the termination date | |
Kurze Angaben All that f/h property situate and k/a land and buildings at parkside business park quinton road coventry, all and singular the fixed machinery buildings erections and other fixtures and fittings. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed and floating charge debenture | Erstellt am 11. Mai 2001 Geliefert am 16. Mai 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with any loan documents | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0