MM (ROCHDALE) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | MM (ROCHDALE) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04192475 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MM (ROCHDALE) LIMITED?
- Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich MM (ROCHDALE) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nixon Street Rochdale OL11 3JW Lancashire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von MM (ROCHDALE) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| PINCO 1619 LIMITED | 02. Apr. 2001 | 02. Apr. 2001 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MM (ROCHDALE) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2014 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für MM (ROCHDALE) LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für MM (ROCHDALE) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Apr. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2014 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Colin Anthony Houlihan als Direktor am 11. Sept. 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Robin Garry Bridge als Geschäftsführer am 12. Sept. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 30. Sept. 2014 bis 31. März 2014 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2013 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Apr. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Graham Pearson als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Graham Pearson als Sekretär | 3 Seiten | AP03 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Steven Nobes als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Steven Nobes als Sekretär | 2 Seiten | TM02 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Graham Pearson als Sekretär | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Steven Nobes als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Steven Nobes als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Mr Graham Pearson als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Robin Garry Bridge am 08. Apr. 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2012 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Apr. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2011 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Apr. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2010 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Apr. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von MM (ROCHDALE) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEARSON, Graham | Sekretär | Nixon Street Rochdale OL11 3JW Lancashire | 186930730001 | |||||||
| HOULIHAN, Colin Anthony | Geschäftsführer | Nixon Street Rochdale OL11 3JW Lancashire | England | British | 191894430001 | |||||
| PEARSON, Graham | Geschäftsführer | Nixon Street Rochdale OL11 3JW Lancashire | United Kingdom | British | 95884040002 | |||||
| HINKLEY, Anthony John | Sekretär | 23 Brockenhurst Drive Harwood BL2 4HP Bolton Lancashire | British | 84786630001 | ||||||
| NIGHTINGALE, Barry Graham Kirk | Sekretär | Ravenhurst The Lane Heaton BL1 5DJ Bolton Lancashire | British | 80722790001 | ||||||
| NIGHTINGALE, Barry Graham Kirk | Sekretär | Ravenhurst The Lane Heaton BL1 5DJ Bolton Lancashire | British | 80722790001 | ||||||
| NOBES, Steven Robert | Sekretär | Nixon Street Rochdale OL11 3JW Lancashire | British | 114259410001 | ||||||
| PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED | Sekretär | 1 Park Row LS1 5AB Leeds West Yorkshire | 76579530001 | |||||||
| BRIDGE, Robin Garry | Geschäftsführer | Nixon Street Rochdale OL11 3JW Lancashire | England | British | 89176260001 | |||||
| HINKLEY, Anthony John | Geschäftsführer | 23 Brockenhurst Drive Harwood BL2 4HP Bolton Lancashire | United Kingdom | British | 84786630001 | |||||
| NIGHTINGALE, Barry Graham Kirk | Geschäftsführer | Ravenhurst The Lane Heaton BL1 5DJ Bolton Lancashire | England | British | 80722790001 | |||||
| NOBES, Steven Robert | Geschäftsführer | Nixon Street Rochdale OL11 3JW Lancashire | United Kingdom | British | 114259410001 | |||||
| YATES, John Richard | Geschäftsführer | 86 Victoria Road WA15 9AB Hale Cheshire | United Kingdom | British | 97822910001 | |||||
| PINSENT MASONS DIRECTOR LIMITED | Geschäftsführer | 1 Park Row LS1 5AB Leeds West Yorkshire | 76332110001 |
Hat MM (ROCHDALE) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Erstellt am 18. Mai 2005 Geliefert am 01. Juni 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Marland mill, nixon street, rochdale t/no GM506089. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 18. Mai 2005 Geliefert am 27. Mai 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Marland mill nixon street rochdale t/no GM506089 fixed charge all fixtures and fittings all plant and machinery vehicles and computer equipment at the property all furniture furnishings equipment tools and other chattels. Fixed charge the goodwill all rents receivable form any lease and the proceeds of any insurance. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 18. Mai 2005 Geliefert am 27. Mai 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 18. Mai 2005 Geliefert am 25. Mai 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge deed | Erstellt am 12. Sept. 2002 Geliefert am 18. Sept. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The property being marland mill nixon street rochdale greater manchester t/no GM506089 the goodwill, benefit of any shareholdings, present and future licences, consents, permissions and agreements, all warranties, guarantees and indemnities, contracts and agreements, contracts of insurance. By way of floating charge over all other property assets rights and equipment and all its undertakings. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0