HANOVER PARK SERVICES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | HANOVER PARK SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04194617 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HANOVER PARK SERVICES LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich HANOVER PARK SERVICES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Portland 25 High Street RH10 1BG Crawley West Sussex |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von HANOVER PARK SERVICES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| HANOVER PARK SERVICES PLC | 01. Juli 2004 | 01. Juli 2004 |
| HANOVER PARK SERVICES PLC | 05. Apr. 2001 | 05. Apr. 2001 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HANOVER PARK SERVICES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2013 |
Welche sind die letzten Einreichungen für HANOVER PARK SERVICES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 16 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Sept. 2016 | 16 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Hestia House Edgewest Road Lincoln LN6 7EL zum Portland 25 High Street Crawley West Sussex RH10 1BG am 17. Nov. 2015 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. Apr. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stefan Gackowski als Sekretär am 06. Mai 2015 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Mr Philip Screeton als Sekretär am 06. Mai 2014 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stefan Gackowski als Sekretär am 06. Mai 2015 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 8 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 9 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. Apr. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Stefan Gackowski als Sekretär | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christina Ye als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kevin Withington als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Philip Screeton als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ian Sutherland als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Martin Totty als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Ramsey als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von HANOVER PARK SERVICES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCREETON, Philip | Sekretär | Edgewest Road LN6 7EL Lincoln Hestia House England | 197766990001 | |||||||
| SCREETON, Philip | Geschäftsführer | High Street RH10 1BG Crawley Portland 25 West Sussex | United Kingdom | British | 183509400001 | |||||
| TOTTY, Martin Richard | Geschäftsführer | High Street RH10 1BG Crawley Portland 25 West Sussex | England | British | 261940540001 | |||||
| BELLIS, Juliet Mary Susan | Sekretär | 4 Grange Hill SE25 6SX London | British | 69991160002 | ||||||
| GACKOWSKI, Stefan | Sekretär | Edgewest Road LN6 7EL Lincoln Hestia House United Kingdom | 184202440001 | |||||||
| HALSTEAD, Andrew John | Sekretär | Hillside Hoseley Lane Marford LL12 8YE Wrexham | British | 92617680001 | ||||||
| JOHNSON, Robin Simon | Sekretär | 25 Thirlmere Road Muswell Hill N10 2DL London | British | 11498320001 | ||||||
| SARGENT, Gavin Roy | Sekretär | 3 Larkfield Road DA14 6RF Sidcup Kent | British | 16957570002 | ||||||
| YE, Christina Hong | Sekretär | Bedford Park CR0 2AP Croydon Third Floor Sunley House United Kingdom | British | 133681410001 | ||||||
| ASHCROFT CAMERON SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 4 Rivers House Fentiman Walk SG14 1DB Hertford Hertfordshire | 900004530001 | |||||||
| ARNOLD, Michael Stuart | Geschäftsführer | Chailey Wood Woolfords Lane Elstead GU8 6LL Godalming Surrey | England | British | 50999400001 | |||||
| ASHBOLT, Timothy John | Geschäftsführer | September Cottages Skirbeck Drive LN1 2HE Saxilby Lincoln | British | 37970340001 | ||||||
| BELLIS, Neil Graham | Geschäftsführer | 4 Grange Hill SE25 6SX London | British | 61569970002 | ||||||
| BOWDEN, Peter | Geschäftsführer | Upper Woodcote House Birch Lane CR8 3LH Purley Surrey | England | British | 9709580001 | |||||
| BRINDLEY, Steven John | Geschäftsführer | 56 Elmstead Lane BR7 5EL Chislehurst Kent | England | British | 71800210002 | |||||
| CUMMINGS, Lucy | Geschäftsführer | 13 Plympton Street NW8 8AB London | British | 80559730001 | ||||||
| CUSHION, Victoria Jane | Geschäftsführer | 31 Wraysbury Gardens TW18 4US Staines Middlesex | British | 81655140002 | ||||||
| DAVIS, Nigel Peter | Geschäftsführer | 6 Boundary Park KT13 9RR Weybridge Surrey | England | British | 93673010002 | |||||
| DEAN, John Robert | Geschäftsführer | Cripland Court Cottage Gravelye Lane Lindfield RH16 2SL Haywards Heath West Sussex | Gbr | British | 92489050001 | |||||
| FARLEY, Michael Ernest | Geschäftsführer | 29 Bankside Dunton Green TN13 2UA Sevenoaks Kent | England | Scottish | 75539870001 | |||||
| HALSTEAD, Andrew John | Geschäftsführer | Hillside Hoseley Lane Marford LL12 8YE Wrexham | United Kingdom | British | 92617680001 | |||||
| HUNNISETT, John Dennis | Geschäftsführer | St Martins Northbourne Road CT14 0HD Deal Kent | United Kingdom | British | 92001880001 | |||||
| HUNTER, Adam Andrew | Geschäftsführer | 33 Chapel Park Road TN37 6HR St Leonards On Sea East Sussex | British | 43507340002 | ||||||
| JENKINSON, Andrew Timothy | Geschäftsführer | Bedford Park CR0 2AP Croydon Third Floor Sunley House United Kingdom | United Kingdom | British | 74069620002 | |||||
| LAVELLE, Dominic Joseph | Geschäftsführer | 2 West Grove SE10 8QT London Flat 3 | United Kingdom | British | 137285750001 | |||||
| LYNCH, Peter Anthony | Geschäftsführer | 528 Coulsdon Road CR3 5QQ Caterham Surrey | British | 1854270005 | ||||||
| OLIVER, David Martin | Geschäftsführer | 13 Kirklee Circus G12 0TW Glasgow Lanarkshire | United Kingdom | British | 115764650001 | |||||
| PALMER, Jeffrey Edward | Geschäftsführer | 22 Catalina Close BH23 4JG Christchurch Dorset | England | British | 82018950001 | |||||
| PEARSON, Michael | Geschäftsführer | 60 Barmouth Road SW18 2DR Wandsworth Greater London | England | British | 67026480004 | |||||
| PERAUX, Keith Vaughan | Geschäftsführer | Highfields 165 Hayes Lane BR2 9EJ Bromley | United Kingdom | British | 1854250002 | |||||
| RAMSEY, Michael Francis | Geschäftsführer | Edgewest Road LN6 7EL Lincoln Hestia House United Kingdom | United Kingdom | British | 80310620002 | |||||
| SARGENT, Gavin Roy | Geschäftsführer | 3 Larkfield Road DA14 6RF Sidcup Kent | British | 16957570002 | ||||||
| SMITH, James Robert Drummond | Geschäftsführer | 11 Wellesley Road CR0 2NW Croydon Caley Limited Phoenix House Surrey | Spain | British | 130443150001 | |||||
| SUTHERLAND, Ian Ronald | Geschäftsführer | Bedford Park CR0 2AP Croydon Third Floor Sunley House United Kingdom | United Kingdom | British | 189660790001 | |||||
| WILLIAMS, Neil Vaughan | Geschäftsführer | 1 Richmond Place TN2 5JZ Tunbridge Wells Kent | England | British | 71561050001 |
Hat HANOVER PARK SERVICES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 26. Juli 2006 Erworben am 13. März 2008 Geliefert am 25. März 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each charging company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The entire issued share capital debentures bonds warrants other securities or investments,etc. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 26. Juli 2006 Erworben am 13. März 2008 Geliefert am 25. März 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each charging company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The entire issued share capital debentures bonds coupons or other securities or investments; see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 26. Juli 2006 Erworben am 13. März 2008 Geliefert am 25. März 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each charging company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The entire issued capital debentures bonds warrants certificates of depoit,etc or other securities or investments; see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Group debenture | Erstellt am 26. Juli 2006 Geliefert am 03. Aug. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 18. Aug. 2004 Geliefert am 20. Aug. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 29. Jan. 2003 Geliefert am 07. Mai 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 12. Apr. 2002 Geliefert am 22. Apr. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 24. Apr. 2001 Geliefert am 01. Mai 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company (formerly hanover park services limited) and all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat HANOVER PARK SERVICES LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0