HS ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | HS ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04198211 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HS ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED?
- (7487) /
Wo befindet sich HS ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 2nd Floor 110 Cannon Street EC4N 6EU London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HS ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für HS ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 39 Seiten | LIQ14 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 24. Jan. 2019 | 36 Seiten | LIQ03 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 24. Jan. 2018 | 35 Seiten | LIQ03 | ||
Beendigung der Bestellung von Alan Robert Howard als Sekretär am 08. Juni 2017 | 2 Seiten | TM02 | ||
Beendigung der Bestellung von Alan Robert Howard als Geschäftsführer am 08. Juni 2017 | 2 Seiten | TM01 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 24. Jan. 2017 | 30 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 24. Jan. 2016 | 31 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 24. Jan. 2015 | 33 Seiten | 4.68 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 10 Furnival Street London EC4A 1AB zum 2Nd Floor 110 Cannon Street London EC4N 6EU am 24. Juli 2014 | 2 Seiten | AD01 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 24. Jan. 2014 | 29 Seiten | 4.68 | ||
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 9 Seiten | F10.2 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * 10 Furnival Street London EC4A 1YH* am 21. Feb. 2013 | 2 Seiten | AD01 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 14. Jan. 2013 | 57 Seiten | 2.24B | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 14. Jan. 2013 | 58 Seiten | 2.24B | ||
Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger | 1 Seiten | 2.34B | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 14. Juli 2012 | 42 Seiten | 2.24B | ||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 1 Seiten | 2.31B | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 14. Jan. 2012 | 40 Seiten | 2.24B | ||
Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge | 1 Seiten | F2.18 | ||
Vorschlag des Verwalters | 109 Seiten | 2.17B | ||
Vermögensübersicht mit Formular 2.14B | 6 Seiten | 2.16B | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Unit 13 Ashton Gate Ashton Road Romford Essex RM3 8UF* am 26. Juli 2011 | 2 Seiten | AD01 | ||
Ernennung eines Verwalters | 1 Seiten | 2.12B | ||
Beendigung der Bestellung von Dipak Chikhalia als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von HS ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GREEN, Christopher John | Geschäftsführer | 22 Welby Crescent Winnersh RG41 5SW Wokingham Berkshire | United Kingdom | British | Commercial Director | 66558180001 | ||||
| PHILLIPS, Chris | Geschäftsführer | Albemarle Link Spring Field CM1 6AG Chelmsford 18 Essex United Kingdom | United Kingdom | British | Project Director | 99034590004 | ||||
| SAYER, Harry | Geschäftsführer | Springhill Star Lane Knowl Hill RG10 9XY Reading Berkshire | United Kingdom | English | Director | 21447560001 | ||||
| SULLIVAN, Marcus | Geschäftsführer | Dane Cottage Dane Street CT14 8ER Chilham Kent | England | South African | Project Director | 81496010003 | ||||
| WILEY, George | Geschäftsführer | 2 Harrow Close RM11 1FQ Hornchurch Essex | United Kingdom | British | Director | 97959650001 | ||||
| HINCHIN, Janice Ann | Sekretär | Holmwood Cornsland CM14 4JN Brentwood Essex | British | 26575010001 | ||||||
| HOWARD, Alan Robert | Sekretär | 35 South View Close DA5 1EG Bexley Kent | English | 97320450001 | ||||||
| TEMPLE SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 788-790 Finchley Road NW11 7TJ London | 900001120001 | |||||||
| BUSH, Michael | Geschäftsführer | Break Of Day Beaumont Rd, Great Oakley CO12 5BD Harwich Essex | England | British | Director | 121666030001 | ||||
| CHIKHALIA, Dipak | Geschäftsführer | 280 Crofton Road BR6 8EY Orpington Kent | England | British | Director | 84705030001 | ||||
| HINCHIN, Daniel Patrick | Geschäftsführer | Holmwood Cornsland CM14 4JN Brentwood Essex | Uk | British | Engineer | 38388640001 | ||||
| HOWARD, Alan Robert | Geschäftsführer | 35 South View Close DA5 1EG Bexley Kent | England | English | Director | 97320450001 | ||||
| THURSTON, John Edward | Geschäftsführer | 38 Branksome Avenue SS5 5PF Hockley Essex | United Kingdom | British | Company Director | 63271830001 | ||||
| COMPANY DIRECTORS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 788-790 Finchley Road NW11 7TJ London | 900001110001 |
Hat HS ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| An omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 02. Aug. 2010 Geliefert am 05. Aug. 2010 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement (ogsa) dated 10TH july 2006 | Erstellt am 15. Sept. 2008 Geliefert am 20. Sept. 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| All assets debenture | Erstellt am 15. Nov. 2007 Geliefert am 17. Nov. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 10. Juli 2006 Geliefert am 21. Juli 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sums or sums standing to the credit if any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. Dez. 2005 Geliefert am 23. Dez. 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 27. Feb. 2004 Geliefert am 03. März 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat HS ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| In Verwaltung |
| ||||||||||||||||||||||
| 2 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0