CW COSMETICS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCW COSMETICS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04200663
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CW COSMETICS LIMITED?

    • (7487) /

    Wo befindet sich CW COSMETICS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Ewenny Road
    Maesteg
    CF34 9TU Bridgend County Borough
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CW COSMETICS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    2147TH SINGLE MEMBER SHELF INVESTMENT COMPANY LIMITED17. Apr. 200117. Apr. 2001

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CW COSMETICS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis25. März 2006

    Welche sind die letzten Einreichungen für CW COSMETICS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Beendigung der Liquidation

    1 SeitenL64.07

    Gerichtsbeschluss zur Liquidation

    2 SeitenCOCOMP

    Gerichtsbeschluss zur Liquidation

    2 SeitenCOCOMP

    Gerichtsbeschluss zur Liquidation

    1 SeitenCOCOMP

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    2 Seiten363a

    legacy

    19 Seiten395

    legacy

    8 Seiten395

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    2 Seiten288a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 25. März 2006

    15 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    2 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    14 Seiten395

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    115 Seiten395

    Wer sind die Geschäftsführer von CW COSMETICS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    THIRLWELL, Wendy Denise
    Manvers 15 Golwg Yr Afon
    Llangennech
    SA14 8SX Llanelli
    Dyfed
    Sekretär
    Manvers 15 Golwg Yr Afon
    Llangennech
    SA14 8SX Llanelli
    Dyfed
    BritishExecutive Pa114068060001
    MELDRUM, Stuart
    32 Chargot Road
    CF5 1EW Cardiff
    South Glamorgan
    Geschäftsführer
    32 Chargot Road
    CF5 1EW Cardiff
    South Glamorgan
    WalesBritishChief Executive Officer102237980001
    OREN, Ran
    28 Wolsey Way
    CB1 3JQ Cambridge
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    28 Wolsey Way
    CB1 3JQ Cambridge
    Cambridgeshire
    United KingdomGermanChief Financial Officer113744540001
    TOLAN, Bobby Jay
    11203 Gregory Lane
    75035 Frisco
    Texas
    United States Of America
    Geschäftsführer
    11203 Gregory Lane
    75035 Frisco
    Texas
    United States Of America
    AmericanExecutive Chairman90919790004
    DONNELLY, John Michael
    Timbers Ridge
    Franksfield
    GU5 9SR Peaslake
    Surrey
    Sekretär
    Timbers Ridge
    Franksfield
    GU5 9SR Peaslake
    Surrey
    BritishDirector153980720001
    HENRIKSEN, Alison Jane
    428 Upper Richmond Road West
    TW10 5DY Richmond
    Surrey
    Sekretär
    428 Upper Richmond Road West
    TW10 5DY Richmond
    Surrey
    BritishC F O102224500002
    LASHBROOKE, Andrew Michael
    2 Lavender Gate
    Steels Lane
    KT22 0RE Oxshott
    Surrey
    Sekretär
    2 Lavender Gate
    Steels Lane
    KT22 0RE Oxshott
    Surrey
    South African81345910001
    NICHOLLS, Duncan
    Tanglin Manor Road
    Penn
    HP10 8HY High Wycombe
    Buckinghamshire
    Sekretär
    Tanglin Manor Road
    Penn
    HP10 8HY High Wycombe
    Buckinghamshire
    BritishChartered Accountant17828040001
    SISEC LIMITED
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    Bevollmächtigter Sekretär
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    900001770001
    DONNELLY, John Michael
    Timbers Ridge
    Franksfield
    GU5 9SR Peaslake
    Surrey
    Geschäftsführer
    Timbers Ridge
    Franksfield
    GU5 9SR Peaslake
    Surrey
    United KingdomBritishChartered Accountant153980720001
    HENRIKSEN, Alison Jane
    428 Upper Richmond Road West
    TW10 5DY Richmond
    Surrey
    Geschäftsführer
    428 Upper Richmond Road West
    TW10 5DY Richmond
    Surrey
    BritishC F O102224500002
    LASHBROOKE, Andrew Michael
    2 Lavender Gate
    Steels Lane
    KT22 0RE Oxshott
    Surrey
    Geschäftsführer
    2 Lavender Gate
    Steels Lane
    KT22 0RE Oxshott
    Surrey
    South AfricanDirector81345910001
    MCNALLY, Ian Richard Armstrong
    Woodcote House
    Lodge Green Burton Park
    GU28 0LH Petworth
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Woodcote House
    Lodge Green Burton Park
    GU28 0LH Petworth
    West Sussex
    EnglandBritishDirector115019860001
    NICHOLLS, Duncan
    Tanglin Manor Road
    Penn
    HP10 8HY High Wycombe
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Tanglin Manor Road
    Penn
    HP10 8HY High Wycombe
    Buckinghamshire
    BritishChartered Accountant17828040001
    TEN HOPE, Michael Frits
    89 David Avenue
    Duxberry
    Sandton
    South Africa
    Geschäftsführer
    89 David Avenue
    Duxberry
    Sandton
    South Africa
    South AfricanDirector77298500001
    LOVITING LIMITED
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    900001760001
    SERJEANTS' INN NOMINEES LIMITED
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    900001750001

    Hat CW COSMETICS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of variation and charge
    Erstellt am 18. Juni 2007
    Geliefert am 28. Juni 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and each and every other security obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of fixed charge the littlehampton equipment being york YCAL0347SBXA chiller, netsch 602 de-aerator s/n 510248/01 and omas capping machine for details of maesteg equipment and other equipment please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Venture Finance PLC
    Transaktionen
    • 28. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of assignment of the benefit of certain insurance policies
    Erstellt am 18. Juni 2007
    Geliefert am 28. Juni 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and each and every other security obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Right title and interest in and to the policies and the replacement policies. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Venture Finance PLC
    Transaktionen
    • 28. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 21. Feb. 2006
    Geliefert am 28. Feb. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and all monies due or to become due from each and every other security obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Underlease relating to factory and warehouse hawthorn road wick littlehampton west sussex, underlease relating to factory unit 5 watermead business park littlehampton west sussex, underlease relating to unit 8 watermead business park worthing lane littlehampton west sussex. For details of further properties charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Venture Finance PLC
    Transaktionen
    • 28. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 09. Feb. 2006
    Geliefert am 09. Feb. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    1 omso novax m uv 4 colour screen print inline machine s/no 1301522-95(1995), 1 omso novax m uv 4 colour screen print inline machine s/no 1301329-94 (1994), 1 medway novopac package shrink wrapper for details of further plant & machinery charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 11. März 2003
    Geliefert am 14. März 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from cosi (bahamas) limited or any company to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H property land on the east side of oakwood drive and on the west side of ewenny road, maesteg, bridgend, mid glamorgan. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Industrial Development Limited (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 14. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 12. Okt. 2001
    Geliefert am 02. Nov. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All money and liabilities due, owing or incurred to any secured party by any charging company or any other obligor (as defined therein) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for Itself and the Other Securedparties
    Transaktionen
    • 02. Nov. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage of stocks and shares to secure own liabilities of a company
    Erstellt am 30. Juli 2001
    Geliefert am 08. Aug. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the company's right title benefit and interest in and to the "mortgaged securities". See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Aug. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. März 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat CW COSMETICS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    02. Nov. 2009Abschluss der Liquidation
    25. Juni 2008Antragsdatum
    03. Sept. 2008Beginn der Liquidation
    16. Feb. 2010Aufgelöst am
    Zwangsliquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    The Official Receiver Or Cardiff
    3rd Floor Companies House
    Crown Way
    CF14 3UZ Maindy Cardiff
    Praktiker
    3rd Floor Companies House
    Crown Way
    CF14 3UZ Maindy Cardiff
    The Official Receiver Or London
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    Praktiker
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0