ISOFT NETHERLANDS (HOLDINGS) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | ISOFT NETHERLANDS (HOLDINGS) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 04204306 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ISOFT NETHERLANDS (HOLDINGS) LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich ISOFT NETHERLANDS (HOLDINGS) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Royal Pavilion Wellesley Road GU11 1PZ Aldershot Hampshire United Kingdom |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ISOFT NETHERLANDS (HOLDINGS) LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
TOREX EUROPE (HOLDINGS) LIMITED | 16. Mai 2001 | 16. Mai 2001 |
SPEED 8732 LIMITED | 24. Apr. 2001 | 24. Apr. 2001 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ISOFT NETHERLANDS (HOLDINGS) LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2012 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für ISOFT NETHERLANDS (HOLDINGS) LIMITED?
Jahresabschluss |
|
---|
Welche sind die letzten Einreichungen für ISOFT NETHERLANDS (HOLDINGS) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. März 2013 bis 30. Sept. 2013 | 3 Seiten | AA01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Thomson als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Apr. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift verlegt | 1 Seiten | AD04 | ||||||||||
Ernennung von David William Hart Gray als Sekretär | 3 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Gareth Wilson als Sekretär | 2 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2012 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 34 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Adrian Stevens als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Apr. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2011 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verkürzt von 30. Juni 2012 bis 31. März 2012 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Andrea Fiumicelli am 12. Sept. 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Andrew James Edward Thomson am 12. Sept. 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Adrian Charles Stevens am 12. Sept. 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mr Gareth Antony Wilson am 12. Sept. 2011 | 2 Seiten | CH03 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * C/O Csc Computer Sciences International Ltd Royal Pavilion Wellesley Road Aldershot Hampshire GU11 1PZ United Kingdom* am 18. Aug. 2011 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * C/O Isoft Group Plc Daventry Road Banbury Oxfordshire OX16 3JT* am 05. Aug. 2011 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Ernennung von Mr Andrew James Edward Thomson als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ISOFT NETHERLANDS (HOLDINGS) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAY, David William Hart | Sekretär | Wellesley Road GU11 1PZ Aldershot Royal Pavilion Hampshire United Kingdom | British | 177357700001 | ||||||
FIUMICELLI, Andrea | Geschäftsführer | Wellesley Road GU11 1PZ Aldershot Royal Pavilion Hampshire United Kingdom | Italy | Italian | Company Director | 135619020001 | ||||
EDELMAN, Howard Todd | Sekretär | Elizabeth Bay Road 2011 Elizabeth Bay 84/108 Nsw Australia | Australian | Company Secretary | 126124430005 | |||||
HILL, Teifion Mark | Sekretär | 59 Hill Top Avenue Cheadle Hulme SK8 7HZ Stockport Cheshire | British | 100105520001 | ||||||
HORN, Nigel David | Sekretär | Featherbow House Ratley OX15 6DS Banbury Oxfordshire | British | 109926660001 | ||||||
WILSON, Gareth Antony | Sekretär | Wellesley Road GU11 1PZ Aldershot Royal Pavilion Hampshire United Kingdom | 162047940001 | |||||||
WATERLOW SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003950001 | |||||||
COHEN, Gary Michael | Geschäftsführer | 178 Hopetoun Avenue, Watsons Bay Nsw 2030 Australia | Australia | Australian | Company Director | 125992970001 | ||||
GRAHAM, Stephen Paul | Geschäftsführer | Brackenridge Mereside Road WA16 6QR Mere Cheshire | United Kingdom | British | Director | 97528710001 | ||||
HENRY, William Patrick | Geschäftsführer | 9 Grafton Road GL50 2ET Cheltenham Gloucestershire | England | American | Company Director | 119049370001 | ||||
JAMES, Gavin Keith, Mr. | Geschäftsführer | Camelford Bradcutts Lane SL6 9AA Cookham Dean Berkshire | England | British | Finance Director | 44173560008 | ||||
KUMAR, Ravi | Geschäftsführer | 14 Parkham Close Daisy Hill Westhaughton BL5 2GT Bolton Lancashire | British | Director | 101025710001 | |||||
MACKAY, James Gordon | Geschäftsführer | Daventry Road OX16 3JT Banbury Isoft Group Plc Oxfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 178097680001 | ||||
PEARMAN, Mark Chalice | Geschäftsführer | The Old Rectory Honiley CV8 1NP Kenilworth Warwickshire | United Kingdom | British | Director | 57516220003 | ||||
RICHARDS, Paul | Geschäftsführer | The Barn Green Lane South Newington OX15 4JH Banbury | United Kingdom | British | Company Director | 126777780001 | ||||
STEVENS, Adrian Charles | Geschäftsführer | Wellesley Road GU11 1PZ Aldershot Royal Pavilion Hampshire United Kingdom | England | British | Company Director | 76964750002 | ||||
THOMSON, Andrew James Edward | Geschäftsführer | Wellesley Road GU11 1 PZ Aldershot Royal Pavilion Hampshire United Kingdom | England | British | Chartered Accountant | 147270780001 | ||||
WHELAN, John | Geschäftsführer | 26 Lynton Park Road SK8 6JA Cheadle Hulme Cheshire | Uk | British | Director | 105872500001 | ||||
WHISTON, Timothy Andrew | Geschäftsführer | Boothshill Farm Booths Lane WA13 0PF Lymm Cheshire | England | British | Director | 69575560002 | ||||
WOODBRIDGE, Mark Gavin | Geschäftsführer | The Bungalow Marton CV23 9RS Rugby Warwickshire | British | Finance Director | 74738270002 | |||||
WATERLOW NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003940001 |
Hat ISOFT NETHERLANDS (HOLDINGS) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Second ranking share pledge | Erstellt am 03. Dez. 2010 Geliefert am 14. Dez. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All shares and share rights, the first ranking deed. Future assets of the second ranking share charge see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of pledge of shares | Erstellt am 30. Dez. 2009 Geliefert am 15. Jan. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All rights means all rights dividends interest money or property bonus see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security agreement | Erstellt am 30. Dez. 2009 Geliefert am 13. Jan. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All f/h and l/h property,all equipment and fixed assets,all shares,all other stocks debentures,bonds,warrants,coupons or other securities see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A third ranking deed of pledge of shares | Erstellt am 29. Okt. 2008 Geliefert am 13. Nov. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the chargee in its capacity as creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All shares and share rights see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Second ranking deed of pledge of shares | Erstellt am 29. Juli 2008 Geliefert am 15. Aug. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All its shares and share rights see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of pledge | Erstellt am 27. Nov. 2007 Geliefert am 17. Dez. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Shares and share rights including any dividend, interest. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A deed of accession | Erstellt am 27. Nov. 2007 Geliefert am 13. Dez. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each borrower as a borrower and from each target guarantor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 24. Aug. 2006 Geliefert am 31. Aug. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Any sums or sums standing to the credit if any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental guarantee and debenture | Erstellt am 25. Juni 2004 Geliefert am 01. Juli 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the parent company, any chargor or any other of the parent company's subsidiaries (together the group) to the finance parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H property known as unit 2 firecrest court warrington t/no CH445922, l/h property known as upminster unit 16 essex, l/h property known as sarum gate basingstoke t/no HP208786. For details of further properties charged please refer to form 395. by way of fixed charge the rental income, fixed or other plant and machinery, insurances, licences on land, rights as tenant, book debts and other debts. Floating charge all undertaking and all other property assets and rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A legal charge containing fixed and floating charges | Erstellt am 21. Juli 2003 Geliefert am 06. Aug. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage the f/h property known as churchfields, stonesfield, witney OX8 8PQ t/no ON214941 and all that f/h property known as unit 2 (postal number 310) firecrest court, centre park, warrington, cheshire, t/no CH445922. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0