PATIENTFIRST (HINCKLEY) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | PATIENTFIRST (HINCKLEY) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aktiv |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 04207580 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PATIENTFIRST (HINCKLEY) LIMITED?
- Allgemeinarztpraxen (86210) / Gesundheits- und Sozialwesen
Wo befindet sich PATIENTFIRST (HINCKLEY) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 5th Floor Burdett House 15-16 Buckingham Street WC2N 6DU London United Kingdom |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von PATIENTFIRST (HINCKLEY) LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
JPH (HINCKLEY) LIMITED | 28. Feb. 2002 | 28. Feb. 2002 |
HEALTHCARE PROPERTY (HINCKLEY) LIMITED | 27. Apr. 2001 | 27. Apr. 2001 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PATIENTFIRST (HINCKLEY) LIMITED?
Überfällig | Nein |
---|---|
Nächster Jahresabschluss | |
Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. Dez. 2024 |
Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Sept. 2025 |
Letzter Jahresabschluss | |
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2023 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für PATIENTFIRST (HINCKLEY) LIMITED?
Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 07. Juni 2025 |
---|---|
Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 21. Juni 2025 |
Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 07. Juni 2024 |
Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für PATIENTFIRST (HINCKLEY) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
---|---|---|---|---|
Beendigung der Bestellung von David Leslie Jack Bateman als Geschäftsführer am 18. Juli 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2023 | 24 Seiten | AA | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Richard Howell am 03. Juli 2024 | 2 Seiten | CH01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Juni 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Harry Abraham Hyman als Geschäftsführer am 24. Apr. 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Mr Mark Davies als Direktor am 17. Apr. 2024 | 2 Seiten | AP01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2022 | 25 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Juni 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Ernennung von Mr Toby Newman als Sekretär am 10. Feb. 2023 | 2 Seiten | AP03 | ||
Beendigung der Bestellung von Paul Simon Kent Wright als Sekretär am 10. Feb. 2023 | 1 Seiten | TM02 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 26 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Juni 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 5th Floor Burdett House 15-16 Buckingham Street London United Kingdom WC2N 6DH United Kingdom zum 5th Floor Burdett House 15-16 Buckingham Street London WC2N 6DU am 05. Mai 2022 | 1 Seiten | AD01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr David Leslie Jack Bateman am 01. Apr. 2022 | 2 Seiten | CH01 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 5th Floor Greener House 66-68 Haymarket London England SW1Y 4RF zum 5th Floor Burdett House 15-16 Buckingham Street London United Kingdom WC2N 6DH am 27. Apr. 2022 | 1 Seiten | AD01 | ||
Ernennung von Mr David Leslie Jack Bateman als Direktor am 25. März 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||
Eintragung der Belastung 042075800015, erstellt am 06. Jan. 2022 | 53 Seiten | MR01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 24 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Juni 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Ernennung von Mr Paul Simon Kent Wright als Sekretär am 05. Jan. 2021 | 2 Seiten | AP03 | ||
Beendigung der Bestellung von Nexus Management Services Limited als Sekretär am 05. Jan. 2021 | 1 Seiten | TM02 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 24 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Juni 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Notification of Php Stl Limited as a person with significant control on 27. Juli 2018 | 2 Seiten | PSC02 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 23 Seiten | AA | ||
Wer sind die Geschäftsführer von PATIENTFIRST (HINCKLEY) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEWMAN, Toby | Sekretär | Burdett House 15-16 Buckingham Street WC2N 6DU London 5th Floor United Kingdom | 305561800001 | |||||||||||
AUSTIN, David Christopher | Geschäftsführer | Burdett House 15-16 Buckingham Street WC2N 6DU London 5th Floor United Kingdom | England | British | Chartered Surveyor | 131339590001 | ||||||||
DAVIES, Mark | Geschäftsführer | Burdett House 15-16 Buckingham Street WC2N 6DU London 5th Floor United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 321061420001 | ||||||||
HOWELL, Richard | Geschäftsführer | Burdett House 15-16 Buckingham Street WC2N 6DU London 5th Floor United Kingdom | England | British | Accountant | 164790590002 | ||||||||
BOWLES, Hazel | Sekretär | 97 High Street RG29 1LA Odiham Hampshire | British | Valuer | 82659500001 | |||||||||
WILDEN, Stephen Kenneth | Sekretär | Lawn Cottage Rectory Road Streatley RG8 9LE Reading Berkshire | British | 42543070001 | ||||||||||
WRIGHT, Paul Simon Kent | Sekretär | Burdett House 15-16 Buckingham Street WC2N 6DU London 5th Floor United Kingdom | 279268450001 | |||||||||||
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | Sekretär | SW1Y 6QB London Ground Floor 14 Ryder Street |
| 149899190001 | ||||||||||
NEXUS MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Sekretär | Greener House 66-68 Haymarket SW1Y 4RF London 5th Floor England |
| 57253330002 | ||||||||||
SECRETARIAT SERVICES LIMITED | Sekretär | Jarvis House Toft Green YO1 6JZ York | 70053320012 | |||||||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
BATEMAN, David Leslie Jack | Geschäftsführer | Burdett House 15-16 Buckingham Street WC2N 6DH London 5th Floor United Kingdom United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 294040290001 | ||||||||
BOWLES, Hazel | Geschäftsführer | 97 High Street RG29 1LA Odiham Hampshire | British | Valuer | 82659500001 | |||||||||
BOWLES, Jonathan | Geschäftsführer | 97 High Street RG29 1LA Odiham Hampshire | England | British | Project Manager | 67579490002 | ||||||||
CARLISLE, Celia Diana | Geschäftsführer | 163 Portland Road W11 4LR London | United Kingdom | British | Project Financier | 63756390001 | ||||||||
GARDINER, Patrick Hugh | Geschäftsführer | Greystones Cornsland CM14 4JL Brentwood Essex | British | Director | 63883470001 | |||||||||
HAMBRO, James Daryl | Geschäftsführer | 14 Ryder Street SW1Y 6QB London Ground Floor Ryder Court | United Kingdom | British | Company Director | 53684400001 | ||||||||
HAMILTON, Andrew Mark | Geschäftsführer | Henham House Church Street Henham CM22 6AN Bishops Stortford Hertfordshire | England | British | Director | 85571560001 | ||||||||
HOLLAND, Philip John | Geschäftsführer | Greener House 66-68 Haymarket SW1Y 4RF London 5th Floor England England | England | British | Chartered Accountant | 163838050001 | ||||||||
HYMAN, Harry Abraham | Geschäftsführer | Burdett House 15-16 Buckingham Street WC2N 6DU London 5th Floor United Kingdom | England | British | Chartered Accountant | 35560380005 | ||||||||
JOHNSON, Robert Nigel | Geschäftsführer | 16 Kirkwell Bishopthorpe YO23 2RZ York Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 57954340003 | ||||||||
LAFFERTY, Henry | Geschäftsführer | Windmill House 4 High Street MK44 1PG Sharnbrook Beds | England | British | Accounant | 146249130001 | ||||||||
MASON, Geoffrey Keith Howard | Geschäftsführer | Downing House Lower Road SG8 0EG Croydon Royston Cambridgeshire | United Kingdom | British | Chartered Secretary | 37404250003 | ||||||||
SINCLAIR, Michael Jeffrey, Dr | Geschäftsführer | Flat 6 11 Hyde Park Gardens W2 2LU London | United Kingdom | British | Businessman | 73399780002 | ||||||||
STACEY, Paul Quentin Cullum | Geschäftsführer | 3 Catherine Wheel Yard SW1A 1DR London | United Kingdom | British | Director | 81598360001 | ||||||||
SUTTON, Andrew John | Geschäftsführer | Browns End Cottage Browns End Road CM6 2BE Broxted Essex | United Kingdom | British | Divisional Chief Executive | 110729740001 | ||||||||
VAUGHAN, Margaret Helen | Geschäftsführer | 14 Ryder Street SW1Y 6QB London Ground Floor Ryder Court | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 123167120001 | ||||||||
WALKER-ARNOTT, Timothy David | Geschäftsführer | Greener House 66-68 Haymarket SW1Y 4RF London 5th Floor England | England | British | Chartered Surveyor | 131266520001 | ||||||||
WILDEN, Stephen Kenneth | Geschäftsführer | Lawn Cottage Rectory Road Streatley RG8 9LE Reading Berkshire | England | British | Finance Director | 42543070001 | ||||||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei PATIENTFIRST (HINCKLEY) LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Php Stl Limited | 27. Juli 2018 | Greener House 66-68 Haymarket SW1Y 4RF London 5th Floor United Kingdom United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Primary Health Properties Plc | 01. Juli 2016 | 66-68 Haymarket SW1Y 4RF London 5th Floor, Greener House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat PATIENTFIRST (HINCKLEY) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 06. Jan. 2022 Geliefert am 10. Jan. 2022 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Land at medical centre, southfields road, hinckley with title number LT336025, as more particularly described in schedule 2 part I of the instrument.. Land and buildings on the north side of. Southfield road, hinckley with title number LT335939, as more particularly described in schedule 2 part I of the instrument. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 27. Juli 2018 Geliefert am 03. Aug. 2018 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung First legal mortgage over the freehold land known as medical centre, southfields road, hinckley and the freehold land known as land and buildings on the north side of southfield road, hinckley (title numbers: LT336025 and LT335939).. For further details please see the instrument. Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 02. Apr. 2012 Geliefert am 04. Apr. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 30. Apr. 2010 Geliefert am 30. Apr. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben F/H property k/a medical centre, southfield road, hinkley t/no's LT335939 and LT336025. By way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 30. Apr. 2010 Geliefert am 30. Apr. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Medical centre, southfield road, hinkley t/no's LT335939 and LT336025. All plant and machinery. All isurance contracts and insurance policies. The rental income see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed and floating security agreement | Erstellt am 30. Apr. 2010 Geliefert am 30. Apr. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 28. Okt. 2008 Geliefert am 01. Nov. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any group company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Hinckley medical centre and pharmacy station view southfield road hinckley t/nos LT336025 and LT335939 by way of fixed charge fixed plant and machinery fixtures and fittings any present and future goodwill see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 17. Okt. 2007 Geliefert am 20. Okt. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H medical centre southfield road and land and buildings on the north side of southfield road hinckley and bosworth leicestershire t/nos LT336025/LT335969. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of assignment | Erstellt am 22. Dez. 2005 Geliefert am 07. Jan. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from patientfirst partnership limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Land and buildings on the north east side of southfield road hinckley leicestershire all right title benefits and interests to all moneys. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental deed being supplemental to a deed of legal charge dated 21 december 2001 and | Erstellt am 22. Dez. 2005 Geliefert am 05. Jan. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from patientfirst partnerships limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Land and buildings on the north east side of southfield road hinkley leicestershire, together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fixed plant and machinery thereon, all improvements and additions thereto and all easements rights licences appurtenant thereto, subject to and with the benefit of all existing leases underleases tenancies agreements to lease rights covenants under conditions affecting the same but otherwise free from encumbrance,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of assignment | Erstellt am 11. Aug. 2003 Geliefert am 16. Aug. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from jarvis primary health limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All the rights, titles, benefits and interests, present and future, of the company to all moneys from time to time due, owing or incurred to the company under the lease in respect of medical centre and pharmacy at 124 southfield road, hinckley, leicestershire (the lease). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of release, amendment and security | Erstellt am 21. Dez. 2001 Geliefert am 09. Jan. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any group member to the chargee as trustee for itself and other lenders or any lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The medical centre 124 southfield road hinckley together with all buildings erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fixed plant and machinery..all monies deposited with the trustee..floating charge the whole of the company's undertaking. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of assignment | Erstellt am 21. Dez. 2001 Geliefert am 08. Jan. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All the company's right title and interest in and to all moneys from time to time due or to become due from the company under the lease of the medical centre southfield road hinckley leicester. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of legal charge | Erstellt am 21. Dez. 2001 Geliefert am 08. Jan. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The medical centre 124 southfield road hinckey leicester LT335939 together with all buildings erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fitting thereon. All monies deposited with the trustee. By way of floating charge all property assets rights revenues present and future including uncalled share capital (if any). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental deed | Erstellt am 27. Juli 2001 Geliefert am 10. Aug. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys and indebtedness due from and all moneys covenanted to be paid by any group member to the chargee as trustee for itself and any other lender supplemental to the legal charge dated 14 january 2000 | |
Kurze Angaben The medical centre 124 southfield road hinckley together with all buildings erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fitting thereon. All monies deposited with the trustee. By way of floating charge all property assets rights revenues present and future including uncalled share capital (if any). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0