PATIENTFIRST (HINCKLEY) LIMITED

PATIENTFIRST (HINCKLEY) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnamePATIENTFIRST (HINCKLEY) LIMITED
    UnternehmensstatusAktiv
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04207580
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von PATIENTFIRST (HINCKLEY) LIMITED?

    • Allgemeinarztpraxen (86210) / Gesundheits- und Sozialwesen

    Wo befindet sich PATIENTFIRST (HINCKLEY) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    5th Floor Burdett House 15-16
    Buckingham Street
    WC2N 6DU London
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von PATIENTFIRST (HINCKLEY) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    JPH (HINCKLEY) LIMITED28. Feb. 200228. Feb. 2002
    HEALTHCARE PROPERTY (HINCKLEY) LIMITED27. Apr. 200127. Apr. 2001

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PATIENTFIRST (HINCKLEY) LIMITED?

    ÜberfälligNein
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am31. Dez. 2024
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am30. Sept. 2025
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2023

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für PATIENTFIRST (HINCKLEY) LIMITED?

    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis07. Juni 2025
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung21. Juni 2025
    Letzte Bestätigungsbescheinigung
    Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis07. Juni 2024
    ÜberfälligNein

    Welche sind die letzten Einreichungen für PATIENTFIRST (HINCKLEY) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Beendigung der Bestellung von David Leslie Jack Bateman als Geschäftsführer am 18. Juli 2024

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2023

    24 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr Richard Howell am 03. Juli 2024

    2 SeitenCH01

    Bestätigungserklärung erstellt am 07. Juni 2024 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Harry Abraham Hyman als Geschäftsführer am 24. Apr. 2024

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Mark Davies als Direktor am 17. Apr. 2024

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2022

    25 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 07. Juni 2023 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Ernennung von Mr Toby Newman als Sekretär am 10. Feb. 2023

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Paul Simon Kent Wright als Sekretär am 10. Feb. 2023

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2021

    26 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 07. Juni 2022 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 5th Floor Burdett House 15-16 Buckingham Street London United Kingdom WC2N 6DH United Kingdom zum 5th Floor Burdett House 15-16 Buckingham Street London WC2N 6DU am 05. Mai 2022

    1 SeitenAD01

    Änderung der Details des Direktors für Mr David Leslie Jack Bateman am 01. Apr. 2022

    2 SeitenCH01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 5th Floor Greener House 66-68 Haymarket London England SW1Y 4RF zum 5th Floor Burdett House 15-16 Buckingham Street London United Kingdom WC2N 6DH am 27. Apr. 2022

    1 SeitenAD01

    Ernennung von Mr David Leslie Jack Bateman als Direktor am 25. März 2022

    2 SeitenAP01

    Eintragung der Belastung 042075800015, erstellt am 06. Jan. 2022

    53 SeitenMR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2020

    24 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 07. Juni 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Ernennung von Mr Paul Simon Kent Wright als Sekretär am 05. Jan. 2021

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Nexus Management Services Limited als Sekretär am 05. Jan. 2021

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2019

    24 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 05. Juni 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Notification of Php Stl Limited as a person with significant control on 27. Juli 2018

    2 SeitenPSC02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018

    23 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von PATIENTFIRST (HINCKLEY) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    NEWMAN, Toby
    Burdett House 15-16
    Buckingham Street
    WC2N 6DU London
    5th Floor
    United Kingdom
    Sekretär
    Burdett House 15-16
    Buckingham Street
    WC2N 6DU London
    5th Floor
    United Kingdom
    305561800001
    AUSTIN, David Christopher
    Burdett House 15-16
    Buckingham Street
    WC2N 6DU London
    5th Floor
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Burdett House 15-16
    Buckingham Street
    WC2N 6DU London
    5th Floor
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Surveyor131339590001
    DAVIES, Mark
    Burdett House 15-16
    Buckingham Street
    WC2N 6DU London
    5th Floor
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Burdett House 15-16
    Buckingham Street
    WC2N 6DU London
    5th Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector321061420001
    HOWELL, Richard
    Burdett House 15-16
    Buckingham Street
    WC2N 6DU London
    5th Floor
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Burdett House 15-16
    Buckingham Street
    WC2N 6DU London
    5th Floor
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant164790590002
    BOWLES, Hazel
    97 High Street
    RG29 1LA Odiham
    Hampshire
    Sekretär
    97 High Street
    RG29 1LA Odiham
    Hampshire
    BritishValuer82659500001
    WILDEN, Stephen Kenneth
    Lawn Cottage Rectory Road
    Streatley
    RG8 9LE Reading
    Berkshire
    Sekretär
    Lawn Cottage Rectory Road
    Streatley
    RG8 9LE Reading
    Berkshire
    British42543070001
    WRIGHT, Paul Simon Kent
    Burdett House 15-16
    Buckingham Street
    WC2N 6DU London
    5th Floor
    United Kingdom
    Sekretär
    Burdett House 15-16
    Buckingham Street
    WC2N 6DU London
    5th Floor
    United Kingdom
    279268450001
    J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT LIMITED
    SW1Y 6QB London
    Ground Floor 14 Ryder Street
    Sekretär
    SW1Y 6QB London
    Ground Floor 14 Ryder Street
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer2176004
    149899190001
    NEXUS MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    Sekretär
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    Art des AusweisesBritische Gesellschaft mit beschränkter Haftung
    Registrierungsnummer4187765
    57253330002
    SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    Jarvis House
    Toft Green
    YO1 6JZ York
    Sekretär
    Jarvis House
    Toft Green
    YO1 6JZ York
    70053320012
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BATEMAN, David Leslie Jack
    Burdett House
    15-16 Buckingham Street
    WC2N 6DH London
    5th Floor
    United Kingdom
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Burdett House
    15-16 Buckingham Street
    WC2N 6DH London
    5th Floor
    United Kingdom
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Surveyor294040290001
    BOWLES, Hazel
    97 High Street
    RG29 1LA Odiham
    Hampshire
    Geschäftsführer
    97 High Street
    RG29 1LA Odiham
    Hampshire
    BritishValuer82659500001
    BOWLES, Jonathan
    97 High Street
    RG29 1LA Odiham
    Hampshire
    Geschäftsführer
    97 High Street
    RG29 1LA Odiham
    Hampshire
    EnglandBritishProject Manager67579490002
    CARLISLE, Celia Diana
    163 Portland Road
    W11 4LR London
    Geschäftsführer
    163 Portland Road
    W11 4LR London
    United KingdomBritishProject Financier63756390001
    GARDINER, Patrick Hugh
    Greystones
    Cornsland
    CM14 4JL Brentwood
    Essex
    Geschäftsführer
    Greystones
    Cornsland
    CM14 4JL Brentwood
    Essex
    BritishDirector63883470001
    HAMBRO, James Daryl
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Ground Floor Ryder Court
    Geschäftsführer
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Ground Floor Ryder Court
    United KingdomBritishCompany Director53684400001
    HAMILTON, Andrew Mark
    Henham House
    Church Street Henham
    CM22 6AN Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Henham House
    Church Street Henham
    CM22 6AN Bishops Stortford
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector85571560001
    HOLLAND, Philip John
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    England
    Geschäftsführer
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    England
    EnglandBritishChartered Accountant163838050001
    HYMAN, Harry Abraham
    Burdett House 15-16
    Buckingham Street
    WC2N 6DU London
    5th Floor
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Burdett House 15-16
    Buckingham Street
    WC2N 6DU London
    5th Floor
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant35560380005
    JOHNSON, Robert Nigel
    16 Kirkwell
    Bishopthorpe
    YO23 2RZ York
    Yorkshire
    Geschäftsführer
    16 Kirkwell
    Bishopthorpe
    YO23 2RZ York
    Yorkshire
    United KingdomBritishDirector57954340003
    LAFFERTY, Henry
    Windmill House
    4 High Street
    MK44 1PG Sharnbrook
    Beds
    Geschäftsführer
    Windmill House
    4 High Street
    MK44 1PG Sharnbrook
    Beds
    EnglandBritishAccounant146249130001
    MASON, Geoffrey Keith Howard
    Downing House
    Lower Road
    SG8 0EG Croydon Royston
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    Downing House
    Lower Road
    SG8 0EG Croydon Royston
    Cambridgeshire
    United KingdomBritishChartered Secretary37404250003
    SINCLAIR, Michael Jeffrey, Dr
    Flat 6
    11 Hyde Park Gardens
    W2 2LU London
    Geschäftsführer
    Flat 6
    11 Hyde Park Gardens
    W2 2LU London
    United KingdomBritishBusinessman73399780002
    STACEY, Paul Quentin Cullum
    3 Catherine Wheel Yard
    SW1A 1DR London
    Geschäftsführer
    3 Catherine Wheel Yard
    SW1A 1DR London
    United KingdomBritishDirector81598360001
    SUTTON, Andrew John
    Browns End Cottage
    Browns End Road
    CM6 2BE Broxted
    Essex
    Geschäftsführer
    Browns End Cottage
    Browns End Road
    CM6 2BE Broxted
    Essex
    United KingdomBritishDivisional Chief Executive110729740001
    VAUGHAN, Margaret Helen
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Ground Floor Ryder Court
    Geschäftsführer
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Ground Floor Ryder Court
    United KingdomBritishChartered Accountant123167120001
    WALKER-ARNOTT, Timothy David
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    Geschäftsführer
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    EnglandBritishChartered Surveyor131266520001
    WILDEN, Stephen Kenneth
    Lawn Cottage Rectory Road
    Streatley
    RG8 9LE Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Lawn Cottage Rectory Road
    Streatley
    RG8 9LE Reading
    Berkshire
    EnglandBritishFinance Director42543070001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei PATIENTFIRST (HINCKLEY) LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    United Kingdom
    United Kingdom
    27. Juli 2018
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    United Kingdom
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (England And Wales)
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer11228141
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.
    Primary Health Properties Plc
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor, Greener House
    England
    01. Juli 2016
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor, Greener House
    England
    Nein
    RechtsformPublic Limited Company
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageCompanies Act
    RegistrierungsortEngland & Wales
    Registrierungsnummer03033634
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.

    Hat PATIENTFIRST (HINCKLEY) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 06. Jan. 2022
    Geliefert am 10. Jan. 2022
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Land at medical centre, southfields road, hinckley with title number LT336025, as more particularly described in schedule 2 part I of the instrument.. Land and buildings on the north side of. Southfield road, hinckley with title number LT335939, as more particularly described in schedule 2 part I of the instrument.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Santander UK PLC
    Transaktionen
    • 10. Jan. 2022Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 27. Juli 2018
    Geliefert am 03. Aug. 2018
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    First legal mortgage over the freehold land known as medical centre, southfields road, hinckley and the freehold land known as land and buildings on the north side of southfield road, hinckley (title numbers: LT336025 and LT335939).. For further details please see the instrument.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Santander UK PLC as Security Agent
    Transaktionen
    • 03. Aug. 2018Registrierung einer Belastung (MR01)
    Debenture
    Erstellt am 02. Apr. 2012
    Geliefert am 04. Apr. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 04. Apr. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 13. Apr. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Apr. 2010
    Geliefert am 30. Apr. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    F/H property k/a medical centre, southfield road, hinkley t/no's LT335939 and LT336025. By way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 30. Apr. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 16. Juni 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 30. Apr. 2010
    Geliefert am 30. Apr. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Medical centre, southfield road, hinkley t/no's LT335939 and LT336025. All plant and machinery. All isurance contracts and insurance policies. The rental income see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abbey National Treasury Services PLC
    Transaktionen
    • 30. Apr. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 16. Juni 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Fixed and floating security agreement
    Erstellt am 30. Apr. 2010
    Geliefert am 30. Apr. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Allied Irish Banks PLC
    Transaktionen
    • 30. Apr. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 16. Juni 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Okt. 2008
    Geliefert am 01. Nov. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or any group company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Hinckley medical centre and pharmacy station view southfield road hinckley t/nos LT336025 and LT335939 by way of fixed charge fixed plant and machinery fixtures and fittings any present and future goodwill see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dr Michael Sinclair
    Transaktionen
    • 01. Nov. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Feb. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 17. Okt. 2007
    Geliefert am 20. Okt. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H medical centre southfield road and land and buildings on the north side of southfield road hinckley and bosworth leicestershire t/nos LT336025/LT335969. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Nov. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment
    Erstellt am 22. Dez. 2005
    Geliefert am 07. Jan. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from patientfirst partnership limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Land and buildings on the north east side of southfield road hinckley leicestershire all right title benefits and interests to all moneys. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The General Practice Finance Corporation Limited
    Transaktionen
    • 07. Jan. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Feb. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Supplemental deed being supplemental to a deed of legal charge dated 21 december 2001 and
    Erstellt am 22. Dez. 2005
    Geliefert am 05. Jan. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from patientfirst partnerships limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Land and buildings on the north east side of southfield road hinkley leicestershire, together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fixed plant and machinery thereon, all improvements and additions thereto and all easements rights licences appurtenant thereto, subject to and with the benefit of all existing leases underleases tenancies agreements to lease rights covenants under conditions affecting the same but otherwise free from encumbrance,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The General Practice Finance Corporation Limited
    Transaktionen
    • 05. Jan. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Feb. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of assignment
    Erstellt am 11. Aug. 2003
    Geliefert am 16. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from jarvis primary health limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the rights, titles, benefits and interests, present and future, of the company to all moneys from time to time due, owing or incurred to the company under the lease in respect of medical centre and pharmacy at 124 southfield road, hinckley, leicestershire (the lease). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The General Practice Finance Corporation Limited
    Transaktionen
    • 16. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Feb. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of release, amendment and security
    Erstellt am 21. Dez. 2001
    Geliefert am 09. Jan. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any group member to the chargee as trustee for itself and other lenders or any lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The medical centre 124 southfield road hinckley together with all buildings erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fixed plant and machinery..all monies deposited with the trustee..floating charge the whole of the company's undertaking.
    Berechtigte Personen
    • The General Practice Finance Corporation Limited
    Transaktionen
    • 09. Jan. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Feb. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of assignment
    Erstellt am 21. Dez. 2001
    Geliefert am 08. Jan. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the company's right title and interest in and to all moneys from time to time due or to become due from the company under the lease of the medical centre southfield road hinckley leicester. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The General Practice Finance Corporation Limited and Cgnu PLC
    Transaktionen
    • 08. Jan. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Feb. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of legal charge
    Erstellt am 21. Dez. 2001
    Geliefert am 08. Jan. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The medical centre 124 southfield road hinckey leicester LT335939 together with all buildings erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fitting thereon. All monies deposited with the trustee. By way of floating charge all property assets rights revenues present and future including uncalled share capital (if any). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The General Practice Finance Corporation Limited and Cgnu PLC
    Transaktionen
    • 08. Jan. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Feb. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Supplemental deed
    Erstellt am 27. Juli 2001
    Geliefert am 10. Aug. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys and indebtedness due from and all moneys covenanted to be paid by any group member to the chargee as trustee for itself and any other lender supplemental to the legal charge dated 14 january 2000
    Kurze Angaben
    The medical centre 124 southfield road hinckley together with all buildings erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fitting thereon. All monies deposited with the trustee. By way of floating charge all property assets rights revenues present and future including uncalled share capital (if any).
    Berechtigte Personen
    • The General Practice Finance Corporation Limited
    Transaktionen
    • 10. Aug. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Feb. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0