AVENUE NOMINEES II LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameAVENUE NOMINEES II LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04208806
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von AVENUE NOMINEES II LIMITED?

    • Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich AVENUE NOMINEES II LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    180 Great Portland Street
    London
    W1W 5QZ
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von AVENUE NOMINEES II LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Mai 2013

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für AVENUE NOMINEES II LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für AVENUE NOMINEES II LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Mai 2013

    2 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Mai 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital21. Mai 2013

    Kapitalaufstellung am 21. Mai 2013

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Mai 2012

    2 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Mai 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Mai 2011

    3 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Mai 2010

    3 SeitenAA

    Ernennung von Mrs Patricia Anne Watson als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Darryl Noik als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Darryl Sean Noik am 01. Mai 2010

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Mai 2009

    3 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Mai 2008

    3 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Mai 2007

    3 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    2 Seiten363a

    legacy

    2 Seiten403a

    Wer sind die Geschäftsführer von AVENUE NOMINEES II LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    FARRANT, David Jonathan
    6 Charlwood Drive
    KT22 0HD Oxshott
    Surrey
    Sekretär
    6 Charlwood Drive
    KT22 0HD Oxshott
    Surrey
    British58574750004
    WATSON, Patricia Anne
    180 Great Portland Street
    London
    W1W 5QZ
    Geschäftsführer
    180 Great Portland Street
    London
    W1W 5QZ
    EnglandBritish90326340001
    TOMKINS, Glenn Douglas
    2 Hillside Grove
    Mill Hill
    NW7 2LR London
    Sekretär
    2 Hillside Grove
    Mill Hill
    NW7 2LR London
    British37725800001
    FIDSEC LIMITED
    PO BOX 175
    Frances House, Sir William Place St Peter Port
    GY1 4HQ Guernsey
    Sekretär
    PO BOX 175
    Frances House, Sir William Place St Peter Port
    GY1 4HQ Guernsey
    60914590001
    ABBOTTS, Timothy John
    5 Lynwood Avenue
    KT17 4LQ Epsom
    Surrey
    Geschäftsführer
    5 Lynwood Avenue
    KT17 4LQ Epsom
    Surrey
    British60937580003
    CLAYTON, Robert Bernard
    22 Springfields
    EN10 7LX Broxbourne
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    22 Springfields
    EN10 7LX Broxbourne
    Hertfordshire
    United KingdomBritish68958570001
    NOIK, Darryl Sean
    12 Foxmore Street
    SW11 4PU London
    Geschäftsführer
    12 Foxmore Street
    SW11 4PU London
    United KingdomBritish62951950001
    ROBERTS, Martin Lindley
    Widbrook House
    Sutton Road
    SL6 9RD Cookham
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Widbrook House
    Sutton Road
    SL6 9RD Cookham
    Berkshire
    United KingdomBritish67892370002
    SORENSEN, Philip Clement Claude Christian
    Crossinglands
    Salford Road Aspley Guise
    MK17 8HZ Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Crossinglands
    Salford Road Aspley Guise
    MK17 8HZ Milton Keynes
    Buckinghamshire
    EnglandBritish81678880001
    TOMKINS, Glenn Douglas
    2 Hillside Grove
    Mill Hill
    NW7 2LR London
    Geschäftsführer
    2 Hillside Grove
    Mill Hill
    NW7 2LR London
    United KingdomBritish37725800001
    ADL ONE LIMITED
    Frances House
    Sir William Place
    GY1 4HQ St Peter Port
    Guernsey
    Geschäftsführer
    Frances House
    Sir William Place
    GY1 4HQ St Peter Port
    Guernsey
    81016220001
    ADL TWO LIMITED
    Frances House
    Sir William Place
    GY1 4HQ St Peter Port
    Channel Islands
    Geschäftsführer
    Frances House
    Sir William Place
    GY1 4HQ St Peter Port
    Channel Islands
    79946980001

    Hat AVENUE NOMINEES II LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 05. Juli 2006
    Geliefert am 18. Juli 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from dunning properties limited or the mortgagor and avenue nominees I limited to the beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property at 100 avenue road swiss cottage london t/n NGL590790 and NGL832601 and any part or parts of it including all rights attached or appurtenant to it and all buildings fixtures fittings plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Valletta Property Limited (The Beneficiary)
    Transaktionen
    • 18. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. März 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Juli 2006
    Geliefert am 13. Juli 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any other company which is a member of the same group of companies on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    100 avenue road swiss cottage london t/n's NGL590790 and NGL8232601, together with all buildings fixtures fixed plant and machinery and the proceeds of sale.floating charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment, fixed charge over the benefit of all contracts agreements and covenants,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 13. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 05. Juli 2006
    Geliefert am 13. Juli 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any other company which is a member of the same group of companies on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 13. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 02. Dez. 2004
    Geliefert am 17. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (In Its Capacity as Security Trustee of Thefinance Parties)
    Transaktionen
    • 17. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. Okt. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 01. März 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Dez. 2004
    Geliefert am 17. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or eponine limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 100 avenue road swiss cottage london t/no NGL590790 and NGL832601. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor & Company of the Bank of Scotland (In Its Capacity as Security Trustee for Thefinance Parties)
    Transaktionen
    • 17. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. Okt. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 01. März 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Third party debenture
    Erstellt am 15. Juli 2002
    Geliefert am 26. Juli 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and hawk property holdings limited (the borrower) to all or any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Morgan Stanley Mortgage Servicing Limited (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 26. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Jan. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Nominee deed of charge
    Erstellt am 22. Mai 2001
    Geliefert am 07. Juni 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys obligations or liabilities due or to become due from the company to the chargee or the security trustee in any manner whatsoever under or in respect of the loan agreeement, the charge and any other transaction document
    Kurze Angaben
    All right title interest and benefit in and to the property : all f/h andl/h property k/a 100 avenue road london t/n NGL590790 and all other property belonging to it at the date of the charge. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ubs Ag
    Transaktionen
    • 07. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Okt. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge between guardian property investments limited (borrower) and ubs ag, london branch (security trustee)
    Erstellt am 20. März 2000
    Erworben am 22. Mai 2001
    Geliefert am 12. Juni 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies obligations or liabilities (actual or contingent) of whatever nature which are at the date of the charge or may at any time be or become due owing or incurred to the bank or the security trustee by the borrower in any manner whatsoever under or in respect of the loan agreement, the charge and any other transaction documents (all terms as defined)
    Kurze Angaben
    By way of first legal mortgage 120 holborn, london EC1, london borough of camden t/n NGL291482, sea containers house, 20-22 upper ground, london SE1 london borough of southwark t/n SGL185368, johnson smirke building, royal mint court, east smithfield, london EC3, london borough of tower hamlets t/n EGL209636 (for further details of property charged please see schedule to form 395) including all estates, rights and interests in all f/h and l/h property.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ubs Ag (Security Trustee)
    Transaktionen
    • 12. Juni 2001Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 30. Okt. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0