SAPPHIRE (BURNLEY) (NO.2) NOMINEE LIMITED

SAPPHIRE (BURNLEY) (NO.2) NOMINEE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSAPPHIRE (BURNLEY) (NO.2) NOMINEE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04208919
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von SAPPHIRE (BURNLEY) (NO.2) NOMINEE LIMITED?

    • (7487) /

    Wo befindet sich SAPPHIRE (BURNLEY) (NO.2) NOMINEE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    GRANT THORNTON UK LLP
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von SAPPHIRE (BURNLEY) (NO.2) NOMINEE LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    G.P.E. (BURNLEY) (NO.2) NOMINEE LIMITED30. Mai 200130. Mai 2001
    SHELFCO (NO.2458) LIMITED01. Mai 200101. Mai 2001

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SAPPHIRE (BURNLEY) (NO.2) NOMINEE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für SAPPHIRE (BURNLEY) (NO.2) NOMINEE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 23. Aug. 2011

    11 Seiten2.35B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 23. Feb. 2011

    15 Seiten2.24B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    6 Seiten2.16B

    Vorschlag des Verwalters

    18 Seiten2.17B

    Vorschlag des Verwalters

    17 Seiten2.17B

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 25 Harley Street London W1G 9BR am 06. Sept. 2010

    2 SeitenAD01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Malcolm Robin Turner am 01. Jan. 2010

    2 SeitenCH01

    Jahresrückblick erstellt bis 29. Apr. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital10. Mai 2010

    Kapitalaufstellung am 10. Mai 2010

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Stephane Abraham Joseph Nahum am 01. Jan. 2010

    3 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Malcolm Robin Turner am 01. Jan. 2010

    3 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    7 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    7 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006

    3 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288c

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005

    4 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    1 Seiten288c

    Wer sind die Geschäftsführer von SAPPHIRE (BURNLEY) (NO.2) NOMINEE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    E L SERVICES LIMITED
    25 Harley Street
    W1G 9BR London
    Sekretär
    25 Harley Street
    W1G 9BR London
    78638580003
    NAHUM, Stephane Abraham Joseph
    Millbank Tower
    21-24 Millbank
    SW1P 4QP London
    4th Floor
    Geschäftsführer
    Millbank Tower
    21-24 Millbank
    SW1P 4QP London
    4th Floor
    EnglandFrench99292580003
    TURNER, Malcolm Robin
    Millbank
    SW1P 4QP London
    4th Floor Millbank Tower 21-24
    Geschäftsführer
    Millbank
    SW1P 4QP London
    4th Floor Millbank Tower 21-24
    United KingdomBritish60293070008
    BLAIR, James Don
    9 Rosebank Grove
    EH5 3QN Edinburgh
    Midlothian
    Sekretär
    9 Rosebank Grove
    EH5 3QN Edinburgh
    Midlothian
    British85605320001
    MARTIN, Desna Lee
    72 Thurleigh Road
    SW12 8UD London
    Sekretär
    72 Thurleigh Road
    SW12 8UD London
    British62162550003
    EPS SECRETARIES LIMITED
    Lacon House
    Theobalds Road
    WC1X 8RW London
    Sekretär
    Lacon House
    Theobalds Road
    WC1X 8RW London
    67339580001
    BARROTT, Ronald Stephen
    Foxborough
    Drovers Hill
    GL55 6UW Chipping Campden
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Foxborough
    Drovers Hill
    GL55 6UW Chipping Campden
    Gloucestershire
    EnglandBritish9892700002
    BRADLEY, Pauline Anne
    Spruce Tree House
    By Gleneagles
    PH4 1RG Auchterarder
    Perthshire
    Geschäftsführer
    Spruce Tree House
    By Gleneagles
    PH4 1RG Auchterarder
    Perthshire
    British122926460001
    CORCORAN, John Anthony
    7 Milton Avenue
    Mosman
    New South Wales 2088
    Australia
    Geschäftsführer
    7 Milton Avenue
    Mosman
    New South Wales 2088
    Australia
    Australian79804100001
    CUMMINGS, Peter Joseph
    Glen View
    6 Barloan Crescent
    G82 2AT Dumbarton
    Dunbartonshire
    Geschäftsführer
    Glen View
    6 Barloan Crescent
    G82 2AT Dumbarton
    Dunbartonshire
    ScotlandBritish68241910003
    GITTENS, Paul Alexander
    29 Woodland Way
    Woodford Wells
    IG8 0QQ Woodford
    Essex
    Geschäftsführer
    29 Woodland Way
    Woodford Wells
    IG8 0QQ Woodford
    Essex
    British14920090001
    KERR, Donald
    28 Burnbank
    EH20 9NE Straiton
    Midlothian
    Geschäftsführer
    28 Burnbank
    EH20 9NE Straiton
    Midlothian
    British84247450001
    MACKINTOSH, Iain Stewart
    9 Greenbank Terrace
    EH10 6ER Edinburgh
    Midlothian
    Geschäftsführer
    9 Greenbank Terrace
    EH10 6ER Edinburgh
    Midlothian
    British94163020001
    MACLEOD, Alan Donald Ewen
    12 Violet Terrace
    EH11 1NZ Edinburgh
    Midlothian
    Geschäftsführer
    12 Violet Terrace
    EH11 1NZ Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish107116780001
    MCDIVEN, Ross Arnold
    U 9 38 Bay Street
    NSW 2028 Double Bay
    New South Wales
    Australia
    Geschäftsführer
    U 9 38 Bay Street
    NSW 2028 Double Bay
    New South Wales
    Australia
    Australian108719480001
    MIDDLETON, Douglas Alister
    16 Wesley Crescent
    Bonnyrigg
    EH19 3RT Edinburgh
    Geschäftsführer
    16 Wesley Crescent
    Bonnyrigg
    EH19 3RT Edinburgh
    British73738070001
    MURPHY, Kevin Joseph John
    77b Home Park Road
    Wimbledon
    SW19 7HS London
    Geschäftsführer
    77b Home Park Road
    Wimbledon
    SW19 7HS London
    British106832380002
    NATHAN, Timothy Paul
    19 Elms Avenue
    N10 2JN London
    Geschäftsführer
    19 Elms Avenue
    N10 2JN London
    EnglandBritish104162560001
    PESKIN, Richard Martin
    41 Circus Road
    St Johns Wood
    NW8 9JH London
    Geschäftsführer
    41 Circus Road
    St Johns Wood
    NW8 9JH London
    EnglandBritish35018930001
    SHAW, Peter David Marley
    Worth Cottage
    9 Batchworth Heath
    WD3 1QB Rickmansworth
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Worth Cottage
    9 Batchworth Heath
    WD3 1QB Rickmansworth
    Hertfordshire
    British74197750001
    WATTERS, Michael John
    51b Chesham Road
    Bryanston
    South Africa
    Geschäftsführer
    51b Chesham Road
    Bryanston
    South Africa
    South African79419220001
    WHITELEY, John Howard
    14 Fallows Green
    AL5 4HD Harpenden
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    14 Fallows Green
    AL5 4HD Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish48980090002
    MIKJON LIMITED
    Lacon House 84 Theobald's Road
    WC1X 8RW London
    Geschäftsführer
    Lacon House 84 Theobald's Road
    WC1X 8RW London
    72341560001

    Hat SAPPHIRE (BURNLEY) (NO.2) NOMINEE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 31. Aug. 2005
    Geliefert am 03. Sept. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 03. Sept. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 31. Aug. 2005
    Geliefert am 02. Sept. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property k/a the mall, chancery walk, st james's street and curzon street, burnley t/no LA271132 and the f/h property k/a on the north west side of curzon street, burnley t/no LA887602 for further property charged please refer to the form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 02. Sept. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge between the company and the governor and company of the bank of scotland (as security trustee for the lenders (the "security trustee")
    Erstellt am 16. Nov. 2001
    Geliefert am 26. Nov. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities of the company to the lenders (or any of them) whether actual, contingent, sole, joint and/or several or otherwise
    Kurze Angaben
    Charter walk shopping centre burnley t/n LA757535, LA271132 LA887606 LA887602 and l/h LA271132 plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 26. Nov. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 16. Nov. 2001
    Geliefert am 22. Nov. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All obligations and liabilities due or to become due from the company (the "chargor") to the lenders (as defined)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 22. Nov. 2001Registrierung einer Belastung (395)

    Hat SAPPHIRE (BURNLEY) (NO.2) NOMINEE LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    24. Aug. 2010Beginn der Verwaltung
    23. Aug. 2011Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Malcolm Brian Shierson
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praktiker
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Martin Gilbert Ellis
    30 Finsbury Square
    London
    EC2P 2YU
    Praktiker
    30 Finsbury Square
    London
    EC2P 2YU
    Daniel Robert Whiteley Smith
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    Praktiker
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0