HIGH PRESSURE PUMPS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | HIGH PRESSURE PUMPS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04212865 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HIGH PRESSURE PUMPS LIMITED?
- (2956) /
Wo befindet sich HIGH PRESSURE PUMPS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 8 East Portway Portway Industrial Estate SP10 3LU Andover Hampshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von HIGH PRESSURE PUMPS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| WOMA (GB) LIMITED | 13. Apr. 2003 | 13. Apr. 2003 |
| PEGASUS SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED | 08. Juni 2001 | 08. Juni 2001 |
| BONDCO 873 LIMITED | 09. Mai 2001 | 09. Mai 2001 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HIGH PRESSURE PUMPS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für HIGH PRESSURE PUMPS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 2 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2009 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen Jones als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2008 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2007 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2006 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 14 Seiten | MA | ||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed woma (GB) LIMITED\certificate issued on 28/06/07 | 2 Seiten | CERTNM | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 403a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 403a | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 395 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von HIGH PRESSURE PUMPS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUNCAN, William Murray | Sekretär | Rampart Road SP1 1JA Salisbury 113 Wiltshire United Kingdom | British | 67830180002 | ||||||
| KELLY, Joseph Shaun | Geschäftsführer | 9/3 Palmerston Place EH12 5AF Edinburgh | United Kingdom | British | 33918070003 | |||||
| MOON, Kevin Andrew | Geschäftsführer | 28 Lairds Gate Bothwell G71 7HR Glasgow Lanarkshire | United Kingdom | British | 111396200001 | |||||
| SPINKS, Roderick George | Geschäftsführer | 34b Cammo Road EH4 8AP Edinburgh | Scotland | British | 85061380003 | |||||
| BONDLAW SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 39/49 Commercial Road SO15 1GA Southampton Hampshire | 900018010001 | |||||||
| DAVIDSON CHALMERS (SECRETARIAL SERVICES) LIMITED | Sekretär | 12 Hope Street EH2 4DB Edinburgh Midlothian | 137092310001 | |||||||
| CARLING, Simon | Geschäftsführer | Foxleigh Cottage Newtown Road SO51 0GJ Romsey Hampshire | England | British | 88823820001 | |||||
| JONES, Stephen Graham | Geschäftsführer | Spindleberry Woodville Stour Provost SP8 5LY Gillingham Dorset | England | British | 74888270005 | |||||
| SMITH, Mark | Geschäftsführer | Le Stangala Old Salisbury Road Abbotts Ann SP11 7NS Andover Hampshire | British | 94349330001 | ||||||
| BONDLAW DIRECTORS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 39-49 Commercial Road SO15 1GA Southampton Hampshire | 900018000001 |
Hat HIGH PRESSURE PUMPS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 29. Jan. 2007 Geliefert am 02. Feb. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 14. März 2006 Geliefert am 16. März 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 27. Aug. 2004 Geliefert am 02. Sept. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 31/03/03 | Erstellt am 23. Juni 2003 Geliefert am 11. Juli 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deposit agreement to secure own liabilities | Erstellt am 20. Feb. 2002 Geliefert am 06. März 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All such rights to the repayment of the deposit meaning the debt(s) on the account(s) described in the schedule being the account with the bank denominated in sterling designated ltsb re pegasus systems international limited bond liability and numbered 07479102 and any account(s) for the time being replacing the same and all interest owing in respect thereof and all deposits with the banks treasury division on the name of the bank re the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0