THE EXCLUSIVE CORPORATION LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | THE EXCLUSIVE CORPORATION LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04215320 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von THE EXCLUSIVE CORPORATION LIMITED?
- (7020) /
Wo befindet sich THE EXCLUSIVE CORPORATION LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 3rd Floor 5 Wigmore Street W1U 1PB London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von THE EXCLUSIVE CORPORATION LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 24. März 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für THE EXCLUSIVE CORPORATION LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 2 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 11. Mai 2011 | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 24. März 2010 | 6 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 11. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Reit(Corporate Services) Limited am 09. Dez. 2009 | 1 Seiten | CH04 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Trafalgar Officers Limited am 11. Mai 2010 | 1 Seiten | CH02 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Christopher George White am 01. Mai 2010 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Maurice Moses Benady am 01. Mai 2010 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 24. März 2009 | 6 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 24. März 2008 | 12 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||||||
legacy | 4 Seiten | 288a | ||||||||||||||
legacy | 4 Seiten | 288a | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 4 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 24. März 2007 | 13 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von THE EXCLUSIVE CORPORATION LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F&C REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED | Sekretär | 5 Wigmore Street W1U 1PB London |
| 79571870006 | ||||||||||
| BENADY, Maurice Moses | Geschäftsführer | Line Wall Road Gibraltar 57/63 | Gibraltar | British | 69435160001 | |||||||||
| WHITE, Christopher George | Geschäftsführer | Line Wall Road Gibraltar 57/63 | Gibraltar | British | 80132540006 | |||||||||
| TRAFALGAR OFFICERS LIMITED | Geschäftsführer | 5 Wigmore Street W1U 1PB London 3rd Floor |
| 135316290001 | ||||||||||
| JACOBS, Adrian Mark | Sekretär | 13 Beaufort Gardens Hendon NW4 3QN London | British | 59392140001 | ||||||||||
| THE COMPANY REGISTRATION AGENTS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Leonard Street EC2A 4QS London 83 | 900013740001 | |||||||||||
| BENJAMIN, William Stephen | Geschäftsführer | 44 Campden Hill Square Holland Park W8 7JR London | United Kingdom | British | 71600980002 | |||||||||
| PASHLEY, Michael | Geschäftsführer | 31 Saint Michaels Road MK40 2LZ Bedford | British | 77493420001 | ||||||||||
| LUCIENE JAMES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 83 Leonard Street EC2A 4QS London | 900003210001 | |||||||||||
| REIT(CORPORATE DIRECTORS) LIMITED | Geschäftsführer | 5 Wigmore Street W1U 1PB London | 74030120002 |
Hat THE EXCLUSIVE CORPORATION LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Eleventh supplemental trust deed | Erstellt am 16. Okt. 2001 Erworben am 16. Jan. 2005 Geliefert am 18. Jan. 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Part of f/h land on the east side of watersmeeting road bolton greater manchester t/no GM884303 (formerly GM785296) buildings erections fixtures fixed plant and machinery leases. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Eleventh supplemental trust deed | Erstellt am 16. Okt. 2001 Erworben am 16. Dez. 2004 Geliefert am 18. Jan. 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H valley leisure park watersmeeting road bolton greater manchester all buildings erections and fixtures fixed plant and machinery benefit of leases. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Eleventh supplemental trust deed ashpol PLC (1) no problem limited (2) optioncorp limited (3) the company (4) and law debenture trustees limited (the "trustee") (5) (the "eleventh supplemental trust deed") | Erstellt am 16. Okt. 2001 Geliefert am 17. Okt. 2001 | Ausstehend | Gesicherter Betrag The principal of and interest on the £75,000,000 10 > per cent. First mortgage debenture stock 2025 of ashpol PLC and all other moneys intended to be secured by the eleventh supplemental trust deed and the trust deed dated 6.12.85 (the "principal trust deed") and also the deeds of various dates as defined to which the eleventh supplemental trust deed is supplemental | |
Kurze Angaben Part of the freehold property known as land on the east side of watersmeeting road bolton greater manchester title number GM785296 together with all buildings erections and fixtures (including tenants and trade fixtures belonging to the company) and fixed plant and machinery for the time being thereon and all improvements and additions thereto subject to and with the benefit of all existing leases underleases tenancies agreements for lease rights covenants and conditions affecting the same. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0