STADCO HOLDINGS LTD.

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSTADCO HOLDINGS LTD.
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04215953
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von STADCO HOLDINGS LTD.?

    • Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich STADCO HOLDINGS LTD.?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    International House Siskin Parkway East
    Middlemarch Business Park
    CV3 4PE Coventry
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von STADCO HOLDINGS LTD.?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    OFFSHELF 282 LTD14. Mai 200114. Mai 2001

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von STADCO HOLDINGS LTD.?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2017

    Welche sind die letzten Einreichungen für STADCO HOLDINGS LTD.?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    1 SeitenDS01

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 15. Okt. 2019

    • Kapital: GBP 1
    3 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Bestätigungserklärung erstellt am 08. Mai 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Mark John Smith am 18. Apr. 2019

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Christopher Paul Fisher am 18. Apr. 2019

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017

    17 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 08. Mai 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    16 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 08. Mai 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Tachbrook Park 5 Apollo Way Warwick Warwickshire CV34 6RW zum International House Siskin Parkway East Middlemarch Business Park Coventry CV3 4PE am 07. Okt. 2016

    1 SeitenAD01

    Ernennung von Mr Mark John Smith als Sekretär am 05. Sept. 2016

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Michael Hayhurst als Sekretär am 05. Sept. 2016

    1 SeitenTM02

    Jahresrückblick erstellt bis 08. Mai 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital09. Mai 2016

    Kapitalaufstellung am 09. Mai 2016

    • Kapital: GBP 19,155,439
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015

    20 SeitenAA

    Ernennung von Mr Mark John Smith als Direktor am 30. Nov. 2015

    3 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Christopher Paul Fisher als Direktor am 30. Nov. 2015

    3 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Gregory Ian Macleod als Geschäftsführer am 30. Okt. 2015

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von David Gordon Hussey als Geschäftsführer am 30. Nov. 2015

    2 SeitenTM01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Stadco Queensway Hortonwood Telford Shropshire TF1 7LL zum Tachbrook Park 5 Apollo Way Warwick Warwickshire CV34 6RW am 29. Dez. 2015

    2 SeitenAD01

    Erfüllung der Belastung 042159530006 vollständig

    1 SeitenMR04

    Wer sind die Geschäftsführer von STADCO HOLDINGS LTD.?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SMITH, Mark John
    Siskin Parkway East
    Middlemarch Business Park
    CV3 4PE Coventry
    International House
    England
    Sekretär
    Siskin Parkway East
    Middlemarch Business Park
    CV3 4PE Coventry
    International House
    England
    213570940001
    FISHER, Christopher Paul
    Siskin Parkway East
    Middlemarch Business Park
    CV3 4PE Coventry
    International House
    England
    Geschäftsführer
    Siskin Parkway East
    Middlemarch Business Park
    CV3 4PE Coventry
    International House
    England
    United KingdomBritish183747270001
    SMITH, Mark John
    Siskin Parkway East
    Middlemarch Business Park
    CV3 4PE Coventry
    International House
    England
    Geschäftsführer
    Siskin Parkway East
    Middlemarch Business Park
    CV3 4PE Coventry
    International House
    England
    United KingdomBritish124719430001
    HAYHURST, Michael
    5 Apollo Way
    CV34 6RW Warwick
    Tachbrook Park
    Warwickshire
    Sekretär
    5 Apollo Way
    CV34 6RW Warwick
    Tachbrook Park
    Warwickshire
    British15201970002
    KYNASTON, Stephen Lloyd
    Plas Onn Quinta
    Weston Rhyn
    SY10 7LW Oswestry
    Shropshire
    Sekretär
    Plas Onn Quinta
    Weston Rhyn
    SY10 7LW Oswestry
    Shropshire
    British10529040001
    OTHERS INTERESTS LTD
    Churchill House
    47 Regent Road
    ST1 3RQ Stoke On Trent
    Staffordshire
    Sekretär
    Churchill House
    47 Regent Road
    ST1 3RQ Stoke On Trent
    Staffordshire
    103784950001
    COOK, Jonathan Charles
    The Backs
    38 South Parade, Harbury
    CV33 9JE Leamington Spa
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    The Backs
    38 South Parade, Harbury
    CV33 9JE Leamington Spa
    Warwickshire
    British72559760001
    HUSSEY, David Gordon
    5 Apollo Way
    CV34 6RW Warwick
    Tachbrook Park
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    5 Apollo Way
    CV34 6RW Warwick
    Tachbrook Park
    Warwickshire
    EnglandBritish131639570002
    HUSSEY, David Gordon
    Callingwood Lane
    Tatenhill
    DE13 9SH Burton-On-Trent
    Callingwood Hall
    Staffordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Callingwood Lane
    Tatenhill
    DE13 9SH Burton-On-Trent
    Callingwood Hall
    Staffordshire
    United Kingdom
    British131639570001
    KYNASTON, Stephen Lloyd
    Harlescott Lane
    Shrewsbury
    SY1 3AS Shropshire
    Geschäftsführer
    Harlescott Lane
    Shrewsbury
    SY1 3AS Shropshire
    United KingdomBritish10529040001
    MACLEOD, Gregory Ian
    5 Apollo Way
    CV34 6RW Warwick
    Tachbrook Park
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    5 Apollo Way
    CV34 6RW Warwick
    Tachbrook Park
    Warwickshire
    United KingdomAustralian60518160005
    MORGAN, Kelvin Brian
    Manderley Ellesmere Road
    Harmer Hill
    SY4 3EE Shrewsbury
    Shropshire
    Geschäftsführer
    Manderley Ellesmere Road
    Harmer Hill
    SY4 3EE Shrewsbury
    Shropshire
    EnglandBritish74818010001
    MORGAN, Kelvin Brian
    Manderley Ellesmere Road
    Harmer Hill
    SY4 3EE Shrewsbury
    Shropshire
    Geschäftsführer
    Manderley Ellesmere Road
    Harmer Hill
    SY4 3EE Shrewsbury
    Shropshire
    EnglandBritish74818010001
    MORRISS, Andrew Stuart
    Harlescott Lane
    Shrewsbury
    SY1 3AS Shropshire
    Geschäftsführer
    Harlescott Lane
    Shrewsbury
    SY1 3AS Shropshire
    EnglandBritish11643310001
    ROACHE, David John
    Fallowfield
    Badgers Lane
    CV35 0BY Lower Tysoe
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Fallowfield
    Badgers Lane
    CV35 0BY Lower Tysoe
    Warwickshire
    United KingdomBritish40953790002
    STERNE, Dermot Desmond
    Harlescott Lane
    Shrewsbury
    SY1 3AS Shropshire
    Geschäftsführer
    Harlescott Lane
    Shrewsbury
    SY1 3AS Shropshire
    UkBritish96569780001
    SWORD, John David
    Chivel
    OX7 5TR Chipping Norton
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Chivel
    OX7 5TR Chipping Norton
    Oxfordshire
    EnglandBritish1600540001
    WILLIS, David John
    Damson Cottage
    Highfields
    SY4 5UN Wem
    Shropshire
    Geschäftsführer
    Damson Cottage
    Highfields
    SY4 5UN Wem
    Shropshire
    British51085590002
    YOUENS, Michael Arthur
    14 Westwood Drive
    The Mount
    SY3 8YB Shrewsbury
    Shropshire
    Geschäftsführer
    14 Westwood Drive
    The Mount
    SY3 8YB Shrewsbury
    Shropshire
    British36008490001
    OFFSHELF LTD
    Churchill House 47 Regent Road
    ST1 3RQ Stoke On Trent
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Churchill House 47 Regent Road
    ST1 3RQ Stoke On Trent
    Staffordshire
    42228870001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei STADCO HOLDINGS LTD.?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Siskin Parkway East
    Middlemarch Business Park
    CV3 4PE Coventry
    International House
    England
    06. Apr. 2016
    Siskin Parkway East
    Middlemarch Business Park
    CV3 4PE Coventry
    International House
    England
    Nein
    RechtsformPrivate Limited Company
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageCompanies Act
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer555532
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat STADCO HOLDINGS LTD. Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 29. Aug. 2013
    Geliefert am 06. Sept. 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Castle bromwich, fort parkway, fort dunlop, erdington,t/no: WM835446 & WM918474;. Land and buildings on the north side of harlescott lane, shrewsbury, t/no: SL100479; and. Unit a, fford y cain, cain valley trading estate, llanfyllin, t/no: WA725094, CYM389181 and CYM387145. (For details of all other property charged, please refer to the docs). Notification of addition to or amendment of charge.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • The Board of the Pension Protection Fund
    Transaktionen
    • 06. Sept. 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 16. Dez. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 29. Aug. 2013
    Geliefert am 04. Sept. 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Castle bromwich fort parkway fort dunlop erdington t/no.WM835446 and WM918474. Land and buildings on the north side of harlescott lane shrewsbury t/no.SL100479. Unit a, fford y cain cain valley trading estate llanfyllin t/no.WA725094, CYM389181 and CYM387145. Land and buildings to the west side of queensway trench lock interchange hadley telford t/no.SL21563, SL81932 and SL96965. Notification of addition to or amendment of charge.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee
    Transaktionen
    • 04. Sept. 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 16. Dez. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 23. Nov. 2005
    Geliefert am 01. Dez. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC 'Security Trustee'
    Transaktionen
    • 01. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Dez. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of charge
    Erstellt am 28. Feb. 2003
    Geliefert am 06. März 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All securities and their proceeds of sale, all dividends, interests and other distributions, all accretions, rights benefits, money or property accruing.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 06. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Jan. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 28. Feb. 2003
    Geliefert am 06. März 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 06. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Jan. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Pledge of shares
    Erstellt am 23. Juli 2002
    Geliefert am 07. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    926 shares in the share capital of the company numbered from 926 up to and including 1,851. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • J.P. Morgan Europe Limited (Formerly Known as Chase Manhattan International Limited) or Theother Finance Parties
    Transaktionen
    • 07. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Dez. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental deed to the target group debenture
    Erstellt am 23. Juli 2002
    Geliefert am 07. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee or the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • J.P. Morgan Europe Limited (Formerly K/a Chase Manhattan International Limited)
    Transaktionen
    • 07. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Dez. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0