CENTRO PUB CO LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCENTRO PUB CO LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04216482
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CENTRO PUB CO LIMITED?

    • (5540) /

    Wo befindet sich CENTRO PUB CO LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O GRAMNT THORNTON UK LLP
    Earl Grey House 75-85 Grey Street
    NE1 6EF Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CENTRO PUB CO LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CROSSCO (611) LIMITED15. Mai 200115. Mai 2001

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CENTRO PUB CO LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Mai 2006

    Welche sind die letzten Einreichungen für CENTRO PUB CO LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Mitteilung an den Registrar bezüglich des Auflösungsdatums

    2 Seiten2.36B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 10. Nov. 2010

    10 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 10. Nov. 2010

    10 Seiten2.35B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 11. Mai 2010

    8 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 11. Nov. 2009

    8 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 11. Mai 2009

    8 Seiten2.24B

    Ergebnis der Gläubigerversammlung

    11 Seiten2.23B

    Vorschlag des Verwalters

    21 Seiten2.17B

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    4 Seiten395

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Mai 2006

    6 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten395

    legacy

    8 Seiten363s

    legacy

    Seiten363(288)

    legacy

    3 Seiten395

    legacy

    7 Seiten395

    legacy

    7 Seiten395

    legacy

    4 Seiten395

    legacy

    4 Seiten395

    legacy

    4 Seiten395

    legacy

    4 Seiten395

    Wer sind die Geschäftsführer von CENTRO PUB CO LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SAMPLE, Elizabeth
    Abbotswood
    Coldcoats Burn
    NE20 0AE Ponteland
    Tyne & Wear
    Sekretär
    Abbotswood
    Coldcoats Burn
    NE20 0AE Ponteland
    Tyne & Wear
    British27471920002
    NEWTON, Julie
    Orchard House
    South Lodge Wood
    NE61 6LH Hepscott
    Northumberland
    Geschäftsführer
    Orchard House
    South Lodge Wood
    NE61 6LH Hepscott
    Northumberland
    BritishPublican107859600001
    NEWTON, William Alan
    Orchard House South Lodge Wood
    Hepscott
    NE61 6LH Morpeth
    Northumberland
    Geschäftsführer
    Orchard House South Lodge Wood
    Hepscott
    NE61 6LH Morpeth
    Northumberland
    EnglandBritishPublican49019180001
    SAMPLE, Elizabeth
    Abbotswood
    Coldcoats Burn
    NE20 0AE Ponteland
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    Abbotswood
    Coldcoats Burn
    NE20 0AE Ponteland
    Tyne & Wear
    BritishAdministrator27471920002
    SAMPLE, James Ridley
    Abbotswood Coldcoates Burn
    Ponteland
    NE20 0AE Newcastle Upon Tyne
    Geschäftsführer
    Abbotswood Coldcoates Burn
    Ponteland
    NE20 0AE Newcastle Upon Tyne
    BritishCompany Director80272030002
    NEWTON, Julie
    Orchard House
    South Lodge Wood
    NE61 6LH Hepscott
    Northumberland
    Sekretär
    Orchard House
    South Lodge Wood
    NE61 6LH Hepscott
    Northumberland
    British107859600001
    NEWTON, William Alan
    Orchard House South Lodge Wood
    Hepscott
    NE61 6LH Morpeth
    Northumberland
    Sekretär
    Orchard House South Lodge Wood
    Hepscott
    NE61 6LH Morpeth
    Northumberland
    British49019180001
    DICKINSON DEES
    St Anns Wharf
    112 Quayside
    NE99 1SB Newcastle Upon Tyne
    Bevollmächtigter Sekretär
    St Anns Wharf
    112 Quayside
    NE99 1SB Newcastle Upon Tyne
    900005460001
    CARE, Timothy James
    West House Whorlton Hall Farm
    Westerhope
    NE5 1NP Newcastle Upon Tyne
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    West House Whorlton Hall Farm
    Westerhope
    NE5 1NP Newcastle Upon Tyne
    British900005450001
    NEWTON, William Alan
    Orchard House South Lodge Wood
    Hepscott
    NE61 6LH Morpeth
    Northumberland
    Geschäftsführer
    Orchard House South Lodge Wood
    Hepscott
    NE61 6LH Morpeth
    Northumberland
    EnglandBritishCompany Director49019180001

    Hat CENTRO PUB CO LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 23. Jan. 2008
    Geliefert am 13. Feb. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property known as bzar groat house bigg market newcastle upon tyne, by way of assignment the goodwill of the business the benefit of all justices licences and any public entertainment licences fixed charge all proceeds of insurance maintained in respect of the undertaking property and assets of the company all goods and moveable fittings floating charge the whole of the companys undertaking and all its property and assets whatsoever and wheresoever present and future,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Scottish & Newcastle UK Limited
    Transaktionen
    • 13. Feb. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of assignment of life policy
    Erstellt am 25. Juni 2007
    Geliefert am 29. Juni 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Entire right title and interest in and to the policy no 009614055-3 with legal and general assurance society limited and dated 16 july 23002: life assured james ridley sample to the sum of £300,000 (reducing) and any new or substituted policy (or policies) which replace the policy. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 29. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of assignment of life policy
    Erstellt am 25. Mai 2007
    Geliefert am 08. Juni 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Its entire right, title and interest in and to the policy (this being life insurance policy no 009613986-0, held with legal and general assurance society limited and dated 16TH july 2002. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 08. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 28. März 2007
    Geliefert am 07. Apr. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land k/a reform place lying to the north of north road durham t/no: DU246662. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 07. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 28. März 2007
    Geliefert am 07. Apr. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Part of reform place lying to the north of north road durham. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 07. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 28. März 2007
    Geliefert am 31. März 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    F/H land and premises and buildings situate thereon and k/a reform place north road durham city t/no DY246662, the goodwill of the business, the benefit of all justices licences. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Scottish & Newcastle UK Limited
    Transaktionen
    • 31. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 28. März 2007
    Geliefert am 31. März 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Land and premises and buildings situate thereon and k/a land being part of reform place lying to the north of north road durham, the goodwill of the business, the benefit of all justices licences. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Scottish & Newcastle UK Limited
    Transaktionen
    • 31. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 27. März 2007
    Geliefert am 31. März 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    L/H land and premises and buildings situate thereon and k/a jimmy allens, 19-21 elvet bridge, durham city, the goodwill of the business, the benefit of all justices licences. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Scottish & Newcastle UK Limited
    Transaktionen
    • 31. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 27. März 2007
    Geliefert am 31. März 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    L/H land and premises and buildings situate thereon and k/a bar me, 1-6 low row sunderland, the goodwill of the business, the benefit of all justices licences. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Scottish & Newcastle UK Limited
    Transaktionen
    • 31. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 27. März 2007
    Geliefert am 31. März 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    F/H land and premises and buildings situate thereon and k/a shooters bar, 43-45 bridge street morpeth northumberland t/no ND102506, the goodwill of the business, the benefit of all justices licences. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Scottish & Newcastle UK Limited
    Transaktionen
    • 31. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 13. März 2007
    Geliefert am 23. März 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H bar me 1-6 low road sunderland tyne & wear. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 23. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 13. März 2007
    Geliefert am 23. März 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H sammy jacks 76 front street tynemouth north shields t/no ty 360486. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 23. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of novation
    Erstellt am 09. Feb. 2007
    Geliefert am 13. Feb. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    L/H land and premises and buildings k/a sammy jacks 76 front street tynemouth north shields t/no TY360486 the goodwill, the benefit of all justices' licences, the proceeds of insurance, all goods and moveable fittings, floating charge the undertaking and all propert and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Scottish & Newcastle UK Limited
    Transaktionen
    • 13. Feb. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 09. Feb. 2007
    Geliefert am 13. Feb. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The goodwill, the benefit of all justices' licences, the proceeds of insurance, all goods and moveable fittings, floating charge the undertaking and all propert and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Scottish & Newcastle UK Limited
    Transaktionen
    • 13. Feb. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Jan. 2007
    Geliefert am 20. Jan. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The l/h property known as jimmy allen's part 19-20 and 21 elvert bridge durham city,. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 20. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of assignment of life policy
    Erstellt am 16. Jan. 2007
    Geliefert am 03. Feb. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Right tile and interest in and to the policy no:X75559069 with standard life assurance company dated 27 october 2004, life assured being james ridley sample and william alan newton, assured to the sum of £520,000 and all of its rights. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 03. Feb. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 16. Jan. 2007
    Geliefert am 20. Jan. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The f/h land and buildings known as shooters bar t/n ND102506,. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 20. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 16. Jan. 2007
    Geliefert am 20. Jan. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 20. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 23. März 2006
    Erworben am 28. Apr. 2006
    Geliefert am 25. Mai 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    L/H premises k/a as sammy jacks 76 front street tynemouth t/no TY360486.
    Berechtigte Personen
    • Scottish & Newcastle PLC
    Transaktionen
    • 25. Mai 2006Registrierung eines Erwerbs (400)
    Legal charge
    Erstellt am 17. März 2005
    Geliefert am 23. März 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The l/h property and premises and buildings situate thereon and k/a shooters bar, unit G11, the gate, newcastle upon tyne by way of assignment the goodwill of the business the benefit of all justices licences and any public entertainment licences fixed charge all proceeds of insurance maintained in respect of the undertaking property and assets of the company all goods and moveable fittings floating charge the whole of the companys undertaking and all its property and assets whatsoever and wheresoever present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Scottish Courage Limited
    Transaktionen
    • 23. März 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 02. Apr. 2004
    Geliefert am 03. Apr. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Excel-a-Rate Business Services LTD
    Transaktionen
    • 03. Apr. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Dez. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 16. Jan. 2004
    Geliefert am 28. Jan. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    By way of assignment all its rights and title in respect of the goodwill of the business trading from licensed premises to be carried on by the company and the benefit of all licences etc. held by the company in connection with the business. Fixed charge all proceeds due to the company of insurance maintained in respect of the undertaking, property and assets of the company. Fixed charge all goods and movable fittings which do not form part of the company's stock-in-trade and a floating charge the whole of the company's undertaking property and assets present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Scottish Courage Limited
    Transaktionen
    • 28. Jan. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 07. Jan. 2004
    Geliefert am 22. Jan. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 43-45 bridge street morpeth northumberland (now known as shooters) all other l/h and f/h land present and future floating charge all undertaking and all property and assets and rights present and future.
    Berechtigte Personen
    • Crown Dilmun (Swan House) Limited
    Transaktionen
    • 22. Jan. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Dez. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 07. Jan. 2004
    Geliefert am 20. Jan. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The f/h property known as 43-45 bridge street morpeth northumberland t/n ND102506. By way of legal mortgage all estates and interests in any other f/h and l/h property vested at the date of the debenture and by way of fixed charge all estates and interests in any f/h and l/h property in the future. By way of floating charge. Undertaking and all property and assets.
    Berechtigte Personen
    • L S Leisure Limited
    Transaktionen
    • 20. Jan. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Dez. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Jan. 2004
    Geliefert am 10. Jan. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Bar 55 south podium building, 55 degrees north pilgrim street newcastle, all that equipment and stock in trade, all that goodwill of the business.
    Berechtigte Personen
    • Coors Brewers Limited
    Transaktionen
    • 10. Jan. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat CENTRO PUB CO LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    10. Nov. 2010Ende der Verwaltung
    12. Nov. 2008Beginn der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Keith Hinds
    Grant Thornton
    Earl Grey House
    NE1 6EF 75-85 Grey Street
    Newcastle Upon Tyne
    Praktiker
    Grant Thornton
    Earl Grey House
    NE1 6EF 75-85 Grey Street
    Newcastle Upon Tyne
    Joseph Peter Francis Mclean
    Grant Thornton
    Earl Grey House
    NE1 6EF 75-85 Grey Street
    Newcastle Upon Tyne
    Praktiker
    Grant Thornton
    Earl Grey House
    NE1 6EF 75-85 Grey Street
    Newcastle Upon Tyne

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0