SCOTIA SHIPPING LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSCOTIA SHIPPING LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04218389
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von SCOTIA SHIPPING LIMITED?

    • See- und Küstenfrachtverkehr (50200) / Verkehr und Lagerei

    Wo befindet sich SCOTIA SHIPPING LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1 Finsbury Circus
    EC2M 7SH London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von SCOTIA SHIPPING LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    SHERRYBROOK LIMITED17. Mai 200117. Mai 2001

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SCOTIA SHIPPING LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am31. Dez. 2015
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am30. Sept. 2016
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2014

    Welche sind die letzten Einreichungen für SCOTIA SHIPPING LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt.

    1 SeitenSOAS(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 17. Mai 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital21. Juli 2016

    Kapitalaufstellung am 21. Juli 2016

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    3 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 17. Mai 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital05. Juni 2015

    Kapitalaufstellung am 05. Juni 2015

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    3 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 17. Mai 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital05. Juni 2014

    Kapitalaufstellung am 05. Juni 2014

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    13 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 17. Mai 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    3 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 17. Mai 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    3 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 17. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * One St. Paul's Churchyard London EC4M 8SH* am 19. Apr. 2011

    2 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 17. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Juni 2010 bis 31. Dez. 2010

    3 SeitenAA01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2009

    3 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2008

    8 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten287

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von SCOTIA SHIPPING LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    STABLES, Richard James
    William Mackie Crescent
    AB39 2PR Stonehaven
    3
    Kincardineshire
    Sekretär
    William Mackie Crescent
    AB39 2PR Stonehaven
    3
    Kincardineshire
    British134956710001
    BAKKEN, Karl Johan
    6060 Haveid
    Gamle Brandalsvegen
    Norway
    Geschäftsführer
    6060 Haveid
    Gamle Brandalsvegen
    Norway
    NorwayNorwegian135464020001
    JONES, Graham Edward
    15 Golfview Road
    Bieldside
    AB15 9AA Aberdeen
    Aberdeenshire
    Geschäftsführer
    15 Golfview Road
    Bieldside
    AB15 9AA Aberdeen
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish64408420001
    MAXWELL, John Richard
    Mid Street
    Johnshaven
    DD10 0HB Montrose
    16
    Angus
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Mid Street
    Johnshaven
    DD10 0HB Montrose
    16
    Angus
    United Kingdom
    ScotlandBritish75717710002
    CARON DELION, Patrick
    4 Esmond Road
    W4 1JQ London
    Sekretär
    4 Esmond Road
    W4 1JQ London
    Other95892040003
    CARON DELION, Patrick
    First Floor Flat
    39 Nevern Square
    SW5 9PE London
    Sekretär
    First Floor Flat
    39 Nevern Square
    SW5 9PE London
    British95892040001
    LEWIN, Alastair Giles
    19 Severnake Close
    Isle Of Dogs
    E14 9WE London
    Sekretär
    19 Severnake Close
    Isle Of Dogs
    E14 9WE London
    British73905180001
    THORP, Richard Simon
    26 Murray Mews
    Camden
    NW1 9RJ London
    Sekretär
    26 Murray Mews
    Camden
    NW1 9RJ London
    British98514070001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Bevollmächtigter Sekretär
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    CARON DELION, Patrick
    4 Esmond Road
    W4 1JQ London
    Geschäftsführer
    4 Esmond Road
    W4 1JQ London
    EnglandOther95892040003
    GRIFFIN, Philip Mark
    51 Olola Avenue
    2030 Vaucluse
    Nsw
    Australia
    Geschäftsführer
    51 Olola Avenue
    2030 Vaucluse
    Nsw
    Australia
    Australian49828980005
    HARRIS, Braden
    Flat D
    41 Lancaster Grove
    NW3 4HB London
    Geschäftsführer
    Flat D
    41 Lancaster Grove
    NW3 4HB London
    United KingdomBritish72069860002
    JOBANPUTRA, Sandip
    7 High Holborn
    Flat 110
    WC1V 6DR London
    Geschäftsführer
    7 High Holborn
    Flat 110
    WC1V 6DR London
    UkBritish83069380001
    KAYSER, Simon Philip
    Apartment 91
    Cinnabar Wharf East, 28 Wapping High Street
    E1W 1NG London
    Geschäftsführer
    Apartment 91
    Cinnabar Wharf East, 28 Wapping High Street
    E1W 1NG London
    EnglandBritish99475270002
    LAYTON, Matthew Robert
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    British900019870001
    RICHARDS, Martin Edgar
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    British900002870001
    SWANNELL, David William
    55 Albion Gate
    Hyde Park Place
    W2 2LG London
    Geschäftsführer
    55 Albion Gate
    Hyde Park Place
    W2 2LG London
    British72665990003

    Hat SCOTIA SHIPPING LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    First priority isle of man ship mortgage
    Erstellt am 12. Okt. 2007
    Geliefert am 23. Okt. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee up to the maximum amount of gbp 84,000,000 under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    64/64 shares in the vessel and in her boats and appurtenances. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dnb Nor Bank Asa
    Transaktionen
    • 23. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of assignment of insurances
    Erstellt am 12. Okt. 2007
    Geliefert am 23. Okt. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    First priority all amounts due from any underwriters under any insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dnb Nor Bank Asa
    Transaktionen
    • 23. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of covenants
    Erstellt am 12. Okt. 2007
    Geliefert am 23. Okt. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrower and/or the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All of the owner's interest prsent and future in the vessel. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dnb Nor Bank Asa
    Transaktionen
    • 23. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Third priority isle of man statutory mortgage
    Erstellt am 16. Juli 2001
    Geliefert am 03. Aug. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee in the manner set forth in the participation agreement and the deed
    Kurze Angaben
    The M.v "far scotia" regitered in the isle of man register with official number 734266.
    Berechtigte Personen
    • Farstad Shipping Asa
    Transaktionen
    • 03. Aug. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Third priority deed of assignment of insurance
    Erstellt am 16. Juli 2001
    Geliefert am 03. Aug. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to a secondary put and call agreement dated 29 june 2001
    Kurze Angaben
    All insurances in respect of the vessel k/a hull number 78 to be named "far scotia" to be regitered under isle of man flag.
    Berechtigte Personen
    • Farstad Shipping Asa
    Transaktionen
    • 03. Aug. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    A mortgage dated 16/07/01 made by the mortgagor in favour of th chargee in its capacity as security trustee for and on behalf of itself and the primary l/c providers
    Erstellt am 16. Juli 2001
    Geliefert am 31. Juli 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All sums for the time being owing to the chargee in th manner and at the times set forth in the counter-indemnity, the counter-indemnity (swaps), the appa, the deed of assignment, the transaction documents and other transaction documents
    Kurze Angaben
    The 64/64TH shares of which the mortgagor is the owner of the vessel and in the vessels boats ans appurtenances the vessel being platform supply vessel to be known during construction by the seller as hull number 78 and to be registered in the isle of man ships register at the port of douglas. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Den Norske Bank Asa
    Transaktionen
    • 31. Juli 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage
    Erstellt am 16. Juli 2001
    Geliefert am 25. Juli 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to (a) a put option agreement dated 29 june 2001 (b) an application of proceeds and participation agreement dated 29 june 2001 (c) a deed of assignment and covenant dated 29 june 2001 and (d) the transaction documents (all as defined)
    Kurze Angaben
    64/64TH shares in the british registered ship M.V.2FAR scotia" with official no 734266.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Maritime Leasing (No.4) Limited
    Transaktionen
    • 25. Juli 2001Registrierung einer Belastung (395)
    A deed of general assignment and covenant (the "assignment") made by the chargor, allco finance limited (the "general partner") allco finance (UK) limited (the "sponsor") lloyds tsb maritime leasing (no 4) limited (the "investor") in favour of den norske bank asa in its capacity as security trustee for and on behalf of itself and the primary l/c providers (security trustee
    Erstellt am 29. Juni 2001
    Geliefert am 13. Juli 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    Any and all monies liabilities and obligations which are as of the date of the debenture or which may at any time and from time to time thereafter be due owing payable or incurred or expressed to be due owing payable or incurred from or by any of the security parties to the security trustee and the primary l/c providers or any of them under any of the transaction documents and/or any of the other transaction documents and/or any other document entered into from time to time by any security party with one or more of the security trustee and/or the primary l/c providers (all terms as defined)
    Kurze Angaben
    All of the right title and interest present and future actual or contingent of that assignor in to and under the insurances including all payments to that assignor in respect thereof and all claims rights and remedies of that assignor arising therefrom (including all damages and compensation payable for or inrespect thereof) any requisition compensation all sums of money which may now or in the future be standing in the name of that assignor to the credit of an account including without limitation all amounts now or hereafter credited to an account and all proceeds of the foregoing including all cash at any time and from time to time receivable or distributable in respect of or in exchange for any of the foregoing and interest thereon the charterparty and the farstad guarantee of charter all of its right title and interest in and to the vessel known during construction by the seller as hull number 78 for details of the property charged please refer to the form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Den Norske Bank Asa as Security Trustee
    Transaktionen
    • 13. Juli 2001Registrierung einer Belastung (395)
    A debenture made by the company in favour of den norske bank asa in its capacity as security trustee for and on behalf of itself and the primary l/c providers (the "security trustee")
    Erstellt am 29. Juni 2001
    Geliefert am 13. Juli 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    Any and all monies liabilities and obligations which are as of the date of the debenture or which may at any time and from time to time thereafter be due owing payable or incurred or expressed to be due owing payable or incurred from or by any of the security parties to the security trustee and the primary l/c providers or any of them under any of the transaction documents and/or any of the other transaction documents and/or any other document entered into from time to time by any security party with one or more of the security trustee and/or the primary l/c providers (all terms as defined)
    Kurze Angaben
    Each and every part of the undertaking being the whole of the companys undertaking property and assets whatsoever and wheresoever both present and future including any uncalled capital and the proceeds of any future calls. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Den Norske Bank Asa as Security Trustee
    Transaktionen
    • 13. Juli 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of general assignment and covenant
    Erstellt am 29. Juni 2001
    Geliefert am 12. Juli 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All moneys obligations and liabilities from time to time due owing or payable from or by any of the company,allco finance limited ("general partner") ,allco finance (UK) limited ("sponsor"), farstad shipping asa ("guarantor"), farstad shipping limited (the "bareboat charterer") den norske asa and svenska handelsbanken ab (publ) (the "letter of credit providers") to the chargee under or pursuant to the transaction documents as defined in the application of proceeds and participation agreement relating to the scotia shipping limited partnership (the "appa") dated 29TH june 2001 between the owner, the sponsor, the company, the assignee, the guarantor and the letter of credit providers which include but are not limited to a).,the appa b).a partnership agreement dated 29TH june 2001 between the company, the sponsor and the assignee
    Kurze Angaben
    All the company's right title and interest in and to a). The benefit of all insurances over the vessel with hull NO78 at brattvaag skipsverft as (tbn M.V."far scotia") b). Any compensation payable in respect of the compulsory acquisition or requisition for title or hire of such vessel c). The sterling current account (and any account replacing or amending thereof) of the owner with den norske asa, london branch with account number 62377001 and all monies accruing therefrom d). The sterling partnership account (and any account replacing or amending thereof) in the name of the scotia shipping limited partnership with den norske bank asa london branch with account no;-62392001 and all moneys accruing therefrom .
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Maritime Leasing (NO4) Limited ("Assignee")
    Transaktionen
    • 12. Juli 2001Registrierung einer Belastung (395)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0