LA TASCA GROUP LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | LA TASCA GROUP LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04220541 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von LA TASCA GROUP LIMITED?
- Tätigkeit anderer Holdinggesellschaften n.n.a. (64209) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Wo befindet sich LA TASCA GROUP LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Lower Ground Floor, Elsley House 24/30 Great Titchfield Street W1W 8BF London England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von LA TASCA GROUP LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| THE RESTAURANT PEOPLE GROUP LIMITED | 27. Juli 2001 | 27. Juli 2001 |
| DMWSL 339 LIMITED | 21. Mai 2001 | 21. Mai 2001 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LA TASCA GROUP LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 26. Mai 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für LA TASCA GROUP LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||
Beendigung der Bestellung von James Forrester Spragg als Geschäftsführer am 31. März 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 1st Floor, 163 Eversholt Street London NW1 1BU England zum Lower Ground Floor, Elsley House 24/30 Great Titchfield Street London W1W 8BF am 10. März 2021 | 1 Seiten | AD01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Mai 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 26. Mai 2019 | 2 Seiten | AA | ||
Eintragung der Belastung 042205410015, erstellt am 14. Jan. 2020 | 24 Seiten | MR01 | ||
Ernennung von Mr Adrian Walker als Direktor am 06. Dez. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Giles Matthew Oliver David als Sekretär am 06. Dez. 2019 | 1 Seiten | TM02 | ||
Beendigung der Bestellung von Giles Matthew Oliver David als Geschäftsführer am 06. Dez. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Mai 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Ernennung von Mr James Forrester Spragg als Direktor am 30. Apr. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Stephen Richards als Geschäftsführer am 30. Apr. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 27. Mai 2018 | 2 Seiten | AA | ||
Eintragung der Belastung 042205410014, erstellt am 15. Aug. 2018 | 25 Seiten | MR01 | ||
Eintragung der Belastung 042205410013, erstellt am 15. Aug. 2018 | 25 Seiten | MR01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Mai 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 28. Mai 2017 | 2 Seiten | AA | ||
Notification of La Tasca Holdings Limited as a person with significant control on 21. Mai 2017 | 2 Seiten | PSC02 | ||
Withdrawal of a person with significant control statement on 06. März 2018 | 2 Seiten | PSC09 | ||
Beendigung der Bestellung von Timothy John Doubleday als Geschäftsführer am 21. Juni 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Giles Matthew Oliver David als Sekretär am 21. Juni 2017 | 2 Seiten | AP03 | ||
Beendigung der Bestellung von Timothy John Doubleday als Sekretär am 21. Juni 2017 | 1 Seiten | TM02 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von LA TASCA GROUP LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WALKER, Adrian Rowland | Geschäftsführer | 163 Eversholt Street NW1 1BU London 1st Floor United Kingdom | England | British | 265227060001 | |||||||||
| DAVID, Giles Matthew Oliver | Sekretär | Eversholt Street NW1 1BU London 1st Floor, 163 England | 237559790001 | |||||||||||
| DOUBLEDAY, Timothy John | Sekretär | 163 Eversholt Street NW1 1BU London 1st Floor United Kingdom | 201021490001 | |||||||||||
| EVANS, Martin John | Sekretär | 6 Bellcast Close Appleton WA4 5SA Warrington Cheshire | British | 52869850002 | ||||||||||
| POWELL, Matthew David | Sekretär | 33 Tagg Wood View Ramsbottom BL0 9XP Bury Lancashire | British | 125692100001 | ||||||||||
| DM COMPANY SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 16 Charlotte Square EH2 4DF Edinburgh Midlothian | 900000320001 | |||||||||||
| MAZARS COMPANY SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Bridge House, St Katharine's Way E1W 1DD London Tower United Kingdom |
| 130398850001 | ||||||||||
| ABBEY, Adrian Mark | Geschäftsführer | The Stables Mill Lane Broom B50 4HS Alcester Warwickshire | United Kingdom | British | 78951280002 | |||||||||
| ARMOUR, Malcolm Craig | Geschäftsführer | 104 Trinity Road EH5 3JZ Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 70810590001 | |||||||||
| BAKER, Suzanne Louise | Geschäftsführer | 500 Capability Green LU1 3LS Luton Porter Tun House Bedfordshire | England | British | 35409580006 | |||||||||
| BARNES, Michael John | Geschäftsführer | 28 Old Lane Bramhope LS16 9AZ Leeds West Yorkshire | England | British | 11951630001 | |||||||||
| BROWN, Aaron Maxwell | Geschäftsführer | Elsworthy Terrace NW3 3DR London 5 | United Kingdom | British | 98928830002 | |||||||||
| DAVID, Giles Matthew Oliver | Geschäftsführer | Eversholt Street NW1 1BU London 1st Floor, 163 England | England | British | 187907210001 | |||||||||
| DOUBLEDAY, Timothy John | Geschäftsführer | 163 Eversholt Street NW1 1BU London 1st Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 91011320001 | |||||||||
| EDWARD, Ian | Geschäftsführer | 17 Baronsmead Road SW13 9RR London | England | British | 90337160001 | |||||||||
| EVANS, Martin John | Geschäftsführer | 6 Bellcast Close Appleton WA4 5SA Warrington Cheshire | United Kingdom | British | 52869850002 | |||||||||
| GRUNNELL, Mark | Geschäftsführer | Montolieu Gardens SW15 6PB London 3 | United Kingdom | British | 94144450002 | |||||||||
| HAVENHAND, Jonathan | Geschäftsführer | 20 Canterbury Avenue Fulwood S10 3RT Sheffield Yorkshire | British | 80812860002 | ||||||||||
| HORLER, James Michael Alexander | Geschäftsführer | West End Farm Main Street WR11 7UE Sedgeberrow Worcestershire | British | 65293140002 | ||||||||||
| KEEN, Christian | Geschäftsführer | 500 Capability Green LU1 3LS Luton Porter Tun House Bedfordshire | United Kingdom | British | 117424240001 | |||||||||
| MCLAUGHLIN, Mary Catherine | Geschäftsführer | The Cobbles Donkey Lane SK9 1PX Wilmslow Cheshire | United Kingdom | Irish | 58320700002 | |||||||||
| MYERS, David Paul | Geschäftsführer | Glyme Court Oxford Office Village Off Langford Lane OX5 1LQ Kidlington County House Oxford United Kingdom | England | British | 142171370001 | |||||||||
| POWELL, Matthew David | Geschäftsführer | 33 Tagg Wood View Ramsbottom BL0 9XP Bury Lancashire | England | British | 125692100001 | |||||||||
| RICHARDS, Stephen | Geschäftsführer | 163 Eversholt Street NW1 1BU London 1st Floor United Kingdom | England | British | 187618040002 | |||||||||
| RICHARDSON, Richard William | Geschäftsführer | 16 Pecketts Way HG1 3EW Harrogate North Yorkshire | British | 31914560002 | ||||||||||
| SMALLEY, Timothy John | Geschäftsführer | Chivers Road CM15 0LG Stondon Massey Stondon Place Essex | United Kingdom | British | 102593650002 | |||||||||
| SPRAGG, James Forrester | Geschäftsführer | 163 Eversholt Street NW1 1BU London 1st Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 127602840002 | |||||||||
| SYMONDS, Paul | Geschäftsführer | Willow House 10a Vicars Close, Biddenham MK40 4BG Bedford Bedfordshire | England | British | 80167420001 | |||||||||
| WETTON, Gavin | Geschäftsführer | Kingfisher Way Cottenham CB24 8XN Cambridge 30 Cambridgeshire | England | British | 141080490001 | |||||||||
| WILKINSON, Simon | Geschäftsführer | 500 Capability Green LU1 3LS Luton Porter Tun House Bedfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 158424890001 | |||||||||
| 25 NOMINEES LIMITED | Geschäftsführer | Royal London House 22-25 Finsbury Square EC2A 1DX London | 42409900001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei LA TASCA GROUP LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Tasca Holdings Limited | 21. Mai 2017 | 163 Eversholt Street NW1 1BU London 1st Floor United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für LA TASCA GROUP LIMITED?
| Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
|---|---|---|
| 21. Mai 2017 | 21. Mai 2017 | Das Unternehmen hat die erforderlichen Schritte zur Ermittlung, ob eine Person eine registrierungspflichtige Person oder eine registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen ist, noch nicht abgeschlossen. |
Hat LA TASCA GROUP LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 14. Jan. 2020 Geliefert am 16. Jan. 2020 | Ausstehend | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 15. Aug. 2018 Geliefert am 23. Aug. 2018 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung None at the date of the charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 15. Aug. 2018 Geliefert am 23. Aug. 2018 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung All current and future interests in property and intellectual property owned by the company, in each case as defined in the supplemental debenture registered by this form MR01. For more details please refer to the supplemental debenture. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 05. Feb. 2016 Geliefert am 12. Feb. 2016 | Ausstehend | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 25. Sept. 2015 Geliefert am 05. Okt. 2015 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 25. Sept. 2015 Geliefert am 02. Okt. 2015 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 24. Feb. 2011 Geliefert am 28. Feb. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and each obligor and bay restaurant holdings limited and la tasca, inc to the security trustee or to any of the other secured parties or any other finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 27. März 2008 Geliefert am 03. Apr. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the parent and each obligor of la tasca, inc to the chargee or to any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment of keyman life policy | Erstellt am 07. Nov. 2002 Geliefert am 22. Nov. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The policy, all sums assured by it and all bonuses and benefits which may arise under it (including sundry conditions, provisions and declarations); and the assignor's whole right title and interest present and future in the policy. The policy of life assurance on the life of michael john barnes with scottish equitable PLC (policy number LO0191147322) dated 30 september 2002. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment of keyman life policy | Erstellt am 23. Aug. 2002 Geliefert am 11. Sept. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The policy of life assurance on the life of james michael alexander horler with scottish equitable PLC (policy number LO199333112) dated 16TH november 2001 all sums assured by it and all bonuses and benefits accruing therefrom. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment of keyman life policy | Erstellt am 23. Aug. 2002 Geliefert am 11. Sept. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The policy of life assurance on the life of jonathan havenhand with norwich union linked life assurance (policy number 7748495EG) dated 18TH june 2002 all sums assured by it and all bonuses and benefits accruing therefrom. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment of keyman life policy | Erstellt am 23. Aug. 2002 Geliefert am 11. Sept. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The policy of life assurance on the life of mary catherine mclaughlin with norwich union linked life assurance limited (policy number 7784177EL) dated 15TH april 2002 all sums assured by it and all bo. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment of keyman life policy | Erstellt am 23. Aug. 2002 Geliefert am 11. Sept. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The policy of life assurance on the life of martin john evans with norwich union linked life assurance limited (policy number 7784384EU) dated 5TH april 2002 and all bonuses and benefits accruing ther. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment of life policy | Erstellt am 13. Feb. 2002 Geliefert am 16. Feb. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The policy of life insurance on the life of michael john barnes with scottish equitable (policy number L0196780902), all sums assured by it and all bonuses and benefits wich may arise under it.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 10. Sept. 2001 Geliefert am 13. Sept. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties and to the holders of the secured consideration loan notes under the secured consideration loan notes (as defined therein) on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0