NHPC LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameNHPC LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04221903
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von NHPC LIMITED?

    • (5530) /
    • (5540) /

    Wo befindet sich NHPC LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    K P M G Corporate Recovery
    Arlington Business Park
    RG7 4SD Theale
    Reading
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von NHPC LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    NOBLE HOUSE PUB COMPANY LIMITED 21. Juni 200121. Juni 2001
    NH GORDON NO.4 LIMITED12. Juni 200112. Juni 2001
    TRUSHELFCO (NO.2806) LIMITED23. Mai 200123. Mai 2001

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NHPC LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis

    Welche sind die letzten Einreichungen für NHPC LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 26. Jan. 2016

    2 Seiten3.6

    Mitteilung über die Beendigung der Tätigkeit als Receiver oder Manager

    4 SeitenRM02

    Mitteilung über die Beendigung der Tätigkeit als Receiver oder Manager

    4 SeitenRM02

    Bericht des Verwaltungsverwalters

    19 Seiten3.10

    Insolvenzmeldung

    Insolvency:progress report
    2 SeitenLIQ MISC

    Ernennung eines Receivers oder Managers

    RM01

    Ernennung eines Receivers oder Managers

    4 SeitenRM01

    Ernennung eines Receivers oder Managers

    4 SeitenRM01

    Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss

    4 SeitenAC92

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 30. Nov. 2010

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 19. Okt. 2010

    4 Seiten3.6

    legacy

    2 SeitenLQ02

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 19. Okt. 2009

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 19. Okt. 2008

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 19. Okt. 2008

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    3 Seiten3.6

    Verschiedenes

    Statement of affairs
    8 SeitenMISC

    Bericht des Verwaltungsverwalters

    11 Seiten3.10

    legacy

    1 Seiten287

    Wer sind die Geschäftsführer von NHPC LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CLARKE, Stephen Paul
    125 South Park Road
    Wimbledon
    SW19 8RX London
    Sekretär
    125 South Park Road
    Wimbledon
    SW19 8RX London
    British83058420001
    BREARE, Robert Roddick Ackrill
    Archers
    Church Lane
    GU35 8PL Headley
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Archers
    Church Lane
    GU35 8PL Headley
    Hampshire
    British38255700005
    JOHNSON, Ian Paul
    Tugwood
    Kings Lane
    SL6 9TZ Cookham Dean
    Berkshire
    Sekretär
    Tugwood
    Kings Lane
    SL6 9TZ Cookham Dean
    Berkshire
    British76187110001
    TRUSEC LIMITED
    35 Basinghall Street
    EC2V 5DB London
    Bevollmächtigter Sekretär
    35 Basinghall Street
    EC2V 5DB London
    900007200001
    CAHILL, John Patrick
    1 Wentworth Cottages
    Thorndown Lane
    GU20 6DJ Windlesham
    Surrey
    Geschäftsführer
    1 Wentworth Cottages
    Thorndown Lane
    GU20 6DJ Windlesham
    Surrey
    British63753920001
    JOHNSON, Ian Paul
    Tugwood
    Kings Lane
    SL6 9TZ Cookham Dean
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Tugwood
    Kings Lane
    SL6 9TZ Cookham Dean
    Berkshire
    United KingdomBritish76187110001
    ROWE, Drusilla Charlotte Jane
    Flat E
    13 Saint Georges Drive
    SW1V 4DJ London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Flat E
    13 Saint Georges Drive
    SW1V 4DJ London
    British900010990001
    RYDE, Andrew Gareth
    Dell Lodge Pinewood Close
    Oxhey Drive South
    HA6 3ET Northwood
    Middlesex
    Geschäftsführer
    Dell Lodge Pinewood Close
    Oxhey Drive South
    HA6 3ET Northwood
    Middlesex
    British47612540002
    SARKAR, Tihir
    Flat 3 Gibson House
    Gibson Square
    N1 0RA London
    Geschäftsführer
    Flat 3 Gibson House
    Gibson Square
    N1 0RA London
    British76258910001
    UPTON, Christopher George
    Little Heath
    Kent Hatch Road, Limpsfield Chart
    RH8 0SZ Oxted
    Surrey
    Geschäftsführer
    Little Heath
    Kent Hatch Road, Limpsfield Chart
    RH8 0SZ Oxted
    Surrey
    EnglandBritish103753080001
    ZUERCHER, Eleanor Jane
    14 St Mary's Court
    Tingewick
    MK18 4RE Buckingham
    Bucks
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    14 St Mary's Court
    Tingewick
    MK18 4RE Buckingham
    Bucks
    British900019290001

    Hat NHPC LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Rent deposit deed
    Erstellt am 10. Dez. 2003
    Geliefert am 13. Dez. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £29,250.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The deposit account held at lloyds tsb bank PLC as created by a rent deposit deed dated 10 december 2003.
    Berechtigte Personen
    • G P Davis, M J Davis and G S Lee
    Transaktionen
    • 13. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge supplemental to a debenture
    Erstellt am 29. Jan. 2003
    Geliefert am 01. Feb. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The additional property - the l/h property k/a the vine formerly k/a the ship and turtle 122 leadenhall street london EC3V 4PT and all its present and future plant and machinery and insurances and all related rights.,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 01. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge supplemental to a debenture
    Erstellt am 13. Jan. 2003
    Geliefert am 16. Jan. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All that l/h property k/a de alto grenfell island grenfell island maidenhead. L/h property k/a de alto york york & county press building york. L/h property k/a huxters manchester minshull street manchester t/no GM5678. (For further property charged refer to form 395). fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland(The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 16. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of deposit supplemental to a lease dated 20 december 2002
    Erstellt am 20. Dez. 2002
    Geliefert am 04. Jan. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The balance outstanding from time to time and all interest standing to the credit of an interest bearing account. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Moorfield (Newcastle) Nominees I Limited & Morfield (Newcastle) Nominee Ii Limited
    Transaktionen
    • 04. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge supplemental to a debenture dated 28 march 2002
    Erstellt am 07. Nov. 2002
    Geliefert am 13. Nov. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due by any chargor to any senior creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The additional property being allthat f/h property k/a bar oz st james street nottingham t/n NT98847,all that unregistered l/h property k/a cock & dragonchalk lane barnet cockfosters EN4 9HU and all that unregistered l/h property k/a de alto bluewater the village greenhithe DA9 9SE for further details of property charged please refer to form 395 fixed charge all its present and future plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 13. Nov. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge supplemental to a debenture dated 28/03/02
    Erstellt am 30. Okt. 2002
    Geliefert am 06. Nov. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each and/or any chargor/s named therein to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a the green man fownhope herefordshire t/n HE15551 and HE10311, all of the additional property not effectively charged by clause 2(a) all plant and machinery not effectively charged 2(a) or 2(b) relating to the addditional property insurances and all related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandthe Security Trustee for and on Behalf of the Secured Creditors
    Transaktionen
    • 06. Nov. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 30. Okt. 2002
    Geliefert am 06. Nov. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    £26,503.14 with all other money and accrued interest.
    Berechtigte Personen
    • Punch Pub Company (Vpr) Limited
    Transaktionen
    • 06. Nov. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge supplemental to a debenture dated 28 march 2002
    Erstellt am 10. Okt. 2002
    Geliefert am 16. Okt. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The additional property k/a all that l/h property unit 13 star city watson road nechells birmingham west midlands t/n WM743768, units 16/22/23 star city watson road nechells birmingham, unit 17 star city watson road nechells birmingham (for further details of the property charged please refer to the form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee
    Transaktionen
    • 16. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of rental deposit
    Erstellt am 16. Sept. 2002
    Geliefert am 25. Sept. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed charge all the company's interest in the interest earning deposit account to be opened by the landlord, in the name of the landlord and in which the landlord shall place the initial deposit of £129,420.00 plus vat (the deposit account) and in the amount at any time standing to the credit of the deposit account.
    Berechtigte Personen
    • Leisure Ii (Birmingham) Limited and Leisure Ii (Birmingham Two) Limited
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of rental deposit
    Erstellt am 16. Sept. 2002
    Geliefert am 25. Sept. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed charge all the company's interest in the interest earning deposit account to be opened by the landlord, in the name of the landlord and in which the landlord shall place the initial deposit of £105,000.00 plus vat (the deposit account) and in the amount at any time standing to the credit of the deposit account.
    Berechtigte Personen
    • Leisure Ii (Birmingham) Limited and Leisure Ii (Birmingham Two) Limited
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of rental deposit
    Erstellt am 16. Sept. 2002
    Geliefert am 25. Sept. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed charge all the company's interest in the interest earning deposit account to be opened by the landlord, in the name of the landlord and in which the landlord shall place the initial deposit of £160,000.00 plus vat (the deposit account) and in the amount at any time standing to the credit of the deposit account.
    Berechtigte Personen
    • Leisure Ii (Birmingham) Limited and Leisure Ii (Birmingham Two) Limited
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge supplemental to a debenture dated 28 march 2002
    Erstellt am 03. Sept. 2002
    Geliefert am 06. Sept. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any chargor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The additional property including (I) the leasehold property known as cranbrook,182 cranbrook road,ilford IG1 4LX; ngl 103302; (ii) l/hold property known as de alto,liverpool,unit 6 queen arcade,queen square,liverpool L1 1RH; (iii) l/hold property known as henry's birmingham,1 victoria square,birmingham B1 1BD; wm 465779; all fixed plant machinery,insurances and all related rights thereon; first floating charge over all undertaking and assets; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 06. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge supplemental to a debenture dated 28 march 2002
    Erstellt am 02. Aug. 2002
    Geliefert am 10. Aug. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All moneys,debts and liabilities due or to become due from the company to any senior creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    (I) l/hold property known as manhattan sq,97 ormskirk rd,liverpool L9 5AE; MS335397; (ii) l/hold known as r & p,birmingham,200 broad st,birmingham B15 1SU; WM679603; (iii) l/hold property known as square,milton keynes,163-175 grafton gate east,milton keynes MK9 1AE; BM227484; all plant machinery,related rights,insurances,claims,returns and premiums thereon; floating charge over all undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 10. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 08. Juli 2002
    Geliefert am 10. Juli 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £9,562 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    An account for the purpose of the deposit under the terms of a lease dated 12/06/69 (as defined therein).
    Berechtigte Personen
    • The Bampton Property Group Limited
    Transaktionen
    • 10. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge supplemental to a debenture dated 28TH march 2002 and
    Erstellt am 26. Juni 2002
    Geliefert am 03. Juli 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first legal mortgage the additional property known as:- the leasehold property known as the george & gragon, eldon square, newcastle NE1 7JN t/no: TY60120 and the leasehold property known as vigos, 11 vigo street, london W1X 1AJ t/no: NGL799903, together with fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 03. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge supplemental to a debenture dated 28TH march 2002 and
    Erstellt am 26. Juni 2002
    Geliefert am 03. Juli 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first legal mortgage the additional property known as:- the freehold property known as the avenue, park avenue, whitley bay NE26 3PH, the leasehold and freehold property known as the crown hotel, crown passage, worcester WR1 3LL t/nos: HW36968 and HW58750, the leasehold property known as the square, wellington road south, stockport SK1 3TA t/no: GM533939, the leasehold property known as todds wine bar, crown passage, worcester WR1 3LL t/no: HW58749, together with fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 03. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 17TH june 2002
    Erstellt am 17. Juni 2002
    Geliefert am 25. Juni 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The hideaway lodge and restaurant halbeath dunfermline t/no: FFE25470.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 25. Juni 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 23. Mai 2002
    Geliefert am 30. Mai 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Cash deposit of £12,075 or such other sum equal to 3 months rent.
    Berechtigte Personen
    • British Waterways Board
    Transaktionen
    • 30. Mai 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of deposit
    Erstellt am 23. Mai 2002
    Geliefert am 29. Mai 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £17,331.25 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The rent deposit balance as defined in the deed being the initial rent deposit of £17,331.25 together with any accrued interest.
    Berechtigte Personen
    • Csc Properties Limited
    Transaktionen
    • 29. Mai 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 29 april 2002 and
    Erstellt am 28. März 2002
    Geliefert am 10. Mai 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    (1) the balgarth, 8 dunure road, ayr t/no. AYR41716 (2) the lanark loch, 179 hyndford road, lanark t/nos. LAN31875 and LAN135020 (3) the mossend hotel, largs road, lochwinnoch, paisley t/no. REN13797 and REN21887. For details of further properties charged please refer to form 395.. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 10. Mai 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 28. März 2002
    Geliefert am 11. Apr. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All present and future moneys debts and liabilities due owing or incurred by any chargor to any senior creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H property k/a head office chapel house alma road windsor, f/h property k/a albert hotel 63 london street southport t/no MS435151, f/h property k/a anchor & horseshoes 194 london road guildford t/no SY368094 (for full details of all property charged see form 395) together with. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 11. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Dez. 2002Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 23. Okt. 2004Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
    • 102. Dez. 2010Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (LQ02)
    • 214. März 2015Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (RM01)
    • 214. März 2015Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (RM01)
    • 227. Jan. 2016Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (RM02)
    • 227. Jan. 2016Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (RM02)
      • Aktenzeichen 1
      • Aktenzeichen 2
    Rent deposit deed
    Erstellt am 04. Feb. 2002
    Geliefert am 12. Feb. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    An interest bearing designated account with an initial deposit of £52,875.00 held with all interest thereon and any further sums paid by the tenant to the landlord. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Associated British Ports
    Transaktionen
    • 12. Feb. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 30. Jan. 2002
    Geliefert am 08. Feb. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    £26,500.
    Berechtigte Personen
    • Punch Pub Company (Vpr) Limited
    Transaktionen
    • 08. Feb. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    A standard security which was registered in scotland on the 27 december 2001 and
    Erstellt am 19. Dez. 2001
    Geliefert am 12. Jan. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The property k/a the balgarth dunure road doonfoot, the lanark loch 179 hyndford road lanark, the mossend hotel largs road lochwinnoch paisley (for further details of the property charged please refer to the form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC(As Security Trustee for the Benefit of the Senior Creditors
    Transaktionen
    • 12. Jan. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Dez. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 19. Dez. 2001
    Geliefert am 24. Dez. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future moneys debts and liabilities due owing or incurred by any chargor to any senior creditor (as defined) under or in connection with any energise finance document (as defined) (whether alone or jointly or severally with any other person whether actually or contingently and whether as principal surety or otherwise)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 24. Dez. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Apr. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat NHPC LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    28. März 2002Instrumentendatum
    Administrativer Receiver bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Jane Bronwen Moriarty
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Blair Carnegie Nimmo
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    2Administrativer Receiver bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Jane Bronwen Moriarty
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Receiver Manager
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Robert Andrew Croxen
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Receiver Manager
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0