CHALICE HOLDINGS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCHALICE HOLDINGS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04227852
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CHALICE HOLDINGS LIMITED?

    • (7487) /

    Wo befindet sich CHALICE HOLDINGS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Numerica
    66 Wigmore Street
    W1U 2HQ London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CHALICE HOLDINGS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2004

    Welche sind die letzten Einreichungen für CHALICE HOLDINGS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    3 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 02. Sept. 2012

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 02. März 2012

    5 Seiten4.68

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator

    1 Seiten4.40

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 02. Sept. 2011

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 02. März 2011

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 02. Sept. 2010

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 02. März 2010

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 02. Sept. 2009

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 02. März 2009

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 02. Sept. 2008

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 02. Sept. 2008

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren

    5 Seiten4.68

    Vermögensübersicht

    6 Seiten4.20

    legacy

    1 Seiten287

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren

    LRESEX

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    3 Seiten395

    legacy

    3 Seiten395

    Wer sind die Geschäftsführer von CHALICE HOLDINGS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BORDELL, Jonathan David
    53 Greenwood Gardens
    Shenley
    WD7 9LF Radlett
    Hertfordshire
    Sekretär
    53 Greenwood Gardens
    Shenley
    WD7 9LF Radlett
    Hertfordshire
    British31982200003
    BORDELL, Danielle Ruth
    53 Greenwood Gardens
    WD7 9LF Radlett
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    53 Greenwood Gardens
    WD7 9LF Radlett
    Hertfordshire
    EnglandBritish89385270001
    BORDELL, Jonathan David
    53 Greenwood Gardens
    Shenley
    WD7 9LF Radlett
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    53 Greenwood Gardens
    Shenley
    WD7 9LF Radlett
    Hertfordshire
    EnglandBritish31982200003
    L.C.I. SECRETARIES LIMITED
    74 Lynn Road
    Terrington Saint Clement
    PE34 4JX Kings Lynn
    Norfolk
    Bevollmächtigter Sekretär
    74 Lynn Road
    Terrington Saint Clement
    PE34 4JX Kings Lynn
    Norfolk
    900015390001
    BRIGGS, Andrew
    Tanners Farm
    Tanners Lane
    RG4 9AB Chalkhouse Green
    Oxon
    Geschäftsführer
    Tanners Farm
    Tanners Lane
    RG4 9AB Chalkhouse Green
    Oxon
    EnglandBritish98852730001
    LLOYD-LANGTON, Marion Anne
    39 Greys Road
    RG9 1SB Henley On Thames
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    39 Greys Road
    RG9 1SB Henley On Thames
    Oxfordshire
    British76678180004
    L.C.I. DIRECTORS LIMITED
    60 Tabernacle Street
    EC2A 4NB London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    60 Tabernacle Street
    EC2A 4NB London
    900013970001

    Hat CHALICE HOLDINGS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 13. Sept. 2004
    Geliefert am 01. Okt. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    2A merry hill mount bushey hertfordshire.
    Berechtigte Personen
    • Andrew Briggs
    Transaktionen
    • 01. Okt. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 13. Sept. 2004
    Geliefert am 01. Okt. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    2A merry hill mount bushey. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Okt. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Dez. 2003
    Geliefert am 24. Dez. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    17 cowper road, hanwell, london. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 24. Nov. 2003
    Geliefert am 10. Dez. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    53 riverview grove chiswick london W4 3QL. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Apr. 2003
    Geliefert am 25. Apr. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    856 harrow road london NW10. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 27. März 2003
    Geliefert am 03. Apr. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 10. Mai 2002
    Geliefert am 15. Mai 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage the property k/a 65A grosvenor road, hanwell, ealing, london W7. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Mai 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 18. März 2002
    Geliefert am 21. März 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    124 worple road, isleworth, middlesex, TW7 7HU.. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. März 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 04. März 2002
    Geliefert am 21. März 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    21 somerset road, brentford, middlesex.. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. März 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 15. Aug. 2001
    Geliefert am 24. Aug. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All property loans which are due during or incurred to the chargee and any interest due thereon at a rate of 1 per cent over the base rate from time to time of national westminster bank PLC per annum and on a full indemnity basis all costs and expenses incurred by the chargee in relation to the monies and liabilities thereby covenanted to be paid and any guarantees and security given therefor
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Andrew Gordon Judd Briggs
    Transaktionen
    • 24. Aug. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 15. Aug. 2001
    Geliefert am 23. Aug. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All property loans due or to become due from the company to the chargee (all terms as defined)
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage all freehold and leasehold property now vested in the company.by way of fixed charge all freehold or leasehold property now or in the future beneficially owned by not vested in the company,all freehold and leasehold property hereafter acquired by the company,all shares and rights to the acquisition of shares stocks and other securities,all uncalled capital,goodwill and all patents,patent applications ,trade marks,trade names,registered designs,copyrights,licences and similar rights for the time being of the company.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Jonathan David Bordell
    Transaktionen
    • 23. Aug. 2001Registrierung einer Belastung (395)

    Hat CHALICE HOLDINGS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    03. März 2005Beginn der Liquidation
    16. Apr. 2013Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Colin Ian Vickers
    Vantis Business Recovery
    4th Floor Southfield House 11
    BN11 1RY Liverpool Gardens
    Worthing
    Praktiker
    Vantis Business Recovery
    4th Floor Southfield House 11
    BN11 1RY Liverpool Gardens
    Worthing
    Nicholas H O'Reilly
    Levy Gee
    66 Wigmore Street
    W1A 3RT London
    Praktiker
    Levy Gee
    66 Wigmore Street
    W1A 3RT London
    Christopher David Stevens
    Frp Advisory Llp 4th Floor Southfield House
    11 Liverpool Garders
    BN11 1RY Worthing
    West Sussex
    Praktiker
    Frp Advisory Llp 4th Floor Southfield House
    11 Liverpool Garders
    BN11 1RY Worthing
    West Sussex

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0