PEERLESS CONSTRUCTION (BIRKDALE) LIMITED

PEERLESS CONSTRUCTION (BIRKDALE) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnamePEERLESS CONSTRUCTION (BIRKDALE) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04236568
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von PEERLESS CONSTRUCTION (BIRKDALE) LIMITED?

    • (7011) /

    Wo befindet sich PEERLESS CONSTRUCTION (BIRKDALE) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Anglian House
    Ambury Road
    PE29 3NZ Huntingdon
    Cambridgeshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von PEERLESS CONSTRUCTION (BIRKDALE) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CROSSCO (625) LIMITED18. Juni 200118. Juni 2001

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PEERLESS CONSTRUCTION (BIRKDALE) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für PEERLESS CONSTRUCTION (BIRKDALE) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Beendigung der Bestellung von Malcolm Joseph Sanders als Geschäftsführer am 06. Juni 2012

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Ralph Lyons als Geschäftsführer am 06. Juni 2012

    1 SeitenTM01

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    3 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 18. Juni 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    8 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital18. Juli 2011

    Kapitalaufstellung am 18. Juli 2011

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    3 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 18. Juni 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    12 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von David Logue als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Nigel Edmund Pacey als Direktor

    2 SeitenAP01

    Änderung der Details des Direktors für David Iain Logue am 03. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    12 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    12 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten403a

    legacy

    2 Seiten403a

    legacy

    5 Seiten395

    Wer sind die Geschäftsführer von PEERLESS CONSTRUCTION (BIRKDALE) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SHEPHEARD, Geoffrey Arthur George
    Red Tiles
    62 Park Road
    GU22 7DB Woking
    Surrey
    Sekretär
    Red Tiles
    62 Park Road
    GU22 7DB Woking
    Surrey
    British143104990001
    DONNELLY, Anthony
    1 Old Kirk Road
    Corstorphine
    EH12 6JY Edinburgh
    Geschäftsführer
    1 Old Kirk Road
    Corstorphine
    EH12 6JY Edinburgh
    United KingdomBritishDevelopment Director109258700001
    PACEY, Nigel Edmund
    Edinburgh Road
    ML12 6AX Biggar
    Springdale
    Lanarkshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Edinburgh Road
    ML12 6AX Biggar
    Springdale
    Lanarkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector135610270001
    FOX, Jacqueline Elizabeth
    Little Dormers
    3 Wicken Road
    CB11 3QD Newport
    Essex
    Sekretär
    Little Dormers
    3 Wicken Road
    CB11 3QD Newport
    Essex
    British35460890004
    GILLEN, Seamus Joseph
    20 Mountway
    EN6 1EP Potters Bar
    Hertfordshire
    Sekretär
    20 Mountway
    EN6 1EP Potters Bar
    Hertfordshire
    British66174560001
    TURNER, David Charles
    13 Thorndales
    St Johns Avenue
    CM14 5DE Brentwood
    Essex
    Sekretär
    13 Thorndales
    St Johns Avenue
    CM14 5DE Brentwood
    Essex
    Other84007940001
    DICKINSON DEES
    St Anns Wharf
    112 Quayside
    NE99 1SB Newcastle Upon Tyne
    Bevollmächtigter Sekretär
    St Anns Wharf
    112 Quayside
    NE99 1SB Newcastle Upon Tyne
    900005460001
    BLYTH, Alastair Forbes
    79 Gardiner Road
    Blackhall
    EH4 5SR Edinburgh
    Scotland
    Geschäftsführer
    79 Gardiner Road
    Blackhall
    EH4 5SR Edinburgh
    Scotland
    EnglandBritishCompany Director67075350002
    CARE, Timothy James
    West House Whorlton Hall Farm
    Westerhope
    NE5 1NP Newcastle Upon Tyne
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    West House Whorlton Hall Farm
    Westerhope
    NE5 1NP Newcastle Upon Tyne
    British900005450001
    LEITH, Brian James
    10 Douglas Avenue
    Lenzie
    G66 4NW Glasgow
    Geschäftsführer
    10 Douglas Avenue
    Lenzie
    G66 4NW Glasgow
    BritishDirector61660001
    LOGUE, David Iain
    6 Colebrook Street
    Kelvinbridge
    G12 8HD Glasgow
    2/1
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    6 Colebrook Street
    Kelvinbridge
    G12 8HD Glasgow
    2/1
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector91223970002
    LYONS, Ralph
    22 Cavendish Avenue
    S17 3NJ Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    22 Cavendish Avenue
    S17 3NJ Sheffield
    South Yorkshire
    BritishCompany Director54929910001
    POPLE, David George
    16 St Crispin's Road
    Newtonhill
    AB39 3PS Stonehaven
    Aberdeenshire
    Geschäftsführer
    16 St Crispin's Road
    Newtonhill
    AB39 3PS Stonehaven
    Aberdeenshire
    BritishC0mpany Director53727020005
    SANDERS, Malcolm Joseph
    45 Woodholm Road
    S11 9HS Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    45 Woodholm Road
    S11 9HS Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritishEngineer70712660001

    Hat PEERLESS CONSTRUCTION (BIRKDALE) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 29. Okt. 2008
    Geliefert am 03. Nov. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H and l/h property k/a 10, 12, 14 and 16 waterloo road, birkdale, southport, merseyside t/no MS263568 and MS456631 by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 03. Nov. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Mai 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 29. Okt. 2008
    Geliefert am 31. Okt. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 31. Okt. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Mai 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 18. Feb. 2002
    Geliefert am 07. März 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that f/h land and buildings k/a 12 waterloo road birkdale t/n MS263568, all l/h property k/a 10 waterloo road birkdale t/n MS28473, 14 waterloo road birkdale and 16 waterloo road birkdale. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 07. März 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Nov. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Feb. 2002
    Geliefert am 07. März 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h land and buildings k/a 12 waterloo road birkdale t/n MS263568. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 07. März 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Nov. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Feb. 2002
    Geliefert am 22. Feb. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The l/h property k/a 10 waterloo road birkdale southport in the county of merseyside with good leasehold t/n MS28473, all that f/h property k/a 12 waterloo road birkdale southport in the county of merseyside with absolute title y/n MS263508, all that l/h property k/a 14 waterloo road birkdale southport in the county of merseyside and all that l/h property k/a 16 waterloo road birkdale southport in the county of merseyside together with all buildings and all fixtures and fittings plant and equipment and the proceeds of the sale. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Morrison Residential Investments Limited
    Transaktionen
    • 22. Feb. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Mai 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 23. Aug. 2001
    Geliefert am 05. Sept. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under an interim loan agreement of even date
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Morrison Homes Limited
    Transaktionen
    • 05. Sept. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Mai 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0