INGLEBY SUB LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | INGLEBY SUB LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04240184 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von INGLEBY SUB LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich INGLEBY SUB LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Highfield Court Tollgate Chandler's Ford SO53 3TY Eastleigh England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von INGLEBY SUB LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ROAD ANGEL GROUP LIMITED | 28. Sept. 2006 | 28. Sept. 2006 |
| BLACK SPOT INTERACTIVE LIMITED | 13. Sept. 2001 | 13. Sept. 2001 |
| EGGSHELL (467) LIMITED | 25. Juni 2001 | 25. Juni 2001 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von INGLEBY SUB LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für INGLEBY SUB LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 25. Juni 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 21 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 25. Juni 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 21 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Pritchard Williams als Geschäftsführer am 28. Juni 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 25. Juni 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Stefan Leon Borson als Direktor am 07. Nov. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Edward Ian Charles Walker als Sekretär am 07. Nov. 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 24 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 25. Juni 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 2nd Floor, Home Ground Barn Pury Hill Business Park Towcester NN12 7LS England zum Highfield Court Tollgate Chandler's Ford Eastleigh SO53 3TY am 13. Feb. 2018 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 26 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 25. Juni 2017 mit Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Notification of Ingleby (1653) Limited as a person with significant control on 04. Juni 2016 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Clark House Silverstone Technology Park Silverstone Circuit Silverstone Northamptonshire NN12 8GX zum 2nd Floor, Home Ground Barn Pury Hill Business Park Towcester NN12 7LS am 09. Jan. 2017 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt | 1 Seiten | DISS40 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 25 Seiten | AA | ||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt | 1 Seiten | DISS16(SOAS) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. Juni 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Edward Ian Charles Walker als Sekretär am 31. Mai 2016 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von INGLEBY SUB LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BORSON, Stefan Leon | Geschäftsführer | Tollgate Chandler's Ford SO53 3TY Eastleigh Highfield Court England | England | British | 117811010002 | |||||
| EAGLE, Anthony Joseph | Sekretär | 6 Adelaide Crescent BN3 2JE Hove East Sussex | British | 75329780001 | ||||||
| ESSACK, Ismail | Sekretär | Silverstone Technology Park Silverstone NN12 8GX Circuit Silverstone Clark House Northamptonshire | 180702250001 | |||||||
| THICKBROOM, Mark Gordon | Sekretär | Silverstone Technology Park Silverstone NN12 8GX Circuit Silverstone Clark House Northamptonshire | 150676770001 | |||||||
| WALKER, Edward Ian Charles | Sekretär | Barnes Wallis Road PO15 5UA Fareham 1 Hampshire England | 208796400001 | |||||||
| WATERLOW SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003950001 | |||||||
| BOWDEN ROOKE, Stuart Lee | Geschäftsführer | 14 Mansell Close NN12 7AY Towcester Northamptonshire | British | 142390750001 | ||||||
| CHAPMAN, Stuart Malcolm | Geschäftsführer | Buckingham Gate SW1E 6LB London 14 United Kingdom | United Kingdom | British | 98452660001 | |||||
| CLARK, David William | Geschäftsführer | Gilbury Farm Gilbury Lane SO45 1AG Exbury Hampshire | England | British | 91168600003 | |||||
| EAGLE, Anthony Joseph | Geschäftsführer | 6 Adelaide Crescent BN3 2JE Hove East Sussex | United Kingdom | British | 75329780001 | |||||
| ESSACK, Ismail | Geschäftsführer | Silverstone Technology Park Silverstone NN12 8GX Circuit Silverstone Clark House Northamptonshire | England | British | 67640350001 | |||||
| KEANE, Adrian Spencer | Geschäftsführer | Dale Acre Barn Main Street DE74 2RH Lockington Derby | United Kingdom | British | 62552110002 | |||||
| MACKIE, Graham Robert | Geschäftsführer | 4 The Paddocks MK43 8LT Bedford Bedfordshire | England | British | 123305710001 | |||||
| MEECHAN, Richard John | Geschäftsführer | Silverstone Technology Park Silverstone NN12 8GX Circuit Silverstone Clark House Northamptonshire | England | British | 167193130001 | |||||
| READ, Jonathan Hugh Tobias | Geschäftsführer | Silverstone Technology Park Silverstone NN12 8GX Circuit Silverstone Clark House Northamptonshire | United Kingdom | British | 154632910001 | |||||
| SADIQ, Hassan Saadi | Geschäftsführer | Silverstone Technology Park Silverstone NN12 8GX Circuit Silverstone Clark House Northamptonshire | United Kingdom | British | 118639040001 | |||||
| SALMON, Steven Kenneth | Geschäftsführer | Valley Farm Hanbury Road B60 4HJ Hanbury Worcestershire | England | British | 142390760001 | |||||
| THICKBROOM, Mark | Geschäftsführer | Technology Park, Silverstone Circuit Silverstone NN12 8GX Towcester Clark House Northamptonshire England | United Kingdom | British | 116064810002 | |||||
| WILLIAMS, Mark Pritchard | Geschäftsführer | Tollgate Chandler's Ford SO53 3TY Eastleigh Highfield Court England | England | British | 198092340001 | |||||
| WATERLOW NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003940001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei INGLEBY SUB LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingleby (1653) Limited | 04. Juni 2016 | Home Ground Barn Pury Hill Business Park NN12 7LS Towcester 2nd Floor England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat INGLEBY SUB LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 23. Juni 2015 Geliefert am 23. Juni 2015 | Ausstehend | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 26. März 2012 Geliefert am 31. März 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the group members (or any of them) on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 19 september 2005 and | Erstellt am 10. Juli 2010 Geliefert am 21. Juli 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deposit deed | Erstellt am 23. Sept. 2005 Geliefert am 30. Sept. 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben £85,187.50 and any interest thereon for the time being standing to the credit of the seperate designated interest bearing deposit account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage of a life policy | Erstellt am 19. Sept. 2005 Geliefert am 01. Okt. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All money including bonuses that have accrued or may become payable under the policy, the benefit of all options and rights given in connection with the policy and all rights and interests in the policy. The policy means the life assurance policy on the life of mr david clark dated 26TH january 2004 with the financial services limited policy number 010644900-2 in the sum of £500,000 for a period of 5 years. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 19. Sept. 2005 Geliefert am 01. Okt. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 19. Sept. 2005 Geliefert am 01. Okt. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Intellectual property rights charge | Erstellt am 19. Sept. 2005 Geliefert am 01. Okt. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All rights in rights and patents know-how registered trade marks registered designs utility models applications for the rights to apply for any of the foregoing unregistered design rights unregistered trade marks the rights to prevent passing off for unfair competition and copyright database rights topography rights and any other rights. The goodwill relating to any of the intellectual property. Every item of physical material of any description in respect of which the intellectual property rights may subsist. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 31. Okt. 2002 Geliefert am 05. Nov. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £3,675.00 due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben A designated interest earning account at a clearing bank or recognised building society. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0