EVERMARSH LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameEVERMARSH LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04247255
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von EVERMARSH LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich EVERMARSH LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    13 Police Street
    M2 7LQ Manchester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EVERMARSH LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2015

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für EVERMARSH LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für EVERMARSH LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2015

    3 SeitenAA

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    2 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 06. Juli 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital06. Juli 2015

    Kapitalaufstellung am 06. Juli 2015

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2014

    3 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 06. Juli 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital07. Juli 2014

    Kapitalaufstellung am 07. Juli 2014

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 6 Brookfield House Holcombe Brook Bury Lancashire BL0 9RN* am 07. Mai 2014

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2013

    3 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 06. Juli 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2012

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 06. Juli 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2011

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 06. Juli 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2010

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 06. Juli 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2009

    4 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten287

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2008

    5 SeitenAA

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2007

    6 SeitenAA

    legacy

    6 Seiten363s

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2006

    6 SeitenAA

    legacy

    8 Seiten363s
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    annual-return10. Nov. 2006

    legacy

    363(288)

    Wer sind die Geschäftsführer von EVERMARSH LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SPEAKMAN, David William Henry
    9 Maldon Road
    Standish
    WN6 0EX Wigan
    Lancashire
    Sekretär
    9 Maldon Road
    Standish
    WN6 0EX Wigan
    Lancashire
    British34006940001
    HARRISON, Paul Darren
    Hall Street
    Walshaw
    BL8 3BE Bury
    21-23
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Hall Street
    Walshaw
    BL8 3BE Bury
    21-23
    Lancashire
    EnglandBritish96445910001
    HARRISON, Mark Andrew
    2 Brookfield House
    Holcombe Brook
    BL0 9RN Bury
    Lancashire
    Sekretär
    2 Brookfield House
    Holcombe Brook
    BL0 9RN Bury
    Lancashire
    British62155720002
    HARRISON, Paul Darren
    Hall Street
    Walshaw
    BL8 3BE Bury
    21-23
    Lancashire
    Sekretär
    Hall Street
    Walshaw
    BL8 3BE Bury
    21-23
    Lancashire
    British96445910001
    BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED
    The Britannia Suite
    Lauren Court
    M33 2AF Wharf Road
    Sale
    Greater Manchester
    Bevollmächtigter Sekretär
    The Britannia Suite
    Lauren Court
    M33 2AF Wharf Road
    Sale
    Greater Manchester
    900018560001
    HARRISON, Geoffrey Keith
    4 Woodhouse
    LA7 7LY Heversham
    Cumbria
    Geschäftsführer
    4 Woodhouse
    LA7 7LY Heversham
    Cumbria
    British77581470002
    HARRISON, Mark Andrew
    2 Brookfield House
    Holcombe Brook
    BL0 9RN Bury
    Lancashire
    Geschäftsführer
    2 Brookfield House
    Holcombe Brook
    BL0 9RN Bury
    Lancashire
    British62155720002
    DEANSGATE COMPANY FORMATIONS LIMITED
    The Britannia Suite
    Lauren Court
    M33 2AF Wharf Road
    Sale
    Greater Manchester
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    The Britannia Suite
    Lauren Court
    M33 2AF Wharf Road
    Sale
    Greater Manchester
    900018550001

    Hat EVERMARSH LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 13. Jan. 2006
    Geliefert am 28. Jan. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Apartment 902 1 deansgate manchester t/n GM904024,. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 28. Jan. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Apr. 2004
    Geliefert am 07. Apr. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold property known as 2 springpool winstanley wigan. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 07. Apr. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Jan. 2004
    Geliefert am 12. Feb. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property t/n MS314241 and known by the short description of 249 liverpool road southport in the sefton district of the county of merseyside. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 12. Feb. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 14. Feb. 2003
    Geliefert am 15. Feb. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The leasehold property known as 55 and 55A darlington street east wigan t/n GM470156. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 15. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Mai 2002
    Geliefert am 01. Juni 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage apartment 901, 1 deansgate, manchester M3 1AZ. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 01. Juni 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Sept. 2001
    Geliefert am 19. Sept. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    406 holcombe road greenmount bury t/n GM562956. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 19. Sept. 2001Registrierung einer Belastung (395)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0