DIGITAL INTERACTIVE TELEVISION GROUP LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | DIGITAL INTERACTIVE TELEVISION GROUP LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04249015 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von DIGITAL INTERACTIVE TELEVISION GROUP LIMITED?
- Entwicklung von vorgefertigter interaktiver Freizeit- und Unterhaltungssoftware (62011) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich DIGITAL INTERACTIVE TELEVISION GROUP LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 3rd Floor Chancery House St Nicholas Way SM1 1JB Sutton Surrey United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DIGITAL INTERACTIVE TELEVISION GROUP LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für DIGITAL INTERACTIVE TELEVISION GROUP LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 68 Lombard Street London EC3V 9LJ England zum 3rd Floor Chancery House St Nicholas Way Sutton Surrey SM1 1JB am 30. Sept. 2020 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Juli 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Jose Luis Vazquez am 28. Mai 2020 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2019 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Juli 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2018 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Juli 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2017 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Juli 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2016 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Juli 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Jose Luis Vazquez am 02. Dez. 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 68 Lombard Street London EC3V 9LJ England zum 68 Lombard Street London EC3V 9LJ am 03. Nov. 2015 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 69 Old Street London EC1V 9HX zum 68 Lombard Street London EC3V 9LJ am 03. Nov. 2015 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2015 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. Juli 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse No.1 London Bridge London SE1 9BG verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse No.1 London Bridge London SE1 9BG verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse No.1 London Bridge London SE1 9BG verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse No.1 London Bridge London SE1 9BG verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse No.1 London Bridge London SE1 9BG verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde auf No.1 London Bridge London SE1 9BG geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von DIGITAL INTERACTIVE TELEVISION GROUP LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FILEX SERVICES LIMITED | Sekretär | SE1 9BG London No.1 London Bridge England |
| 3620420001 | ||||||||||
| VAZQUEZ ANTOLINEZ, Jose Luis | Geschäftsführer | Lombard Street EC3V 9LJ London 68 England | Spain | Spanish | 129097630012 | |||||||||
| APPS, Jonathan Michael Charles | Sekretär | 8 Paines Close HA5 3BN Pinner Middlesex | British,Australian | 71105860002 | ||||||||||
| DUNCAN, Graham Andrew | Sekretär | Old Street EC1V 9HX London 69 England | British | 131749410002 | ||||||||||
| GORDON, Georgia Louise | Sekretär | Flat 8 77-78 Warwick Square SW1V 2AR London | British | 83555480001 | ||||||||||
| HOPKINS, Gareth James | Sekretär | 37 Northbrook Street LS7 4QQ Leeds | British | 76710740002 | ||||||||||
| JAMES, Richard Mark | Sekretär | Nether End House Barnsley Road HD8 8YG Denby Dale West Yorkshire | British | 77966860001 | ||||||||||
| JAMES, Richard Mark | Sekretär | Nether End House Barnsley Road HD8 8YG Denby Dale West Yorkshire | British | 77966860001 | ||||||||||
| WYCHERLEY, Charlotte Ann | Sekretär | 149 Jennyfield Drive HG3 2XQ Harrogate North Yorkshire | British | 78144370001 | ||||||||||
| WYCHERLEY, Charlotte Ann | Sekretär | 149 Jennyfield Drive HG3 2XQ Harrogate North Yorkshire | British | 78144370001 | ||||||||||
| APPS, Jonathan Michael Charles | Geschäftsführer | 8 Paines Close HA5 3BN Pinner Middlesex | United Kingdom | British,Australian | 71105860002 | |||||||||
| DOCHERTY, David, Dr | Geschäftsführer | Sergehill House Sergehill Bedmond WD5 0RY Abbots Langley Herts | United Kingdom | British | 124089180002 | |||||||||
| FEARON, Andrew Jason | Geschäftsführer | Brooms Langley Lower Green CB11 4SB Saffron Walden Essex | United Kingdom | British | 69281370002 | |||||||||
| HANCOCK, Simon Gregory John | Geschäftsführer | 24 The Grove WD7 7NF Radlett Hertfordshire | England | British | 104345230001 | |||||||||
| HUGHES, Mark Vaughan | Geschäftsführer | Longlands Knockholt Road, Halstead TN14 7ER Sevenoaks Kent | Northern Ireland | British | 142863710001 | |||||||||
| JAMES, Richard Mark | Geschäftsführer | Nether End House Barnsley Road HD8 8YG Denby Dale West Yorkshire | United Kingdom | British | 77966860001 | |||||||||
| MACDONALD, Neil Stirling | Geschäftsführer | 36 Elstree Road Bushey Heath WD23 4GL Bushey Hertfordshire | United Kingdom | British | 76876650001 | |||||||||
| SWINGEWOOD, John Paul | Geschäftsführer | Rogers Farm Lunces Common RH16 4QU Haywards Heath West Sussex | United Kingdom | British | 141447260001 | |||||||||
| WILKINSON, Peter Robert | Geschäftsführer | Sycamore Cottage Barrowby Lane Kirkby Overblow HG3 1HD Harrogate North Yorkshire | United Kingdom | British | 4373790001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei DIGITAL INTERACTIVE TELEVISION GROUP LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirada Plc | 06. Apr. 2016 | Lombard Street EC3V 9LJ London 68 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat DIGITAL INTERACTIVE TELEVISION GROUP LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee & debenture | Erstellt am 17. Aug. 2007 Geliefert am 30. Aug. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 12. Mai 2005 Geliefert am 19. Mai 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 26. Juli 2004 Geliefert am 29. Juli 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the noteholder (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture deed | Erstellt am 08. Aug. 2002 Geliefert am 14. Aug. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 14. Nov. 2001 Geliefert am 21. Nov. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0