BANDAIR LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBANDAIR LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04252416
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BANDAIR LIMITED?

    • Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich BANDAIR LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BANDAIR LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für BANDAIR LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 04. Nov. 2013

    19 Seiten2.35B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 19. Mai 2013

    19 Seiten2.24B

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    1 SeitenF2.18

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    6 Seiten2.16B

    Vorschlag des Verwalters

    26 Seiten2.17B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O King Loose St John's Parade 5 South Parade Summertown Oxford OX2 7JL am 30. Nov. 2012

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    legacy

    6 SeitenLQ01

    Jahresrückblick erstellt bis 31. März 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital26. Apr. 2012

    Kapitalaufstellung am 26. Apr. 2012

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2011

    8 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Noel Martin Smyth am 04. Nov. 2011

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2010

    7 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. März 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Ernennung von Alannah Smyth als Sekretär

    2 SeitenAP03

    Ernennung von Bryan Lawlor als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Bryan Lawlor als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von John Mckenna als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 31. März 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2009

    8 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288c

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2008

    9 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    4 Seiten363a

    Wer sind die Geschäftsführer von BANDAIR LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SMYTH, Alannah
    Portobello Road
    Dublin 8
    29
    Ireland
    Sekretär
    Portobello Road
    Dublin 8
    29
    Ireland
    154691750001
    KINNAIRD, Nigel John
    14 Magheraconluce Lane
    BT26 6PT Hillsborough
    County Down
    Geschäftsführer
    14 Magheraconluce Lane
    BT26 6PT Hillsborough
    County Down
    Northern IrelandBritish83042830001
    LAWLOR, Bryan
    Coolamber Court
    Knocklyon Road
    Dublin 16
    17
    Ireland
    Geschäftsführer
    Coolamber Court
    Knocklyon Road
    Dublin 16
    17
    Ireland
    IrelandIrish154652750001
    SMYTH, Noel Martin
    25 Tooting Bec Road
    SW17 8BY London
    Flat 7
    England
    Geschäftsführer
    25 Tooting Bec Road
    SW17 8BY London
    Flat 7
    England
    IrelandIrish91238420002
    BOULTBEE BROOKS, Clive Ensor
    Welcheston Farm
    Broadmoor Common Woolhope
    HR1 4QU Hereford
    Herefordshire
    Sekretär
    Welcheston Farm
    Broadmoor Common Woolhope
    HR1 4QU Hereford
    Herefordshire
    British82993640001
    LAWLOR, Bryan William
    Coolamber Court
    Knocklyon Road
    21
    Dublin 16
    Republic Of Ireland
    Sekretär
    Coolamber Court
    Knocklyon Road
    21
    Dublin 16
    Republic Of Ireland
    Irish102461750012
    MORAN, John
    9 Fitzwilliam Square
    IRISH Dublin
    2
    Ireland
    Sekretär
    9 Fitzwilliam Square
    IRISH Dublin
    2
    Ireland
    Irish81598910002
    GLS FINANCIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4TT London
    Sekretär
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4TT London
    64660490001
    JPCORS LIMITED
    Suite 17 City Business Centre
    Lower Road
    SE16 2XB London
    Bevollmächtigter Sekretär
    Suite 17 City Business Centre
    Lower Road
    SE16 2XB London
    900001430001
    BOULTBEE BROOKS, Charmaine Joan
    Welcheston Farm Broadmoor Common
    Woolhope
    HR1 4QU Hereford
    Herefordshire
    Geschäftsführer
    Welcheston Farm Broadmoor Common
    Woolhope
    HR1 4QU Hereford
    Herefordshire
    United KingdomBritish81478130001
    BOULTBEE BROOKS, Clive Ensor
    Welcheston Farm
    Broadmoor Common Woolhope
    HR1 4QU Hereford
    Herefordshire
    Geschäftsführer
    Welcheston Farm
    Broadmoor Common Woolhope
    HR1 4QU Hereford
    Herefordshire
    United KingdomBritish82993640001
    BOULTBEE BROOKS, Steven John
    Babushka Cadogan Pier
    Chelsea Embankment
    SW3 5RQ London
    Geschäftsführer
    Babushka Cadogan Pier
    Chelsea Embankment
    SW3 5RQ London
    EnglandBritish67458340001
    CONLON, Michael
    384 City Road
    EC1 2QA London
    Geschäftsführer
    384 City Road
    EC1 2QA London
    United KingdomBritish109352660001
    FALKNER, Justine
    18 Shevon Way
    CM14 4PJ Brentwood
    Essex
    Geschäftsführer
    18 Shevon Way
    CM14 4PJ Brentwood
    Essex
    British40502490001
    JEFFEREY, Nigel John
    6 Squires Court
    80 Arthur Road Wimbledon
    SW19 7DJ London
    Geschäftsführer
    6 Squires Court
    80 Arthur Road Wimbledon
    SW19 7DJ London
    British80582360001
    JEFFERY, Nigel John
    6 Squires Court
    80 Arthur Road Wimbledon
    SW19 7DJ London
    Geschäftsführer
    6 Squires Court
    80 Arthur Road Wimbledon
    SW19 7DJ London
    United KingdomBritish65718910001
    LAWLOR, Bryan William
    Rodini
    Waterford Road
    County Kilkenny
    Republic Of Ireland
    Geschäftsführer
    Rodini
    Waterford Road
    County Kilkenny
    Republic Of Ireland
    Irish102461750001
    MCKENNA, John
    34 Brighton Square Rathgar
    IRISH Dublin 6
    Republic Of Ireland
    Geschäftsführer
    34 Brighton Square Rathgar
    IRISH Dublin 6
    Republic Of Ireland
    IrelandIrish116525480001
    MORAN, John
    9 Fitzwilliam Square
    IRISH Dublin
    2
    Ireland
    Geschäftsführer
    9 Fitzwilliam Square
    IRISH Dublin
    2
    Ireland
    Irish81598910002
    JPCORD LIMITED
    Suite 17 City Business Centre
    Lower Road
    SE16 2XB London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Suite 17 City Business Centre
    Lower Road
    SE16 2XB London
    900001420001

    Hat BANDAIR LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 28. Sept. 2007
    Geliefert am 06. Okt. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and each borrower to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property known as 40 & 41 furnival street london t/n NGL6176306, fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled share capital buildings and fixtures,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nm Rothschild & Sons Limited
    Transaktionen
    • 06. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Subordination agreement
    Erstellt am 22. Feb. 2007
    Geliefert am 08. März 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Under the subordination agreement, if: any obligor makes any payment in cash or in kind on account of, or for the purchase or other acquisition of, all or any part of the junior liabilities; or the company receives all or any amount in cash or in kind of the junior liabilities. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • N M Rothschild & Sons Limited as Agent for the Finance Parties
    Transaktionen
    • 08. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Feb. 2007
    Geliefert am 08. März 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The mortgaged property being 40 & 41 furnival st, london t/no NGL617306. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abn Amro Trustees Limited, as Security Trustee for Each of the Finance Parties
    Transaktionen
    • 08. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture with floating charge
    Erstellt am 22. Feb. 2007
    Geliefert am 08. März 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first legal mortgage the mortgaged property, assignment any rental income, insurance policies, the hedge documents, fixed charges the real property, the property account, the gic account, book and other debts, goodwill and uncalled share capital, scottish property, scottish shares, jersey shares, floating charge all assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abn Amro Trustees Limited as Security Trustee for Each of the Finance Parties
    Transaktionen
    • 08. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 117. Mai 2012Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (LQ01)
      • Aktenzeichen 1
    Debenture
    Erstellt am 18. Okt. 2004
    Geliefert am 27. Okt. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrower or the company to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 27. Okt. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Okt. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 01. März 2002
    Geliefert am 18. März 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrowers or any of them to all or any of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The f/h land k/a 40 and 41 furnival street london EC4 t/n NGL617306 and by way of first fixed charge all estates or interests in any freehold or leasehold property, all plant and machinery and all moneys standing to the credit of any account all benefits in respect of all contracts and policies of insurance and all book and other debts the proceeds of the same, the goodwill, the benefit of all licences consents and authorisations, its uncalled capital, its rights under any appointment of a managing agent of the property, its rights under the agreement or agreements relating to the purchase of the property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Morgan Stanley Mortgage Servicing Limited
    Transaktionen
    • 18. März 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Nov. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat BANDAIR LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Kevin Peter Mersh
    20 Grosvenor Hill
    Berkeley Square
    W1K 3HQ London
    United Kingdom
    Receiver Manager
    20 Grosvenor Hill
    Berkeley Square
    W1K 3HQ London
    United Kingdom
    Julian Marshal Clarke
    20 Grosvenor Hill
    Berkeley Square
    W1K 3HQ London
    Receiver Manager
    20 Grosvenor Hill
    Berkeley Square
    W1K 3HQ London
    2
    DatumTyp
    20. Nov. 2012Beginn der Verwaltung
    04. Nov. 2013Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Shelley Bullman
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Praktiker
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Simon Robert Thomas
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Praktiker
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0