OPAL PORTFOLIO 1 LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | OPAL PORTFOLIO 1 LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04252566 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von OPAL PORTFOLIO 1 LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
Wo befindet sich OPAL PORTFOLIO 1 LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 2 St Peters Square M2 3EY Manchester |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von OPAL PORTFOLIO 1 LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| DUNWILCO (942) LIMITED | 16. Juli 2001 | 16. Juli 2001 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von OPAL PORTFOLIO 1 LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2012 |
Welche sind die letzten Einreichungen für OPAL PORTFOLIO 1 LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Hinweis auf den Abschlussbericht vor der Auflösung | 47 Seiten | WU15 | ||||||||||
Fortschrittsbericht bei einer Liquidation durch das Gericht | 47 Seiten | WU07 | ||||||||||
Fortschrittsbericht bei einer Liquidation durch das Gericht | 45 Seiten | WU07 | ||||||||||
Fortschrittsbericht bei einer Liquidation durch das Gericht | 44 Seiten | WU07 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Ernst & Young Llp 100 Barbirolli Square Manchester M2 3EY zum 2 st Peters Square Manchester M2 3EY am 10. Aug. 2017 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Insolvenzmeldung Insolvency:progress report brought down to 24/06/16 resignation of t a jack | 42 Seiten | LIQ MISC | ||||||||||
Insolvenzmeldung Insolvency:liquidators annual progress report to 24/02/2016 | 41 Seiten | LIQ MISC | ||||||||||
Gerichtsbeschluss zur Liquidation | 3 Seiten | COCOMP | ||||||||||
Insolvenzmeldung Insolvency:liquidator's annual progress report - compulsory liquidation - b/d date - 24/02/2015 | 42 Seiten | LIQ MISC | ||||||||||
Ernennung eines Liquidators | 1 Seiten | 4.31 | ||||||||||
Gerichtsbeschluss zur Liquidation | 3 Seiten | COCOMP | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 31. Jan. 2014 | 46 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Mitteilung über einen Gerichtsbeschluss zur Beendigung der Verwaltung | 54 Seiten | 2.33B | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 11. Sept. 2013 | 62 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge | 1 Seiten | F2.18 | ||||||||||
Vorschlag des Verwalters | 117 Seiten | 2.17B | ||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 2.14B | 5 Seiten | 2.16B | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * C/O Opal Property Group the Place Ducie Street Manchester M1 2TP* am 18. März 2013 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines Verwalters | 1 Seiten | 2.12B | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2012 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2011 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 16. Juli 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 16. Juli 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2010 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von OPAL PORTFOLIO 1 LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELLOR, Craig Allan | Sekretär | 21 Queenston Road Didsbury M20 2NX Manchester | British | 60906780002 | ||||||
| DUNCAN, Gavin Robert | Geschäftsführer | St Peters Square M2 3EY Manchester 2 | England | British | 151512820001 | |||||
| MELLOR, Craig Allan | Geschäftsführer | St Peters Square M2 3EY Manchester 2 | England | British | 60906780002 | |||||
| WALL, Stuart Barrie | Geschäftsführer | Old Acres Well Bank Lane Over Peover WA16 8UN Knutsford Cheshire | United Kingdom | British | 95010340001 | |||||
| D.W. COMPANY SERVICES LIMITED | Sekretär | 4th Floor, Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh | 613080003 | |||||||
| MARTIN, Graham Hunter | Geschäftsführer | Rosegarth 51 Adlington Road SK9 2BJ Wilmslow Cheshire | British | 87259480001 | ||||||
| D W DIRECTOR 2 LIMITED | Geschäftsführer | 4th Floor Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh | 73984150001 | |||||||
| D.W. DIRECTOR 1 LIMITED | Geschäftsführer | 4th Floor Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh Lothian | 83454900001 |
Hat OPAL PORTFOLIO 1 LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 23. Mai 2005 Geliefert am 28. Mai 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to the beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Opal hall 2A higher cambridge street chorlton upon medlock t/no LA22923, opal gardens anson road manchester t/nos la 81811, la 69837, LA87192, LA69836, gm 295335, la 42406 and gm 888423, lamvbert hall granby road and fairfield hall 6 fairfield road manchester t/no gm 611206 and la 258713. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage of shares | Erstellt am 07. Nov. 2002 Geliefert am 20. Nov. 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All liabilities due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The shares and related rights,share certificates and other documents in respect of the security assets and all assets and propertyt. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 08. Mai 2002 Geliefert am 24. Mai 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat OPAL PORTFOLIO 1 LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| In Verwaltung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
| Zwangsliquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0