BRENNTAG UK GROUP LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | BRENNTAG UK GROUP LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04253894 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BRENNTAG UK GROUP LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich BRENNTAG UK GROUP LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Alpha House Lawnswood Business Park, Redvers Close LS16 6QY Leeds England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von BRENNTAG UK GROUP LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ALBION GROUP LIMITED | 23. Juli 2001 | 23. Juli 2001 |
| WOODLAND 1 LIMITED | 17. Juli 2001 | 17. Juli 2001 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BRENNTAG UK GROUP LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2015 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BRENNTAG UK GROUP LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. März 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Albion House Rawdon Park Green Lane Yeadon Leeds West Yorkshire LS19 7XX zum Alpha House Lawnswood Business Park, Redvers Close Leeds LS16 6QY am 26. Okt. 2016 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 22. März 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 22. März 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Clare Marie Waters als Geschäftsführer am 31. März 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Russel Argo als Direktor am 31. März 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Clare Marie Waters als Geschäftsführer am 31. März 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 41 Seiten | MEM/ARTS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 4 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 22. März 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 09. Okt. 2013
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erfüllung der Belastung 8 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David O'connell als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von BRENNTAG UK GROUP LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRATTON, Martin | Sekretär | Lawnswood Business Park, Redvers Close LS16 6QY Leeds Alpha House England | British | 90371670001 | ||||||
| ARGO, Russel Ian | Geschäftsführer | Lawnswood Business Park, Redvers Close LS16 6QY Leeds Alpha House England | England | British | 196827670001 | |||||
| GRATTON, Martin | Geschäftsführer | Lawnswood Business Park, Redvers Close LS16 6QY Leeds Alpha House England | England | British | 90371670002 | |||||
| DAY, Mark | Sekretär | Welton Hill Kidd Lane HU15 1PH Welton Brough North Humberside | British | 124446000001 | ||||||
| MH SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Staples Court 11 Staple Inn Buildings WC1V 7QH London | 39754020001 | |||||||
| BATCHELOR, Nigel Maurice | Geschäftsführer | 3 The Green Wimbledon SW19 5AZ London | England | British | 62010280003 | |||||
| BLOMME, Carl Marcel | Geschäftsführer | Aardbezienstraat 2 Heule 8501 Belguim | Belgian | 113214990001 | ||||||
| BUCHSTEINER, Jurgen | Geschäftsführer | Albion House Rawdon Park Green Lane Yeadon LS19 7XX Leeds West Yorkshire | Germany | Germany | 114612200001 | |||||
| CORTAZZI, William Julian | Geschäftsführer | 38 Gloucester Square W2 2TD London | United Kingdom | British | 46234910004 | |||||
| DAY, Mark | Geschäftsführer | Welton Hill Kidd Lane HU15 1PH Welton Brough North Humberside | England | British | 124446000001 | |||||
| HOLLAND, Steven Edward | Geschäftsführer | Albion House Rawdon Park Green Lane Yeadon LS19 7XX Leeds West Yorkshire | England | British | 62261990002 | |||||
| LOCKWOOD, Ian | Geschäftsführer | 10 Wondesford Dale RG42 5TG Binfield Berkshire | England | British | 117640860001 | |||||
| MCLACHLAN, Neil Andrew | Geschäftsführer | Deise Langhurstwood Road RH12 4QD Horsham West Sussex | England | British | 78366690001 | |||||
| O'CONNELL, David Michael | Geschäftsführer | Albion House Rawdon Park Green Lane Yeadon LS19 7XX Leeds West Yorkshire | England | British | 124960420001 | |||||
| PATTYN, Marc Achiel Valeer | Geschäftsführer | Driepikkelstraaty 12 Ledegem 8880 Belgium | Belgian | 113475580001 | ||||||
| PITHOIS, Daniel Yves Andre | Geschäftsführer | 4 Allee De La Pommeraie, 91570 Bievres France | French | 114663980001 | ||||||
| SAVAGE, Peter James | Geschäftsführer | Woodlands Hurdle Way Compton Down SO21 2AN Winchester Hampshire | England | British | 46555490001 | |||||
| VAN BAARLEN, Arie Harry | Geschäftsführer | Wilhelminahoeve 16 Krimpen Aan Den Ussel 2924 Be Netherlands | Netherlands | Dutch | 114573830001 | |||||
| WATERS, Clare Marie | Geschäftsführer | Albion House Rawdon Park Green Lane Yeadon LS19 7XX Leeds West Yorkshire | England | British | 124960910001 | |||||
| WILLIAMS, Graham John | Geschäftsführer | Merstham Lodge Harps Oak Lane RH1 3AN Merstham Surrey | England | British | 5458110001 | |||||
| MH DIRECTORS LIMITED | Geschäftsführer | 12 Great James Street WC1N 3DR London | 40574860001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei BRENNTAG UK GROUP LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brenntag Uk Holding Limited | 06. Apr. 2016 | Lawnswood Business Park, Redvers Close LS16 6QY Leeds Alpha House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat BRENNTAG UK GROUP LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 20. Sept. 2006 Geliefert am 02. Okt. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge over deposit | Erstellt am 23. Juni 2006 Geliefert am 06. Juli 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed charge its entire right title and interest in and to the deposit and all rights and benefits accruing to or arising in connection with the deposit. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture | Erstellt am 29. Jan. 2003 Geliefert am 01. Feb. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben L/H property k/a land off leagrave road luton in the county of bedford having an area of 11,200 square metres or thereabouts. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture to a composite guarantee and debenture dated 28 july 2001 | Erstellt am 23. Jan. 2003 Geliefert am 06. Feb. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due by any group company to the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture | Erstellt am 06. Jan. 2003 Geliefert am 23. Jan. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All that l/h property k/a land and buildings comprising part of the old brick and tile works portishead bristol and all that piece of land formerly part of the dellacassa site adjoining the land. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture to a composite guarantee and debenture dated 28 july 2001 | Erstellt am 19. Dez. 2002 Geliefert am 07. Jan. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All indebtedness,liabilities and obligations due or to become due in any manner whatsoever by any group company to the security beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 28. Juli 2001 Geliefert am 13. Aug. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Akk monies due or to become due from the company (the "chargor") to the chargee under the subordinated security documents (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 28. Juli 2001 Geliefert am 09. Aug. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due by any group company to the security beneficiaries whether pursuant to the guarantee or otherwise, on any account whatsoever (all terms as defined) | |
Kurze Angaben F/H property k/a station road attleborough t/n NK130601, unit 3 nechells business centre dollman street birmingham WM538203 (for furthur property details please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0