WOODLAND 2 LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameWOODLAND 2 LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04253903
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von WOODLAND 2 LIMITED?

    • Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich WOODLAND 2 LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Albion House Rawdon Park
    Green Lane Yeadon
    LS19 7XX Leeds
    West Yorkshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WOODLAND 2 LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2012

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für WOODLAND 2 LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für WOODLAND 2 LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Ernennung von Mr Russel Argo als Direktor

    2 SeitenAP01

    Rücktritt des Auditors

    1 SeitenAUD

    Rücktritt des Auditors

    1 SeitenAUD

    Erfüllung der Belastung 8 vollständig

    1 SeitenMR04

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 04. Okt. 2013

    • Kapital: GBP 1
    4 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Beendigung der Bestellung von David O'connell als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Steven Holland als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Erfüllung der Belastung 9 vollständig

    1 SeitenMR04

    Jahresrückblick erstellt bis 17. Juli 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Änderung der Details des Sekretärs für Martin Gratton am 08. Aug. 2013

    1 SeitenCH03

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    14 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 17. Juli 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Martin Gratton am 01. Jan. 2012

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Ms Clare Marie Waters am 14. Aug. 2012

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Steven Edward Holland am 14. Aug. 2012

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für David Michael O'connell am 14. Aug. 2012

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    13 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Martin Gratton am 01. Jan. 2012

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Martin Gratton am 01. Jan. 2012

    2 SeitenCH03

    Wer sind die Geschäftsführer von WOODLAND 2 LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GRATTON, Martin
    Albion House Rawdon Park
    Green Lane Yeadon
    LS19 7XX Leeds
    West Yorkshire
    Sekretär
    Albion House Rawdon Park
    Green Lane Yeadon
    LS19 7XX Leeds
    West Yorkshire
    British90371670001
    ARGO, Russel
    Albion House Rawdon Park
    Green Lane Yeadon
    LS19 7XX Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Albion House Rawdon Park
    Green Lane Yeadon
    LS19 7XX Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish184053260001
    GRATTON, Martin
    Albion House Rawdon Park
    Green Lane Yeadon
    LS19 7XX Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Albion House Rawdon Park
    Green Lane Yeadon
    LS19 7XX Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish90371670002
    WATERS, Clare Marie
    Albion House Rawdon Park
    Green Lane Yeadon
    LS19 7XX Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Albion House Rawdon Park
    Green Lane Yeadon
    LS19 7XX Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish124960910001
    BATCHELOR, Nigel Maurice
    3 The Green
    Wimbledon
    SW19 5AZ London
    Sekretär
    3 The Green
    Wimbledon
    SW19 5AZ London
    British62010280003
    DAY, Mark
    Welton Hill
    Kidd Lane
    HU15 1PH Welton Brough
    North Humberside
    Sekretär
    Welton Hill
    Kidd Lane
    HU15 1PH Welton Brough
    North Humberside
    British124446000001
    MH SECRETARIES LIMITED
    Staples Court
    11 Staple Inn Buildings
    WC1V 7QH London
    Sekretär
    Staples Court
    11 Staple Inn Buildings
    WC1V 7QH London
    39754020001
    BATCHELOR, Nigel Maurice
    3 The Green
    Wimbledon
    SW19 5AZ London
    Geschäftsführer
    3 The Green
    Wimbledon
    SW19 5AZ London
    EnglandBritish62010280003
    BLOMME, Carl Marcel
    Aardbezienstraat 2
    Heule
    8501
    Belguim
    Geschäftsführer
    Aardbezienstraat 2
    Heule
    8501
    Belguim
    Belgian113214990001
    CORTAZZI, William Julian
    38 Gloucester Square
    W2 2TD London
    Geschäftsführer
    38 Gloucester Square
    W2 2TD London
    United KingdomBritish46234910004
    DAY, Mark
    Welton Hill
    Kidd Lane
    HU15 1PH Welton Brough
    North Humberside
    Geschäftsführer
    Welton Hill
    Kidd Lane
    HU15 1PH Welton Brough
    North Humberside
    EnglandBritish124446000001
    HOLLAND, Steven Edward
    Albion House Rawdon Park
    Green Lane Yeadon
    LS19 7XX Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Albion House Rawdon Park
    Green Lane Yeadon
    LS19 7XX Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish62261990002
    O'CONNELL, David Michael
    Albion House Rawdon Park
    Green Lane Yeadon
    LS19 7XX Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Albion House Rawdon Park
    Green Lane Yeadon
    LS19 7XX Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish124960420001
    PATTYN, Marc Achiel Valeer
    Driepikkelstraaty 12
    Ledegem
    8880
    Belgium
    Geschäftsführer
    Driepikkelstraaty 12
    Ledegem
    8880
    Belgium
    Belgian113475580001
    SAVAGE, Peter James
    Woodlands Hurdle Way
    Compton Down
    SO21 2AN Winchester
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Woodlands Hurdle Way
    Compton Down
    SO21 2AN Winchester
    Hampshire
    EnglandBritish46555490001
    VAN BAARLEN, Arie Harry
    Wilhelminahoeve 16
    Krimpen Aan Den Ussel
    2924 Be
    Netherlands
    Geschäftsführer
    Wilhelminahoeve 16
    Krimpen Aan Den Ussel
    2924 Be
    Netherlands
    NetherlandsDutch114573830001
    MH DIRECTORS LIMITED
    12 Great James Street
    WC1N 3DR London
    Geschäftsführer
    12 Great James Street
    WC1N 3DR London
    40574860001

    Hat WOODLAND 2 LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 20. Sept. 2006
    Geliefert am 02. Okt. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag,London Branch
    Transaktionen
    • 02. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Aug. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Share charge
    Erstellt am 20. Sept. 2006
    Geliefert am 02. Okt. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All of its rights,title,benefit and interest whatsoever,present and future,to or in respect of the charge portfolio. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag,London Branch
    Transaktionen
    • 02. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Okt. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 29. Jan. 2003
    Geliefert am 01. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H property k/a land off leagrave road luton in the county of bedford having an area of 11,200 square metres or thereabouts.
    Berechtigte Personen
    • Hays Holdings Limited
    Transaktionen
    • 01. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Juli 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture to a composite guarantee and debenture dated 28 july 2001
    Erstellt am 23. Jan. 2003
    Geliefert am 06. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due by any group company to the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Trustee for the Securitybeneficiaries) (the Security Trustee)
    Transaktionen
    • 06. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Juli 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 06. Jan. 2003
    Geliefert am 23. Jan. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All that l/h property k/a land and buildings comprising part of the old brick and tile works portishead bristol and all that piece of land formerly part of the dellacassa site adjoining the land. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hays Holdings Limited
    Transaktionen
    • 23. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Juli 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture to a composite guarantee and debenture dated 28 july 2001
    Erstellt am 19. Dez. 2002
    Geliefert am 07. Jan. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All indebtedness,liabilities and obligations due or to become due in any manner whatsoever by any group company to the security beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland,London as Security Trustee for the Securitybeneficiaries
    Transaktionen
    • 07. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Juli 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment of keyman life policies
    Erstellt am 15. Jan. 2002
    Geliefert am 18. Jan. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The policy, all sums assured by it and all bonuses and benefits which may arise under it and the assignors whole right title and interest in the policy numbers I160804 and I160805.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 18. Jan. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Juli 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 28. Juli 2001
    Geliefert am 13. Aug. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Akk monies due or to become due from the company (the "chargor") to the chargee under the subordinated security documents (as defined)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hays Holdings Limited
    Transaktionen
    • 13. Aug. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Juli 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 28. Juli 2001
    Geliefert am 09. Aug. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due by any group company to the security beneficiaries whether pursuant to the guarantee or otherwise, on any account whatsoever (all terms as defined)
    Kurze Angaben
    F/H property k/a station road attleborough t/n NK130601, unit 3 nechells business centre dollman street birmingham WM538203 (for furthur property details please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Trustee for the Security Beneficiaries) (the Security Trustee)
    Transaktionen
    • 09. Aug. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Juli 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0