ARKEX LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameARKEX LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04255000
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ARKEX LIMITED?

    • Andere Forschung und experimentelle Entwicklung in Naturwissenschaften und Ingenieurwesen (72190) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
    • Andere berufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten n.a. (74909) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich ARKEX LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o ERNST & YOUNG LLP
    No 1 Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    West Midlands
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ARKEX LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2013

    Welche sind die letzten Einreichungen für ARKEX LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung

    18 SeitenAM23

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    14 SeitenAM10

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    14 SeitenAM10

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    4 SeitenAM19

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    12 SeitenAM10

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    4 SeitenAM19

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    12 SeitenAM10

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    13 SeitenAM10

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    4 SeitenAM19

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    15 SeitenAM10

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 22. März 2016

    11 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Ernennung eines Ersatz- oder zusätzlichen Verwalters

    3 SeitenAM11

    Mitteilung über den Beschluss zur Abberufung des Administrators vom Amt

    19 SeitenAM16

    Mitteilung über die Ernennung eines Ersatz- oder zusätzlichen Verwalters

    3 SeitenAM11

    Mitteilung über die Ernennung eines Ersatz- oder zusätzlichen Verwalters

    3 SeitenAM11

    Mitteilung über den Beschluss zur Abberufung des Administrators vom Amt

    11 SeitenAM16

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 22. Feb. 2017

    14 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 22. Aug. 2016

    13 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Erfüllung der Belastung 18 vollständig

    4 SeitenMR04

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    1 SeitenF2.18

    Beendigung der Bestellung von Jerome Halbout als Geschäftsführer am 25. Sept. 2015

    2 SeitenTM01

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    12 Seiten2.16B

    Vorschlag des Verwalters

    37 Seiten2.17B

    Wer sind die Geschäftsführer von ARKEX LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    WHITE, James Courtney
    c/o Ernst & Young Llp
    Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    No 1
    West Midlands
    Geschäftsführer
    c/o Ernst & Young Llp
    Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    No 1
    West Midlands
    United StatesAmericanPresident185967560001
    BASTOW, Ian
    2 Barnsfield
    Fulbourn
    CB21 5DD Cambridge
    Cambridgeshire
    Sekretär
    2 Barnsfield
    Fulbourn
    CB21 5DD Cambridge
    Cambridgeshire
    BritishFinance Director124827450001
    GIBSON, Stuart James
    White House
    Bartlow Road Hadstock
    CB21 4PF Cambridge
    Sekretär
    White House
    Bartlow Road Hadstock
    CB21 4PF Cambridge
    British65989170003
    HALL, Katherine Jessie
    124 West Hill
    Aspley Guise
    MK17 8DX Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Sekretär
    124 West Hill
    Aspley Guise
    MK17 8DX Milton Keynes
    Buckinghamshire
    BritishGeophysicist95421540001
    BART SECRETARIES LIMITED
    C/O Laytons
    Carmelite 50 Victoria Embankment Bla
    EC4Y 0LS London
    Sekretär
    C/O Laytons
    Carmelite 50 Victoria Embankment Bla
    EC4Y 0LS London
    41956110002
    BASTOW, Ian
    2 Barnsfield
    Fulbourn
    CB21 5DD Cambridge
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    2 Barnsfield
    Fulbourn
    CB21 5DD Cambridge
    Cambridgeshire
    EnglandBritishFinance Director124827450001
    CURL, Stephen John, Dr
    c/o Ernst & Young Llp
    Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    No 1
    West Midlands
    Geschäftsführer
    c/o Ernst & Young Llp
    Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    No 1
    West Midlands
    United KingdomBritishCompany Chairman103734010001
    GIBSON, Stuart James
    c/o Ernst & Young Llp
    Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    No 1
    West Midlands
    Geschäftsführer
    c/o Ernst & Young Llp
    Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    No 1
    West Midlands
    EnglandBritishChief Financial Officer65989170003
    GLEISSNER, Ulrich Christof, Doctor
    Josef-Schwarz-Weg 14c
    Muenchen
    81479
    Geschäftsführer
    Josef-Schwarz-Weg 14c
    Muenchen
    81479
    GermanInvestment Banker97229460001
    HALBOUT, Jerome
    c/o Ernst & Young Llp
    Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    No 1
    West Midlands
    Geschäftsführer
    c/o Ernst & Young Llp
    Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    No 1
    West Midlands
    FranceFrenchInvestor99362600001
    HALL, Katherine Jessie
    124 West Hill
    Aspley Guise
    MK17 8DX Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    124 West Hill
    Aspley Guise
    MK17 8DX Milton Keynes
    Buckinghamshire
    EnglandBritishGeophysicist95421540001
    HARRIDINE, Paul
    28 Dorsington Close
    Hatton Park
    CV35 7TH Warwick
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    28 Dorsington Close
    Hatton Park
    CV35 7TH Warwick
    Warwickshire
    BritishDirector97227240001
    HELLEBUST, Helge
    c/o Ernst & Young Llp
    Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    No 1
    West Midlands
    Geschäftsführer
    c/o Ernst & Young Llp
    Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    No 1
    West Midlands
    NorwayNorwegianCompany Director194393980001
    HELLEBUST, Helge
    Hoffsjef Loevenskiolds Vei 58c
    Oslo
    N-0382
    Norway
    Geschäftsführer
    Hoffsjef Loevenskiolds Vei 58c
    Oslo
    N-0382
    Norway
    NorwayNorwegianDirector131825480001
    HERRERA, Gregory John
    Albert Street
    AB25 1XX Aberdeen
    15
    Scotland
    Geschäftsführer
    Albert Street
    AB25 1XX Aberdeen
    15
    Scotland
    United KingdomTrinidadianDirector26304570002
    HUMM, Roger James
    Dinghurst Road
    Churchill
    BS25 5PJ Winscombe
    Westfield Orchard
    Avon
    Geschäftsführer
    Dinghurst Road
    Churchill
    BS25 5PJ Winscombe
    Westfield Orchard
    Avon
    EnglandBritishAccountant29914990003
    JONES, Gary Ernest
    Apartment 13 Theatre View
    19 Short Street
    SE1 8LJ London
    Geschäftsführer
    Apartment 13 Theatre View
    19 Short Street
    SE1 8LJ London
    United KingdomAmericanConsultant101527540002
    LUMLEY, John
    13a Madingley Road
    CB3 0EG Cambridge
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    13a Madingley Road
    CB3 0EG Cambridge
    Cambridgeshire
    AustralianPhysicist38924710001
    MCGRANDLE, Andrew
    Coppins Barn
    West Farm Way Emberton
    MK46 5QP Olney
    Bucks
    Geschäftsführer
    Coppins Barn
    West Farm Way Emberton
    MK46 5QP Olney
    Bucks
    EnglandBritishNon Exec Director25484160001
    SIEGFRIED III, John
    Cambridge Business Park
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    Cambridge Business Park
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    Cambridgeshire
    United KingdomUsaChief Executive Officer155073470001
    SKARE, Leif Andre
    Regimentveien 93b
    4045 Hafrsfjord
    Norway
    Geschäftsführer
    Regimentveien 93b
    4045 Hafrsfjord
    Norway
    NorwegianInvestment Manager110006000001
    SLEDZIK, James Peter
    Crystal Pt
    Missouri City
    6427
    Texas 77459
    Usa
    Geschäftsführer
    Crystal Pt
    Missouri City
    6427
    Texas 77459
    Usa
    UsaAmericanDirector135477590001
    SNEDDON, David John
    1 Clarendon Mews
    EH49 6QR Linlithgow
    West Lothian
    Geschäftsführer
    1 Clarendon Mews
    EH49 6QR Linlithgow
    West Lothian
    ScotlandBritishDirector67640890002
    STABBINS, Richard, Dr
    12 Brookfield
    5 Highgate West Hill
    N6 6AS London
    Geschäftsführer
    12 Brookfield
    5 Highgate West Hill
    N6 6AS London
    EnglandBritishGeologist49459830001
    WOOD, Nicholas, Mr.
    The White House
    Odell Road, Sharnbrook
    MK44 1JL Bedford
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    The White House
    Odell Road, Sharnbrook
    MK44 1JL Bedford
    Bedfordshire
    EnglandBritishBusiness Consultant70235850001
    BART MANAGEMENT LIMITED
    C/O Laytons
    Carmelite 50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0LS London
    Geschäftsführer
    C/O Laytons
    Carmelite 50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0LS London
    44093380002

    Hat ARKEX LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 22. Dez. 2014
    Geliefert am 24. Dez. 2014
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    The borrower charged to the lender 1) by way of first legal mortgage all freehold, leasehold or other immovable property now vested or charged to the borrower, and 2) by way of first fixed charge a) all other freehold, leasehold or other immovable property now or in the future belonging to the borrower and b) all the borrower's intellectual property (as defined in the instrument). For more details please refer to the instrument.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Kreos Capital Iv (UK) Limited
    Transaktionen
    • 24. Dez. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 19. Aug. 2014
    Geliefert am 26. Aug. 2014
    Vollständig erfüllt
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • 4D Global Energy Investments PLC
    Transaktionen
    • 26. Aug. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 01. Okt. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Chattels mortgage
    Erstellt am 23. Nov. 2012
    Geliefert am 28. Nov. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Full tensor gravity gradiometer system (FTG3).
    Berechtigte Personen
    • Aurora Leasing LTD
    Transaktionen
    • 28. Nov. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 04. Aug. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 20. Okt. 2010
    Geliefert am 02. Nov. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Kreos Capital Iii (UK) Limited
    Transaktionen
    • 02. Nov. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 27. Juni 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Chattels mortgage
    Erstellt am 07. Juni 2010
    Geliefert am 22. Juni 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Full tensor gravity gradiometer system (FTG2) to be supplied by lockheed martin.
    Berechtigte Personen
    • Aurora Leasing Limited
    Transaktionen
    • 22. Juni 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 04. Dez. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge of deposit
    Erstellt am 29. Apr. 2010
    Geliefert am 07. Mai 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The deposit initially of us $343,000CREDITED to account designation rbsalkb-usd-a with the bank and any addition to that deposit and any deposit or account from time to time of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 07. Mai 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Erstellt am 21. Sept. 2009
    Geliefert am 30. Sept. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All such rights to the repayment of the deposit meaning the debt(s) on the account(s) described in the schedule being the account with the bank denominated in us dollar designated ltsb re: arkex limited and numbered 11640143 and any account(s) for the time being replacing the same and all interest owing in respect thereof and all deposits with the banks treasury division in the name of the bank re the company.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Sept. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Dez. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 02. Feb. 2009
    Geliefert am 04. Feb. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The amount from time to time standing to the credit of the tenant in the interest bearing deposit account see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Crown Estate Commissioners
    Transaktionen
    • 04. Feb. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 09. Jan. 2008
    Geliefert am 15. Jan. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Kreos Capital Iii (UK) Limited
    Transaktionen
    • 15. Jan. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Juni 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 11. Juni 2007
    Geliefert am 20. Juni 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All property present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixed plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Kreos Capital Iii (UK) Limited
    Transaktionen
    • 20. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Juni 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 17. Aug. 2004
    Geliefert am 21. Aug. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £20,213.68 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The deposit account containing the sum of £20,213.68. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Crown Estate Commissioners
    Transaktionen
    • 21. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 12. März 2004
    Geliefert am 25. März 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Oxford Instruments PLC
    Transaktionen
    • 25. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Juni 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 12. März 2004
    Geliefert am 24. März 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Sep Ii
    Transaktionen
    • 24. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Juni 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 12. März 2004
    Geliefert am 24. März 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Sir Martin Francis Wood
    Transaktionen
    • 24. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Juni 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 12. März 2004
    Geliefert am 24. März 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Sep Ii B
    Transaktionen
    • 24. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Juni 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 12. März 2004
    Geliefert am 24. März 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Rwe Venture Capital Fonds Gmbh
    Transaktionen
    • 24. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Juni 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 12. März 2004
    Geliefert am 24. März 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nova Technology Fund
    Transaktionen
    • 24. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Juni 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 12. März 2004
    Geliefert am 24. März 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Eurovestech PLC
    Transaktionen
    • 24. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Juni 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 12. März 2004
    Geliefert am 24. März 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lady Kathleen Audrey Wood
    Transaktionen
    • 24. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Juni 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Hat ARKEX LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    23. Sept. 2015Beginn der Verwaltung
    22. Sept. 2020Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Craig Anthony Lewis
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praktiker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Angela Swarbrick
    1 Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    Praktiker
    1 Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    Tomislav Lukic
    Ernst & Young
    1 Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    Praktiker
    Ernst & Young
    1 Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    Colin Peter Dempster
    Ten George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    Praktiker
    Ten George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    Samuel James Woodward
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Praktiker
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0